LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC

LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 02258411
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?

    • (7415) /

    Wo befindet sich LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TEATHER & GREENWOOD HOLDINGS PLC03. Juni 199903. Juni 1999
    NRP PLC11. Feb. 199711. Feb. 1997
    NATIONWIDE RESIDENTIAL PROPERTIES PLC11. Sept. 199611. Sept. 1996
    NORTHUMBRIAN RESIDENTIAL PROPERTIES PLC01. Sept. 198801. Sept. 1988
    GILTPRICE PUBLIC LIMITED COMPANY16. Mai 198816. Mai 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    9 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Apr. 2018

    9 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Apr. 2017

    11 SeitenLIQ03

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB zum 15 Canada Square London E14 5GL am 28. Sept. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    2 SeitenAC92

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Apr. 2012

    4 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Apr. 2011

    6 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Old Change House 128 Queen Victoria Street London EC4V 4BJ* am 20. Mai 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VALTYSSON, Balvin
    South Parade
    WY 5LH Ealing
    54
    London
    Sekretär
    South Parade
    WY 5LH Ealing
    54
    London
    Icelandic140600340001
    HAFSTEINSSON, Arsaell
    Fjardarsel 5
    Reykjavik
    109
    Iceland
    Geschäftsführer
    Fjardarsel 5
    Reykjavik
    109
    Iceland
    Icelandic137091830001
    VALTYSSON, Balvin
    South Parade
    WY 5LH Ealing
    54
    London
    Geschäftsführer
    South Parade
    WY 5LH Ealing
    54
    London
    Icelandic140600340001
    DEVLIN, Hugh Gerard
    Locksfield
    Ashes Lane
    TN11 0AN Hadlow
    Kent
    Sekretär
    Locksfield
    Ashes Lane
    TN11 0AN Hadlow
    Kent
    British49516630002
    PARKER, Hilary Anne
    3 North Jesmond Avenue
    Jesmond
    NE2 3JX Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    3 North Jesmond Avenue
    Jesmond
    NE2 3JX Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British5986850001
    STOCKS, Timothy Edward
    6 Camlet Way
    AL3 4TL St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    6 Camlet Way
    AL3 4TL St Albans
    Hertfordshire
    British43135190001
    WEIR, Bruce Allan
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    Sekretär
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    British95838730006
    ARNASON, Sigurjon Thorvaldur
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    Geschäftsführer
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    Icelandic104840900003
    ASHFIELD, Philip John Christopher
    South End House
    Ockham
    GU23 6PF Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    South End House
    Ockham
    GU23 6PF Woking
    Surrey
    United KingdomBritish47364730001
    BAKER, Kenneth Wilfred, The Rt Hon Lord
    Teather & Greenwood Ltd
    Beaufort House 15 St Botolph Street
    EC3A 7QR London
    Geschäftsführer
    Teather & Greenwood Ltd
    Beaufort House 15 St Botolph Street
    EC3A 7QR London
    British77976620003
    BARBER, Alan John
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Geschäftsführer
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritish101849290001
    BOOTHMAN, Derek Arnold
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    British5733500001
    CORNISH, Roland David
    38 Speldhurst Road
    Chiswick
    W4 1BU London
    Geschäftsführer
    38 Speldhurst Road
    Chiswick
    W4 1BU London
    British22086910003
    DELMAR MORGAN, Jeremy Hugh
    Mulberry Cottage 5 Western Terrace
    W6 9TX London
    Geschäftsführer
    Mulberry Cottage 5 Western Terrace
    W6 9TX London
    United KingdomBritish58211990001
    DERVILLE, Peter Robin Teichman
    24 River Reach
    TW11 9QL Teddington
    Middlesex
    Geschäftsführer
    24 River Reach
    TW11 9QL Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish24263450001
    FORD, Eric Kenelm
    15 Tenison Avenue
    CB1 2DX Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    15 Tenison Avenue
    CB1 2DX Cambridge
    Cambridgeshire
    British125022680001
    GARSTON, Clive Richard
    Sandy Ridge
    Bollinway Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Sandy Ridge
    Bollinway Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish12179600001
    GRICE, Peter Richard
    68 Lockesfield Place
    Isle Of Dogs
    E14 3AJ London
    Geschäftsführer
    68 Lockesfield Place
    Isle Of Dogs
    E14 3AJ London
    British34827780003
    KRISTJANSSON, Halldor Jon
    15 St. Botolph Street
    EC3A 7QR London
    Geschäftsführer
    15 St. Botolph Street
    EC3A 7QR London
    Icelandic72483590002
    MORGAN, Eric
    96 Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HH Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    96 Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HH Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish14152110001
    REEVE, John Frederick
    Copse Close
    Cedar Road Hook Heath
    GU22 0JJ Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Copse Close
    Cedar Road Hook Heath
    GU22 0JJ Woking
    Surrey
    British33562950001
    ROWBOTHAM, Brian
    The Cygnets Wantage Road
    RG8 9LB Streatley On Thames
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Cygnets Wantage Road
    RG8 9LB Streatley On Thames
    Berkshire
    British58304600003
    SCOTT, George
    5 Beechfield Road
    Gosforth
    NE3 4DR Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    5 Beechfield Road
    Gosforth
    NE3 4DR Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish39196280004
    STAGG, Nicholas Simon
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    Geschäftsführer
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    British75782650004

    Hat LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Letter of pledge over shares
    Erstellt am 30. Apr. 1998
    Geliefert am 15. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    800,000 a ordinary shares of £1 each and 200,000 b ordinary of £1 each in teather & greenwood limited plus all bonuses dividends and interest due therein.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over shares
    Erstellt am 08. März 1996
    Geliefert am 13. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    996146 ordinary 10P shares of county of kent developments PLC plus all dividends and interest payable on any of the shares and all stocks shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. März 1994
    Geliefert am 11. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First legal charge over: 18 the riding,kenton,newcastle upon tyne and 17 other properties as listed on the schedule. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    23 castledene court, freeman road, newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    47, ashleigh grove, high west jesmond newcastle upon tyne tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 gowanburn, fatfield, washington, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    25C osborne avenue pavilion mews, jesmond, newcastle upon tyne tyne and wear togegher with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    10 orchard place baston terrace, jesmond newcastle upon tyne,tyne and wear together with all buildings and fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    71 deneside court selbourne gardens jesmond newcastle upont tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    16 orchard place, buston terrace jesmond newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    6 orchard place buston terrace, jesmond newcastle upon tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    74 broadash grey stoke gardens sandyford newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    21 castledene court, freeman road, newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    18 the riding kenton newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 orchard place, buston terrace jesmond newcastle upon tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    33 victoria mews claremont road newcastle-upon-tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    25B osborne avenue pavilion mews jesmond newcastle upon tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 15. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1990
    Geliefert am 06. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    29 deneside court selbourne gardens, jesmond newcastle-upon-tyne tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Okt. 2018Aufgelöst am
    23. Apr. 2010Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0