LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC
Überblick
| Unternehmensname | LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Unternehmensnummer | 02258411 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?
- (7415) /
Wo befindet sich LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TEATHER & GREENWOOD HOLDINGS PLC | 03. Juni 1999 | 03. Juni 1999 |
| NRP PLC | 11. Feb. 1997 | 11. Feb. 1997 |
| NATIONWIDE RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | 11. Sept. 1996 | 11. Sept. 1996 |
| NORTHUMBRIAN RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | 01. Sept. 1988 | 01. Sept. 1988 |
| GILTPRICE PUBLIC LIMITED COMPANY | 16. Mai 1988 | 16. Mai 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 9 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Apr. 2018 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Apr. 2017 | 11 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:secretary of state's release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB zum 15 Canada Square London E14 5GL am 28. Sept. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 2 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Apr. 2012 | 4 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Apr. 2011 | 6 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Old Change House 128 Queen Victoria Street London EC4V 4BJ* am 20. Mai 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALTYSSON, Balvin | Sekretär | South Parade WY 5LH Ealing 54 London | Icelandic | 140600340001 | ||||||
| HAFSTEINSSON, Arsaell | Geschäftsführer | Fjardarsel 5 Reykjavik 109 Iceland | Icelandic | 137091830001 | ||||||
| VALTYSSON, Balvin | Geschäftsführer | South Parade WY 5LH Ealing 54 London | Icelandic | 140600340001 | ||||||
| DEVLIN, Hugh Gerard | Sekretär | Locksfield Ashes Lane TN11 0AN Hadlow Kent | British | 49516630002 | ||||||
| PARKER, Hilary Anne | Sekretär | 3 North Jesmond Avenue Jesmond NE2 3JX Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 5986850001 | ||||||
| STOCKS, Timothy Edward | Sekretär | 6 Camlet Way AL3 4TL St Albans Hertfordshire | British | 43135190001 | ||||||
| WEIR, Bruce Allan | Sekretär | Bow Bells House 1 Bread Street EC4M 9BF London | British | 95838730006 | ||||||
| ARNASON, Sigurjon Thorvaldur | Geschäftsführer | Bow Bells House 1 Bread Street EC4M 9BF London | Icelandic | 104840900003 | ||||||
| ASHFIELD, Philip John Christopher | Geschäftsführer | South End House Ockham GU23 6PF Woking Surrey | United Kingdom | British | 47364730001 | |||||
| BAKER, Kenneth Wilfred, The Rt Hon Lord | Geschäftsführer | Teather & Greenwood Ltd Beaufort House 15 St Botolph Street EC3A 7QR London | British | 77976620003 | ||||||
| BARBER, Alan John | Geschäftsführer | Salisbury Square EC4Y 8BB London 8 | United Kingdom | British | 101849290001 | |||||
| BOOTHMAN, Derek Arnold | Gesch äftsführer | Ashworth Dene Wilmslow Road Mottram St Andrew SK10 4QH Macclesfield Cheshire | British | 5733500001 | ||||||
| CORNISH, Roland David | Geschäftsführer | 38 Speldhurst Road Chiswick W4 1BU London | British | 22086910003 | ||||||
| DELMAR MORGAN, Jeremy Hugh | Geschäftsführer | Mulberry Cottage 5 Western Terrace W6 9TX London | United Kingdom | British | 58211990001 | |||||
| DERVILLE, Peter Robin Teichman | Geschäftsführer | 24 River Reach TW11 9QL Teddington Middlesex | England | British | 24263450001 | |||||
| FORD, Eric Kenelm | Geschäftsführer | 15 Tenison Avenue CB1 2DX Cambridge Cambridgeshire | British | 125022680001 | ||||||
| GARSTON, Clive Richard | Geschäftsführer | Sandy Ridge Bollinway Hale WA15 0NZ Altrincham Cheshire | England | British | 12179600001 | |||||
| GRICE, Peter Richard | Geschäftsführer | 68 Lockesfield Place Isle Of Dogs E14 3AJ London | British | 34827780003 | ||||||
| KRISTJANSSON, Halldor Jon | Geschäftsführer | 15 St. Botolph Street EC3A 7QR London | Icelandic | 72483590002 | ||||||
| MORGAN, Eric | Geschäftsführer | 96 Runnymede Road Ponteland NE20 9HH Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 14152110001 | |||||
| REEVE, John Frederick | Geschäftsführer | Copse Close Cedar Road Hook Heath GU22 0JJ Woking Surrey | British | 33562950001 | ||||||
| ROWBOTHAM, Brian | Geschäftsführer | The Cygnets Wantage Road RG8 9LB Streatley On Thames Berkshire | British | 58304600003 | ||||||
| SCOTT, George | Geschäftsführer | 5 Beechfield Road Gosforth NE3 4DR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 39196280004 | |||||
| STAGG, Nicholas Simon | Geschäftsführer | Bow Bells House 1 Bread Street EC4M 9BF London | British | 75782650004 |
Hat LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Letter of pledge over shares | Erstellt am 30. Apr. 1998 Geliefert am 15. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 800,000 a ordinary shares of £1 each and 200,000 b ordinary of £1 each in teather & greenwood limited plus all bonuses dividends and interest due therein. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 08. März 1996 Geliefert am 13. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 996146 ordinary 10P shares of county of kent developments PLC plus all dividends and interest payable on any of the shares and all stocks shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. März 1994 Geliefert am 11. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First legal charge over: 18 the riding,kenton,newcastle upon tyne and 17 other properties as listed on the schedule. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 23 castledene court, freeman road, newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 47, ashleigh grove, high west jesmond newcastle upon tyne tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2 gowanburn, fatfield, washington, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 25C osborne avenue pavilion mews, jesmond, newcastle upon tyne tyne and wear togegher with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 10 orchard place baston terrace, jesmond newcastle upon tyne,tyne and wear together with all buildings and fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 71 deneside court selbourne gardens jesmond newcastle upont tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 16 orchard place, buston terrace jesmond newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 6 orchard place buston terrace, jesmond newcastle upon tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 74 broadash grey stoke gardens sandyford newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 21 castledene court, freeman road, newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 18 the riding kenton newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2 orchard place, buston terrace jesmond newcastle upon tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 33 victoria mews claremont road newcastle-upon-tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 25B osborne avenue pavilion mews jesmond newcastle upon tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 06. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 29 deneside court selbourne gardens, jesmond newcastle-upon-tyne tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0