PEOPLES PHONE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PEOPLES PHONE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02262870 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PEOPLES PHONE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich PEOPLES PHONE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PEOPLES PHONE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
THE PEOPLES PHONE COMPANY PLC | 28. Feb. 1994 | 28. Feb. 1994 |
CELLULAR COMMUNICATIONS CORPORATION PLC | 27. Mai 1988 | 27. Mai 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PEOPLES PHONE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PEOPLES PHONE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 19 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 16 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 15 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 17 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 14 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. März 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PEOPLES PHONE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
EVANS, David Nigel | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Director | 134975040001 | ||||||||
MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 173703620001 | ||||||||
DAWE-LANE, Patrick John Beachim | Sekretär | Marsh Lane Rowde SN10 1RE Devizes Upper Foxhangers Farm Wiltshire England | Other | 130771170001 | ||||||||||
EMETULU, Lola | Sekretär | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 88619360002 | ||||||||||
HOWIE, Philip Robert Sutherland | Sekretär | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 77939460004 | ||||||||||
PARRISH, Keith John | Sekretär | 33 Reads Field Four Marks GU34 5XA Alton Hampshire | British | 65075990001 | ||||||||||
SCOTT, Stephen Roy | Sekretär | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | Company Secretary | 25660590003 | |||||||||
ALLEN, Christian Philip Quentin | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Director | 123612980001 | |||||||||
BAMFORD, Peter Richard | Geschäftsführer | Lantern House 4a Queens Gate Place SW7 5NT London | British | Director | 54076100002 | |||||||||
BEST, Pauline Ann | Geschäftsführer | Honeysuckle Cottage Sutton Lane Sutton OX29 5RU Witney Oxfordshire | British | Human Resources Director | 68015830001 | |||||||||
BISWAS, Sumit Kumar | Geschäftsführer | 21 South Street OX2 0BE Oxford Oxfordshire | British | Director | 63870460001 | |||||||||
BREWER, Stephen | Geschäftsführer | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | Company Director | 79186090002 | |||||||||
BROCKLEHURST, Nigel | Geschäftsführer | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | Director | 83126790001 | |||||||||
CHESWORTH, Paul | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Director | 99525280001 | |||||||||
EDWARDS, Peter David | Geschäftsführer | Hockets Oriental Road SL5 7AZ Sunninghill Berkshire | British | Director | 1908570001 | |||||||||
EVANS, Mark | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | Chief Financial Officer | 127017870001 | |||||||||
FINCH, Joanne Sarah | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Senior Finance Manager | 158146620001 | ||||||||
FREEMAN, William Ian Bede | Geschäftsführer | Herons Cottage Ferry Lane, Medmenham SL7 2EZ Marlow Buckinghamshire | England | British | Director | 64442870001 | ||||||||
GARDNER, Malcolm William | Geschäftsführer | Dryson House Edge Business Centre Humber Road NW2 6EW London | British | Company Director | 48770690002 | |||||||||
GENT, Christopher Charles | Geschäftsführer | Crowshott Highclere RG20 9RY Newbury Berkshire | British | Company Director | 50867930001 | |||||||||
GIBBINS, Michael Edward Stanley | Geschäftsführer | 36 Hurlingham Square Peterborough Road SW6 3DZ London | British | Director | 39579200001 | |||||||||
GRAY, Ian | Geschäftsführer | 61 Bathurst Mews W2 2SB London | United Kingdom | British | Director | 50246030004 | ||||||||
HALFORD, Andrew Nigel | Geschäftsführer | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | Director | 33951180005 | |||||||||
HANFORD, Raymond Clifford | Geschäftsführer | Romney Cottage Park Horsley East Horsley KT24 5RZ Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 45868080001 | ||||||||
HANFORD, Raymond Clifford | Geschäftsführer | Romney Cottage Park Horsley East Horsley KT24 5RZ Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 45868080001 | ||||||||
HEXT, Jane Helen | Geschäftsführer | 2 Saint Katherines Winterbourne Bassett SN4 9QG Swindon Wiltshire | England | British | Director | 152305810001 | ||||||||
HOLMES, Stephen Edward | Geschäftsführer | Parsonage Farm Stanbridge Earls SO51 0HE Romsey Hampshire | England | British | Company Director | 6218790003 | ||||||||
JONES, David Leslie | Geschäftsführer | Three Oak Barn RH14 0PY Plaistow West Sussex | British | Company Director | 83517310001 | |||||||||
KEAYS, Helen Margaret | Geschäftsführer | Clematis Cottage Old Warwick Road Rowington CV35 7AA Warwick Warwickshire | British | Director | 55393460002 | |||||||||
KEY, Matthew David | Geschäftsführer | Yardley School Lane Seer Green HP9 2QJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | Director | 62981720001 | |||||||||
LANGSTON, Edward | Geschäftsführer | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | Director | 24471140001 | ||||||||
LEE, Simon Christopher | Geschäftsführer | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | Director | 86697870001 | ||||||||
MELHUISH-HANCOCK, Douglas Charles | Geschäftsführer | 22 Nightingale House E1W 1UA London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 6218780001 | ||||||||
NOWAK, Thomas, Dr | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | Director | 174443800001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PEOPLES PHONE LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone Retail (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat PEOPLES PHONE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of rental deposit | Erstellt am 13. Mai 1998 Geliefert am 20. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease dated 9TH december 1992 | |
Kurze Angaben The sum of £32,500 together with all other sums to be paid into the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Okt. 1995 Geliefert am 18. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture and under the facility letter and/or in each case any deed or document supplemental thereto | |
Kurze Angaben Units 2,3 & 4 edge business centre humber road london NW2 6EF t/nos.NGL643301 NGL643288 and NGL668789. Peoples phone house edgware road london NW2 being the f/h property formerly k/a carlton forge garage edgware road cricklewood t/no. NGL525914. Victory park edgware road london being the f/h property on the north east side of edgware road cricklewood t/nos.NGL638762 NGL697023. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 08. Aug. 1995 Geliefert am 09. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company to the chargees pursuant to the terms of a lease dated 22/9/86 | |
Kurze Angaben The amount from time to time standing to the credit of an interest earning deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 23. Mai 1995 Geliefert am 09. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 6TH january 1978 | |
Kurze Angaben All amounts which are now or which may from time to time be standing to the credit of the account number 10733040 with barclays bank PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 07. Apr. 1995 Geliefert am 13. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease dated 15 april 1985 and this deed | |
Kurze Angaben £17,250 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 27. Jan. 1995 Geliefert am 07. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £13,500 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben £13,500 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 17. Jan. 1995 Geliefert am 21. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £17,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben £17,000 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 11. Jan. 1995 Geliefert am 13. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The company's obligations to the chargee under the terms of the lease | |
Kurze Angaben The amount of the deposit being £11,875.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Dez. 1994 Geliefert am 04. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 22. Dez. 1994 Geliefert am 24. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the services provider agreements (as defined) or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The interest of the company in it's customers from time to time and all goodwill associated with the vodafon network and benefit of the service provider agreements see form 395 for full details of all charged assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Agreement and charge | Erstellt am 22. Dez. 1994 Geliefert am 23. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility documents (as defined) | |
Kurze Angaben By way of equitable assignment all it's right title interest and benefit in and to the receivables. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 03. Okt. 1994 Geliefert am 04. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The obligations of the purchaser to the vendor under the terms of the lease | |
Kurze Angaben The amount of the deposit being £3,125.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 11. Aug. 1994 Geliefert am 19. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The company's obligations to the chargee under the terms of the leases | |
Kurze Angaben The amount of deposit being 411.542.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 11. Aug. 1994 Geliefert am 19. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The company's obligations to the chargee under the terms of the leases | |
Kurze Angaben The amount of deposit being £115,656.oo together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Instrument | Erstellt am 14. Jan. 1994 Geliefert am 27. Jan. 1994 Datum des Sicherungsinstruments 14. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | ||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of deposit | Erstellt am 28. Juli 1989 Geliefert am 01. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 28.7.89 | |
Kurze Angaben The companys' interest in the deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 08. Juni 1989 Geliefert am 14. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that l/h property k/a unit 1 the edge business centre, humber rd london NW2 including all fixed & moveable plant & machinery & fixture furniture implements & utensils & the goodwill of the business of a licensed hotelier & the benefit of all justices' excise or other licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Nov. 1988 Geliefert am 21. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan stock as defined in the deed. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Nov. 1988 Geliefert am 10. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fittings fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0