TRISTAR CARS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRISTAR CARS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02263554
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRISTAR CARS LIMITED?

    • Sonstiger Personenlandverkehr (49390) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich TRISTAR CARS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TRISTAR CARS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DATETOUR LIMITED01. Juni 198801. Juni 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRISTAR CARS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRISTAR CARS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    9 SeitenLIQ13

    Erfüllung der Belastung 022635540017 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 30. Juni 2017

    LRESSP

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2016

    27 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    1 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 022635540017, erstellt am 25. Aug. 2016

    50 SeitenMR01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Ernennung von Mr Andrew Ross Hohne als Direktor am 28. Juni 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Kenneth Boland als Geschäftsführer am 28. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Dean Peter De Beer als Direktor am 28. Juni 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Ross Hohne als Sekretär am 28. Juni 2016

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Andrew Kenneth Boland als Direktor am 28. Juni 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Dean Peter De Beer als Geschäftsführer am 28. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Richard Withers Green als Geschäftsführer am 28. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Ross Hohne als Geschäftsführer am 28. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2015

    20 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 06. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 338,543
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Dean Peter De Beer am 01. Sept. 2015

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von TRISTAR CARS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DE BEER, Dean Peter
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Geschäftsführer
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    EnglandBritish55606080007
    HOHNE, Andrew Ross
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Geschäftsführer
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    EnglandBritish63390230005
    DE BEER, Dean Peter
    64 Perrers Road
    Hammersmith
    W6 0EZ London
    Sekretär
    64 Perrers Road
    Hammersmith
    W6 0EZ London
    British55606080003
    HOHNE, Andrew Ross
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Sekretär
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    British63390230005
    PIGGOTT, Phillip John Christopher
    Ashcroft Snow Hill
    Copthorne
    RH10 3EY Crawley
    West Sussex
    Sekretär
    Ashcroft Snow Hill
    Copthorne
    RH10 3EY Crawley
    West Sussex
    British18305220003
    ROSS, David Peter John
    Flat 4 4 Roland Gardens
    SW7 3PM London
    Sekretär
    Flat 4 4 Roland Gardens
    SW7 3PM London
    British43841990001
    BOLAND, Andrew Kenneth
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Geschäftsführer
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    United KingdomBritish71264540006
    CLARINGBOLD, Douglas Bryan
    96 Staines Road
    TW19 5AG Wraysbury
    Middlesex
    Geschäftsführer
    96 Staines Road
    TW19 5AG Wraysbury
    Middlesex
    EnglandBritish199706860001
    DALE, James Hall
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish84675480001
    DE BEER, Dean Peter
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Geschäftsführer
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    EnglandBritish55606080007
    DUNSTONE, Charles William
    84 Campden Street
    W8 7EN London
    Geschäftsführer
    84 Campden Street
    W8 7EN London
    British43842070001
    HOHNE, Andrew Ross
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Geschäftsführer
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    EnglandBritish63390230005
    KEENLYSIDE, Philip Aiden
    11 The Riverside
    Graburn Way
    KT8 9BF East Moseley
    Surrey
    Geschäftsführer
    11 The Riverside
    Graburn Way
    KT8 9BF East Moseley
    Surrey
    British13017990003
    PIGGOTT, Phillip John Christopher
    Ashcroft Snow Hill
    Copthorne
    RH10 3EY Crawley
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Ashcroft Snow Hill
    Copthorne
    RH10 3EY Crawley
    West Sussex
    British18305220003
    ROSS, David Peter John
    Flat 4 4 Roland Gardens
    SW7 3PM London
    Geschäftsführer
    Flat 4 4 Roland Gardens
    SW7 3PM London
    British43841990001
    WITHERS GREEN, Anthony Richard
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Geschäftsführer
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    EnglandBritish83786360002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TRISTAR CARS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bodycove Ltd
    Horton Road
    UB7 8BQ West Drayton
    Unit 1
    England
    01. Okt. 2016
    Horton Road
    UB7 8BQ West Drayton
    Unit 1
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies England And Wales
    Registrierungsnummer03292923
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat TRISTAR CARS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 25. Aug. 2016
    Geliefert am 05. Sept. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The real property and the intellectual property specified in the instrument including the leasehold at 2003-2004 (postal 1A, 1B, 1C and 2), horton road, west drayton, middlesex, UB7 8BQ (title number: AGL193707) and the intellectual property listed in schedule 7 to the instrument. For more details please refer to the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V., London Branch (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Feb. 2012
    Geliefert am 09. Feb. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of confirmation and variation
    Erstellt am 03. Feb. 2012
    Geliefert am 09. Feb. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 02. Feb. 2012
    Geliefert am 03. Feb. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC as Security Trustee (Security Holder) for Each Group Member
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 22. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form MG01 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re tristar cars limited business premium account account number 13321371.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 17. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 28. Jan. 2008
    Geliefert am 12. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 09. Jan. 2008
    Geliefert am 16. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery (for details of properties please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 09. Jan. 2008
    Geliefert am 12. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 30. Dez. 2004
    Geliefert am 15. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Mai 2004
    Geliefert am 18. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All asset debenture
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 02. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All assets of the company by way of a first fixed and floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transaktionen
    • 02. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 14. Aug. 2002
    Geliefert am 20. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture deed
    Erstellt am 14. Aug. 2002
    Geliefert am 15. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 28. Aug. 1992
    Geliefert am 15. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H bungalow and blck corner garage t/nos sy 210971 and wsx 11313 together with all buildings and fixtures thereon assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 01. Feb. 1991
    Geliefert am 13. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at buildings at west side of rutherford way, crawley, west sussex title no. Wsx 90343. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 13. Feb. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 01. Dez. 1988
    Geliefert am 05. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including trade fixture. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 14. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 09. Nov. 1988
    Geliefert am 23. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all book debts and other debts. Floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (including those mentioned above) uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Nov. 1988Registrierung einer Belastung

    Hat TRISTAR CARS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Nov. 2018Aufgelöst am
    30. Juni 2017Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Barry John Stewart
    2nd Floor Suite 148, Central Chambers
    11 Bothwell Street
    G2 6LY Glasgow
    Praktiker
    2nd Floor Suite 148, Central Chambers
    11 Bothwell Street
    G2 6LY Glasgow

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0