MOTOR VEHICLE INDUSTRIES LIMITED

MOTOR VEHICLE INDUSTRIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMOTOR VEHICLE INDUSTRIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02264021
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MOTOR VEHICLE INDUSTRIES LIMITED?

    • (5010) /

    Wo befindet sich MOTOR VEHICLE INDUSTRIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    43-45 Portman Square
    London
    W1H 6LY
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MOTOR VEHICLE INDUSTRIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WESTERN (PDI) SERVICES LIMITED12. Okt. 198812. Okt. 1988
    WESTERN (PDI) LIMITED23. Sept. 198823. Sept. 1988
    TROVEMARSH LIMITED02. Juni 198802. Juni 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOTOR VEHICLE INDUSTRIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2001

    Welche sind die letzten Einreichungen für MOTOR VEHICLE INDUSTRIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:replacement of liquidator
    7 SeitenLIQ MISC OC

    Verschiedenes

    S/S release of liquidator
    1 SeitenMISC

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Verschiedenes

    O/C - replacement of liquidator
    6 SeitenMISC

    legacy

    1 Seiten287

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    2 Seiten2.15

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    legacy

    1 Seiten287

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Mitteilung über die Aufhebung des Verwaltungsbeschlusses

    4 Seiten2.19

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Mitteilung über das Ergebnis der Gläubigerversammlung

    3 Seiten2.23

    Vorschlag des Administrators

    5 Seiten2.21

    legacy

    1 Seiten287

    Verwaltungsbeschluss

    4 Seiten2.7

    Mitteilung über den Verwaltungsbeschluss

    1 Seiten2.6

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2001

    21 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von MOTOR VEHICLE INDUSTRIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILSON, Terence
    54 Cottesmore Road
    HU13 9JQ Hessle
    East Yorkshire
    Sekretär
    54 Cottesmore Road
    HU13 9JQ Hessle
    East Yorkshire
    BritishAccountant57018790001
    FISHER, Daniel Vincent
    4 Quay Court
    Sorrento 6020
    FOREIGN Western Australia
    Australia
    Geschäftsführer
    4 Quay Court
    Sorrento 6020
    FOREIGN Western Australia
    Australia
    AustralianCompany Director64953220001
    MACKINNON, Charles William
    15 Goldsmith Road
    Claremont
    6010 Perth
    Western Australia 6010
    Australia
    Geschäftsführer
    15 Goldsmith Road
    Claremont
    6010 Perth
    Western Australia 6010
    Australia
    AustralianInvestment Banker64952920001
    NICOL, Graham Keith
    56 Recreation Road
    Kalamunda 6076
    Western Australia
    Australia
    Geschäftsführer
    56 Recreation Road
    Kalamunda 6076
    Western Australia
    Australia
    AustralianAccountant64953110001
    GREEN, David Simon
    14 Chudleigh Crescent
    IG3 9AS Ilford
    Essex
    Sekretär
    14 Chudleigh Crescent
    IG3 9AS Ilford
    Essex
    British36449310001
    JAMES, John William
    15 Squirrel Rise
    Marlow Bottom
    SL7 3PN Marlow
    Buckinghamshire
    Sekretär
    15 Squirrel Rise
    Marlow Bottom
    SL7 3PN Marlow
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary936210001
    LIGHT, John Michael Heathcote
    138 Petersham Road
    TW10 6UX Richmond
    Surrey
    Sekretär
    138 Petersham Road
    TW10 6UX Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director2902370001
    LIGHT, John Michael Heathcote
    138 Petersham Road
    TW10 6UX Richmond
    Surrey
    Sekretär
    138 Petersham Road
    TW10 6UX Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director2902370001
    MACKINNON, Charles William
    15 Goldsmith Road
    Claremont
    6010 Perth
    Western Australia 6010
    Australia
    Sekretär
    15 Goldsmith Road
    Claremont
    6010 Perth
    Western Australia 6010
    Australia
    AustralianInvestment Banker64952920001
    BAUGHAN, David Louis
    Centre House 1 Gillus Lane
    Bempton
    YO15 1HW Bridlington
    North Humberside
    Geschäftsführer
    Centre House 1 Gillus Lane
    Bempton
    YO15 1HW Bridlington
    North Humberside
    BritishCompany Executive67106430001
    BRIGHTON, Alan
    Walnut Cottage
    Lowick
    NN14 3BD Kettering
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Walnut Cottage
    Lowick
    NN14 3BD Kettering
    Northamptonshire
    BritishAccountant88944270001
    FRANKLIN, Christopher Tom
    Woodway Barn Woodway Road
    Sibford Ferris
    OX15 5DA Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Woodway Barn Woodway Road
    Sibford Ferris
    OX15 5DA Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector70288830001
    GREEN, David Anthony
    1 Downs Villas
    Park Road
    HP23 6BW Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Downs Villas
    Park Road
    HP23 6BW Tring
    Hertfordshire
    BritishDevelopment Director61650810001
    HEATH, Reginald Frank
    Linden Croft
    Linden Road St Georges Hill
    KT13 0QW Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Linden Croft
    Linden Road St Georges Hill
    KT13 0QW Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director30254400001
    JAMES, John William
    15 Squirrel Rise
    Marlow Bottom
    SL7 3PN Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    15 Squirrel Rise
    Marlow Bottom
    SL7 3PN Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director936210001
    JAMES, John William
    15 Squirrel Rise
    Marlow Bottom
    SL7 3PN Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    15 Squirrel Rise
    Marlow Bottom
    SL7 3PN Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director936210001
    KIMBERLEY, Michael John
    30 Blakeney Close
    Eaton
    NR4 7QP Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    30 Blakeney Close
    Eaton
    NR4 7QP Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishBusiness Consultant75834210001
    LIGHT, John Michael Heathcote
    138 Petersham Road
    TW10 6UX Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    138 Petersham Road
    TW10 6UX Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director2902370001
    MURRAY, Richard Gordon
    Patrixbourne Oast
    Patrixbourne
    CT4 5DA Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    Patrixbourne Oast
    Patrixbourne
    CT4 5DA Canterbury
    Kent
    BritishCompany Director11168030001
    ROURKE, Maurice
    Beech Tree House
    The Street Ickham
    CT3 1QT Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    Beech Tree House
    The Street Ickham
    CT3 1QT Canterbury
    Kent
    BritishCompany Director9065040001
    SMITHAM, Lyndon
    19 Planetree Close
    B60 1AW Bromsgrove
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    19 Planetree Close
    B60 1AW Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishCompany Director11168050001
    WARKUP, Geoffrey Ernest
    Fourways
    Skipsea Brough
    YO25 8TH Driffield
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Fourways
    Skipsea Brough
    YO25 8TH Driffield
    East Yorkshire
    BritishOperations Director67106520001
    YOUNG, Nicholas
    1 Balmoral Close
    Fernhill Heath
    WR3 7XQ Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    1 Balmoral Close
    Fernhill Heath
    WR3 7XQ Worcester
    Worcestershire
    BritishChartered Accountant11168060001

    Hat MOTOR VEHICLE INDUSTRIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 20. Dez. 2002
    Geliefert am 27. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any other of the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 04. Juli 2000
    Geliefert am 12. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juli 2000
    Geliefert am 12. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land on the north west side of lancaster road carnaby - HS14722 also land on the northern side of lancaster road carnaby - HS5563 and land on the north side of lancaster road carnaby industrial estate - HS39890. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 14. Dez. 1999
    Geliefert am 24. Dez. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The free/lease property known as land on the northern side of lancaster road carnaby east yorkshire title number HS5563 the land on the north west side of lancaster road, carnaby east yorkshire title number HS14722 and the land on the north side of lancaster road carnaby industrial estate carnaby east yorkshire title number HS39890. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC (For Itself and as Security Trustee for Mvi Financial Services Limited)
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment and charge
    Erstellt am 14. Dez. 1999
    Geliefert am 24. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or auto distributor (pty) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies from time to time standing to the credit of an account of the company which is designated deposit account number 00609301 sort code 12-01-03 and the debt represented thereby and all the right, title benefit and interest of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC (For Itself and as Security Trustee for Itself and Mvi Financial Services LTD
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MOTOR VEHICLE INDUSTRIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Feb. 2003Beginn der Verwaltung
    25. März 2004Verwaltung entlassen
    Verwaltungsordnung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Kroll
    Airedale House
    LS1 5AP 77 Albion Street
    Leeds
    Praktiker
    Kroll
    Airedale House
    LS1 5AP 77 Albion Street
    Leeds
    Charles Peter Holder
    Kroll Ltd
    5th Floor, Airedale House
    LS1 5AP 77 Albion Street
    Leeds
    Praktiker
    Kroll Ltd
    5th Floor, Airedale House
    LS1 5AP 77 Albion Street
    Leeds
    2
    DatumTyp
    15. Juli 2010Abschluss der Liquidation
    10. Nov. 2003Antragsdatum
    25. März 2004Beginn der Liquidation
    22. Okt. 2010Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Simon James Underwood
    Menzies Corporate Restructuring
    17-19 Foley Street
    W1W 6DW London
    Praktiker
    Menzies Corporate Restructuring
    17-19 Foley Street
    W1W 6DW London
    Andrew Gordon Stoneman
    17/19 Foley Street
    W1W 6DW London
    Praktiker
    17/19 Foley Street
    W1W 6DW London
    Andrew John Duncan
    Leonard Curtis One Great Cumberland Place
    Marble Arch
    W1H 7LW London
    Praktiker
    Leonard Curtis One Great Cumberland Place
    Marble Arch
    W1H 7LW London
    Geoffrey Wayne Bouchier
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praktiker
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0