SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02265468 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 6 Snow Hill EC1A 2AY London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BIRMINGHAM SERVICETEAM LIMITED | 27. März 2001 | 27. März 2001 |
| TRANPLAN LIMITED | 20. Mai 1998 | 20. Mai 1998 |
| D.R. GODFREY LIMITED | 08. Juni 1988 | 08. Juni 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 210 Pentonville Road London N1 9JY zum 6 Snow Hill London EC1A 2AY am 19. Jan. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Miss Elaine Margaret Aitken als Sekretär am 12. Aug. 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Charles Hunt als Sekretär am 12. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Robert Charles Hunt als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 8Th Floor 210 Pentonville Road London N1 9JY England* am 30. Apr. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Berry als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert Charles Hunt als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Levett als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AITKEN, Elaine Margaret | Sekretär | Snow Hill EC1A 2AY London 6 England | 190255230001 | |||||||
| GERRARD, David Andrew | Geschäftsführer | Snow Hill EC1A 2AY London 6 England | United Kingdom | British | 136575180001 | |||||
| HUNT, Robert Charles | Geschäftsführer | Snow Hill EC1A 2AY London 6 England | United Kingdom | British | 87174080001 | |||||
| BERRY, Richard Douglas | Sekretär | 210 Pentonville Road N1 9JY London 8th Floor England | Australian | 134071050001 | ||||||
| BOHAN, Adrienne | Sekretär | 114 Crescent Road EN4 9RJ New Barnet Hertfordshire | Irish | 56124860001 | ||||||
| BOULT, Michael Gordon | Sekretär | 318 Fir Tree Road KT17 3NW Epsom Downs Surrey | British | 45388810001 | ||||||
| CANE, Micheal Geoffrey | Sekretär | Falstaff Close Walmley B76 1YG Sutton Coldfield 31 | British | 132670220001 | ||||||
| CHAMBERLAIN, Ian Philip | Sekretär | 10 Orwell Road Barrington CB2 5SE Cambridge Cambridgeshire | British | 28873120001 | ||||||
| HUNT, Robert Charles | Sekretär | Pentonville Road N1 9JY London 210 England | 165567060001 | |||||||
| HUNT, Robert Charles | Sekretär | The Chestnuts The Ley Box SN13 8JX Corsham Wiltshire | British | 87174080001 | ||||||
| MURPHY, Francis Joseph | Sekretär | Home Farm North End Lane Fulbeck NG32 3JR Grantham Lincolnshire | British | 32866430001 | ||||||
| PORRITT, Kerry Anne Abigail | Sekretär | Brushwood House 22 Clarence Road WR14 3EH Great Malvern Worcestershire | British | 166987180001 | ||||||
| RAINE, Richard Denby | Sekretär | 19 Madrid Road SW13 9PF London | British | 50519950002 | ||||||
| THOMPSON, Patrick Guy Netterville | Sekretär | 30 Shooters Hill Road SE3 7BD London | British | 66442860001 | ||||||
| WALKER, Philip Francis John | Sekretär | 9 Gilmore Road SE13 5AD London | British | 45389220001 | ||||||
| BOULT, Michael Gordon | Geschäftsführer | 68 Hillside SM7 1HF Banstead Surrey | British | 45388810002 | ||||||
| CRESSWELL, Richard Tom | Geschäftsführer | 20 New Road AL6 0AG Welwyn Hertfordshire | United Kingdom | British | 21952540002 | |||||
| DE SAINT QUENTIN, Axel | Geschäftsführer | 5l Portman Mansions Chiltern Street W1M 1PU London | French | 73659370001 | ||||||
| DU PELOUX DE SAINT ROMAIN, Cyrille | Geschäftsführer | 89 Kensington Court Mansions W8 5DU London | French | 110242530002 | ||||||
| GREENHALGH, Gary | Geschäftsführer | Washdyke Farm Lincoln Road NG32 3HY Fulbeck Lincolnshire | United Kingdom | British | 1192810001 | |||||
| HODGSON, Peter Gerald Pearson | Geschäftsführer | Arlington Ashstead Park KT21 1EG Ashstead Surrey | England | British | 45385340001 | |||||
| HUXLEY, Stephen George | Geschäftsführer | Manor Farm House 33 High Street Ketton PE9 3TA Stamford Lincolnshire | England | British | 96882500001 | |||||
| KILONBACK, David John | Geschäftsführer | 12 Rivermead KT8 9AZ East Molesey Surrey | British | 63153610001 | ||||||
| LEVETT, Paul | Geschäftsführer | 210 Pentonville Road N1 9JY London 8th Floor England | England | British | 44441110002 | |||||
| MALIK, Mushtaq Hussain | Geschäftsführer | 2 Quentin Road Blackheath SE13 5DQ London | British | 43136860001 | ||||||
| MALLETT, Gary James | Geschäftsführer | 26 Chancellor Avenue CM2 6WS Chelmsford Essex | Australian | 87652700001 | ||||||
| MCGRATH, Stephen John | Geschäftsführer | Brookfield Highford Lane NE46 2DP Hexham Northumberland | United Kingdom | British | 73426550001 | |||||
| MEISTER, Stefan Mario | Geschäftsführer | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | 43550520003 | ||||||
| MITCHELL, Brenden | Geschäftsführer | Tudor Cottage Green Road Rickling Green CB11 3YD Saffron Walden Essex | Australian | 100757060001 | ||||||
| NOLAN, Paul Laurence | Geschäftsführer | 18 Goldrings Road KT22 0QR Oxshott Bridgend House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 139216460001 | |||||
| RAINE, Richard Denby | Geschäftsführer | 19 Madrid Road SW13 9PF London | United Kingdom | British | 50519950002 | |||||
| REED, Michael Geoffrey | Geschäftsführer | The Green Barrow IP29 5AA Bury St. Edmunds Ormesby Cottage Suffolk | England | British | 136222240001 | |||||
| REVELL, Anthony William | Geschäftsführer | 26 Ryland Road Welton LN2 3LU Lincoln | British | 980590001 | ||||||
| RUDD, Jeremy George Winterton | Geschäftsführer | Brabant, Gibbs Lane Offenham WR11 8RR Evesham Worcestershire | British | 79668780001 | ||||||
| STEWARD, Michael | Geschäftsführer | Old Farm Lower Potton Road Croydon SG8 0HE Royston Hertfordshire | British | 16406470001 |
Hat SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 26. Jan. 2000 Geliefert am 03. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Juli 1997 Geliefert am 28. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the investment agreement and/or the deed of guarantee and/or any agreement or other documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Feb. 1997 Geliefert am 11. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a deed of guarantee and indemnity dated 3RD february 1997 and the debenture (as defined therein) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 1996 Geliefert am 10. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a deed of guarantee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Okt. 1995 Geliefert am 25. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined therein) on any account whatsoever under or in connection with any of the financing documents (as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Dez. 1988 Geliefert am 05. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including heritable property & assets in scotland lease of first floor offices at 14A hill street saffron walden. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0