EXHAUST DESPATCH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEXHAUST DESPATCH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02266612
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EXHAUST DESPATCH LIMITED?

    • (5020) /

    Wo befindet sich EXHAUST DESPATCH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EXHAUST DESPATCH LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LIFTNOW LIMITED10. Juni 198810. Juni 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EXHAUST DESPATCH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Welche sind die letzten Einreichungen für EXHAUST DESPATCH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    1 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 13. Feb. 2009

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. Aug. 2008

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten287

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten287

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    33 Seiten3.10

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    5 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 1998

    16 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363s

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    2 Seiten244

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    Wer sind die Geschäftsführer von EXHAUST DESPATCH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MASKELL, Philip John
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Sekretär
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishFinance Director5733160003
    BRIDGMAN, Michael
    Broomfield Lodge Broomfield Park
    Sunningdale
    SL5 0JS Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Broomfield Lodge Broomfield Park
    Sunningdale
    SL5 0JS Ascot
    Berkshire
    BritishManaging Director74833800001
    MASKELL, Philip John
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director5733160003
    EYLES, Peter Malcolm
    5 Hazelbury Close
    Wimbledon
    SW19 3JL London
    Sekretär
    5 Hazelbury Close
    Wimbledon
    SW19 3JL London
    British54007140001
    PRICE, Beryl Jean
    Oakmeade Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Berkshire
    Sekretär
    Oakmeade Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Berkshire
    British2883670001
    SMITH, Brian Edward James
    Robins Grove
    Church Lane
    SL2 4PB Stoke Poges
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Robins Grove
    Church Lane
    SL2 4PB Stoke Poges
    Buckinghamshire
    British4699750001
    BENOLIEL, Derek Richard John
    11 Glebe Road
    RH4 3DS Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    11 Glebe Road
    RH4 3DS Dorking
    Surrey
    BritishDirector32539430001
    PRICE, Beryl Jean
    Oakmeade Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Oakmeade Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Berkshire
    BritishSecretary2883670001
    PRICE, John Hanshaw
    Oakmeade Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Oakmeade Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Berkshire
    BritishManaging Director2883680001

    Hat EXHAUST DESPATCH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and charge
    Erstellt am 12. Apr. 2000
    Geliefert am 27. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each charging company to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries (as defined)) (the "security trustee") and all costs charges and expenses properly incurred by the chargee in connection with the preparation and negotiation of the banking documents
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 04. Dez. 1999
    Geliefert am 10. Dez. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All present and future right title and interest in the plant machinery chattels or other equipment described in schedule 2 to the mortgage the benefit of any guarantee warranty or other obligations in relation to the mortgaged chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge over account balances
    Erstellt am 04. Dez. 1999
    Geliefert am 10. Dez. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies from time to time held to the credit of each company listed in schedule 1 to the deed by the bank on any current deposit or other account or accounts which the company may have with lloyds tsb bank PLC.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Dez. 1997
    Geliefert am 12. Dez. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee or to the security beneficiaries (as defined) on any account whatsoever whether pursuant to the guarantee (as defined) provided that the obligations owed by any group company to the security beneficiaries in respect of the refinancing facility shall not from part of the secondary secured obligations; all costs expenses incurred by the security trustee and/or the security beneficiaries in relation to the deed
    Kurze Angaben
    17 rainbow hill, worcester hereford and worcester t/no: HW34917; 19 hampton road droitwich, hereford and worcester t/no: HW121499; 152 wide marsh street hereford and worcester .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Mezzanine Limited; As Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 09. Aug. 1996
    Geliefert am 20. Aug. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC("the Security Trustee")
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2000Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 130. Juli 2010Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
    Legal charge
    Erstellt am 24. Apr. 1995
    Geliefert am 05. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 17 rainbow hill, worcester, hereford and worcester t/n HW34917 and all buildings, fixtures and goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Apr. 1995
    Geliefert am 05. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 19 hampton road, droitwich, hereford and worcester t/n HW121499 and all buildings, fixtures and goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Apr. 1995
    Geliefert am 05. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    152 widemarsh street, hereford, hereford and worcester and all buildings, fixtures and goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Single debenture
    Erstellt am 24. Apr. 1995
    Geliefert am 05. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H properties known as 19 hampton road, hereford and worcester/droitwich t/n HW121499 and 17 rainbow hill, hereford and worcester, 152 widemarsh street, hereford, hereford and worcester.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Single debenture
    Erstellt am 22. Apr. 1995
    Geliefert am 04. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Apr. 1995
    Geliefert am 04. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 152 widemarsh street, hereford, hereford and worcester and all buildings, fixtures and goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Apr. 1995
    Geliefert am 04. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 19 hampton road, droitwich, hereford and worcester and all buildings, fixtures and goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Apr. 1995
    Geliefert am 04. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 17 rainbow hill, worcester, hereford and worcester t/n HW34917 and all buildings, fixtures and goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EXHAUST DESPATCH LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Aug. 1996Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young
    P O Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young
    P O Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Alan Robert Bloom
    Cloth Hall Court
    14 King Street
    LS1 2JN Leeds
    Praktiker
    Cloth Hall Court
    14 King Street
    LS1 2JN Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0