ORANGE BRAND SERVICES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ORANGE BRAND SERVICES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02266684 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ORANGE BRAND SERVICES LIMITED?
- Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ORANGE BRAND SERVICES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 More London Riverside SE1 2AQ London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ORANGE BRAND SERVICES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ORANGE EUROMESSAGE LIMITED | 13. Juli 2001 | 13. Juli 2001 |
HUTCHISON EUROMESSAGE LIMITED | 15. Jan. 1992 | 15. Jan. 1992 |
EUROMESSAGE LIMITED | 25. Aug. 1989 | 25. Aug. 1989 |
EUROPAGE LIMITED | 10. Juni 1988 | 10. Juni 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ORANGE BRAND SERVICES LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ORANGE BRAND SERVICES LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 12. Apr. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 26. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 12. Apr. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für ORANGE BRAND SERVICES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 51 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Christine Walser-Sacau als Geschäftsführer am 08. Dez. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 51 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 11th Floor 5 Merchant Square, Paddington, London England W2 1AY England zum Unit 2a 2 Kingdom Street London W2 6BD geändert | 1 Seiten | AD02 | ||
Beendigung der Bestellung von Christophe Marie Pascal Henri Naulleau als Geschäftsführer am 31. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 50 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Mark James Broom als Direktor am 28. Juni 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Gillian Mary Miles als Geschäftsführer am 25. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Ms Shermineh Sheibani als Sekretär am 21. Sept. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Ibiyemi Solanke als Sekretär am 21. Sept. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Ms Anne Imbert als Direktor am 29. Juni 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 50 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jean-Francois Rodriguez als Geschäftsführer am 30. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 50 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mrs Donna Celia Soane als Direktor am 23. Juni 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Martin John Crossley als Geschäftsführer am 31. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Apr. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 31 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Mickael Jean Faure als Direktor am 11. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Maria Elena Cabrero Sanchez als Geschäftsführer am 11. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ORANGE BRAND SERVICES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEIBANI, Shermineh | Sekretär | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England England | 288374410001 | |||||||
BROOM, Mark James | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2AQ London 3 United Kingdom | United Kingdom | British | Vp Fraud & Revenue Assurance Group | 298144740001 | ||||
FAURE, Mickael Jean | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England England | United Kingdom | French | Brand Strategy And Performance Director | 253516350001 | ||||
IMBERT, Anne | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England England | France | French | Executive Vice President - Brand And Content | 284806350001 | ||||
SOANE, Donna Celia | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England England | United Kingdom | British | Director | 271163160001 | ||||
DOYLE, Amanda | Sekretär | Cotswold House Horseshoe Lane BS37 6ES Chipping Sodbury | British | 77978950001 | ||||||
DUBOIS DENIS, Isabelle | Sekretär | 17 Star Street W2 1QD London | British | 83784610001 | ||||||
DUBOIS DENIS, Isabelle | Sekretär | 17 Star Street W2 1QD London | British | 83784610001 | ||||||
GUY, Estelle Una | Sekretär | Flat 6 10 York Street W1U 6PW London | British | 65966530002 | ||||||
GUY, Estelle Una | Sekretär | 36 Priory Avenue Chingford E4 8AB London | British | 65966530001 | ||||||
MOWAT, Charles | Sekretär | Great Park Road Almondsbury Park BS32 4QJ Bradley Stoke St. James Court Bristol England | British | 108098180003 | ||||||
PATERSON, Mark Alexander | Sekretär | 6 Brackley Road W4 2HN London | British | 98795620001 | ||||||
RICHARDSON, Anna | Sekretär | 49 Cyril Mansions Prince Of Wales Drive SW11 4HW London | British | 92706030002 | ||||||
SHEDDEN, Robert Alan | Sekretär | 18c Hillfield Road West Hampstead NW6 1PZ London | British | 76265950001 | ||||||
SOLANKE, Ibiyemi | Sekretär | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England England | 162961930001 | |||||||
TAHERI-KADKHODA, Ashkan Ashley | Sekretär | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England England | 210333240001 | |||||||
ABOGADO CUSTODIANS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021140001 | |||||||
ABOGADO NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021150001 | |||||||
ALBANEL, Christine Marie | Geschäftsführer | St James Court Great Park Road Almondsbury Park BS32 4QJ Bradley Stoke Bristol | France | French | Company Director | 155572020001 | ||||
ALLWOOD, Charles John | Geschäftsführer | Park Farm The Twist Wigginton HP23 6DU Tring Hertfordshire | England | British | Accountant | 35681240003 | ||||
ALLWOOD, Charles John | Geschäftsführer | Park Farm The Twist Wigginton HP23 6DU Tring Hertfordshire | England | British | Accountant | 35681240003 | ||||
BLANCHET, Philippe | Geschäftsführer | 59 Rue D'Auteuil FOREIGN Paris 75016 France | French | Head Of Legal Services And Com | 103404110001 | |||||
BOULBEN, Frank | Geschäftsführer | 2 Rue De Villersexel FOREIGN Paris 75007 France | French | Executive Vice President Brand | 106359800001 | |||||
CONNAL, Sulina | Geschäftsführer | Great Park Road Almondsbury Park BS32 4QJ Bradley Stoke St. James Court Bristol England | British | Barrister | 92116890002 | |||||
COTTINGHAM, Iain David | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England England | United Kingdom | British | Accountant | 186887570001 | ||||
CROSSLEY, Martin John | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England United Kingdom | England | British | International Telecoms Manager | 195478150001 | ||||
DERWENT, Robin Evelyn Leo, The Right Honourable Lord | Geschäftsführer | Flat 6 Sovereign Court 29 Wrights Lane W8 5SH London | British | Company Director | 36163130004 | |||||
EVANS, Sally Ann | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England England | United Kingdom | British | Company Director | 156566310001 | ||||
FULLER, Robert | Geschäftsführer | Fenrother Grange Fenrother Longhorsley NE61 3DP Morpeth Northumberland | British | Group Director | 36842350002 | |||||
GHILLEBAERT, Bernard | Geschäftsführer | Great Park Road Almondsbury Park BS32 4QJ Bradley Stoke St. James Court Bristol England | French | Chief Executive Officer | 101439390001 | |||||
GIBSON, Ian Charles | Geschäftsführer | Mendip Cottage Shrowle, East Harptree BS40 6BJ Bristol Avon | British | Director Of Finance | 141445820001 | |||||
HOBLEY, David Charles Denholm | Geschäftsführer | Great Park Road Almondsbury Park BS32 4QJ Bradley Stoke St. James Court Bristol England | United Kingdom | British | Company Director | 55275940001 | ||||
HOWE, Graham Edward | Geschäftsführer | 5 Rosebery Avenue AL5 2QT Harpenden Hertfordshire | British | Group Finance Director | 33771120003 | |||||
LEGRIX DE LA SALLE, Severine Marie Yolaine | Geschäftsführer | St James Court Great Park Road Almondsbury Park BS32 4QJ Bradley Stoke Bristol | France | French | Company Director | 156643240001 | ||||
MARIGNY, Thierry Michel | Geschäftsführer | Rue De Serres 75007 Paris 86 France France | France | French | Brand Director | 174044380001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ORANGE BRAND SERVICES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange S.A. | 06. Apr. 2016 | Rue Olivier De Serres 75015 Paris 78 France | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ORANGE BRAND SERVICES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite debenture | Erstellt am 19. Dez. 1997 Geliefert am 31. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as therein defined) | |
Kurze Angaben Block a st james court south great park road woodlands lane bradley stoke t/n AV206385 block b st james court south great park road woodlands lane bradley stoke t/n AV206535 and ground floor key point great park road bradley stoke (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture | Erstellt am 25. Apr. 1996 Geliefert am 07. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (as defined in the credit agreement dated 21ST december, 1995) to the chargee under the terms of each finance document (as defined) to which any obligor is a party | |
Kurze Angaben (I) office buiding k/a key point great park road bradley stoke. (Ii) all buildings and fixtures on the property above. (Iii) the proceeds of sale of all or any part of the property specified in paragraphs (I) and (ii) (inclusive) above in the event that such property has not been released in accordance with clause 18 (release) of the original composite debenture (see ch microfiche for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 21. Dez. 1995 Geliefert am 04. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors to the chargee under each finance document to which any obligor is a party (the "secured liabilities") | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0