BRITANNIA FILMS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRITANNIA FILMS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02268167
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRITANNIA FILMS LIMITED?

    • Filmproduktionsaktivitäten (59111) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich BRITANNIA FILMS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4th Floor 3-4
    John Princes Street
    W1G 0JL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRITANNIA FILMS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LAST PRODUCTIONS LIMITED02. Juli 199902. Juli 1999
    RENAISSANCE FILMS LIMITED28. Sept. 198828. Sept. 1988
    BURLINGTON FILM PRODUCTIONS PLC 30. Juni 198830. Juni 1988
    STARTVALUE PUBLIC LIMITED COMPANY16. Juni 198816. Juni 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRITANNIA FILMS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRITANNIA FILMS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Anthony Evans am 02. Juni 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Anthony Evans am 31. Mai 2019

    2 SeitenCH01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Change of details for Mr Stephen Anthony Evanas as a person with significant control on 10. März 2019

    2 SeitenPSC04

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    9 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Anthony Evans am 01. Juni 2018

    2 SeitenCH01

    Change of details for Mr Stephen Anthony Evanas as a person with significant control on 01. Mai 2018

    2 SeitenPSC04

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    16 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 13. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 921,694
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 10. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 921,694
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 22. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 921,694
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von BRITANNIA FILMS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EVANS, Stephen Anthony
    Peabody Close
    SW1V 4BA London
    39
    England
    Geschäftsführer
    Peabody Close
    SW1V 4BA London
    39
    England
    EnglandBritishFilm Producer114331730008
    PARFITT, David John
    11 Trinity Rise
    SW2 2QP London
    Sekretär
    11 Trinity Rise
    SW2 2QP London
    British32970510003
    SPURR, Colin Luke Edmundson
    8 Gainsborough Avenue
    AL1 4NL St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    8 Gainsborough Avenue
    AL1 4NL St Albans
    Hertfordshire
    British103402400001
    BRANAGH, Kenneth
    30 Crediton Hill
    West Hampstead
    NW6 1HP London
    Geschäftsführer
    30 Crediton Hill
    West Hampstead
    NW6 1HP London
    BritishActor/Director60517590002
    COLEMAN, Sylvia May
    19 Coulson Street
    SW3 3NA London
    Geschäftsführer
    19 Coulson Street
    SW3 3NA London
    EnglandBritishLawyer34894480002
    PARFITT, David John
    11 Trinity Rise
    SW2 2QP London
    Geschäftsführer
    11 Trinity Rise
    SW2 2QP London
    EnglandBritishFilm Producer32970510003
    RUSSELL, Paul
    31 Hyde Park Gardens Mews
    W2 2NX London
    Geschäftsführer
    31 Hyde Park Gardens Mews
    W2 2NX London
    BritishCompany Director69493230001
    SPIERS, John Dudley
    8 Lexham Mews
    W8 6JW London
    Geschäftsführer
    8 Lexham Mews
    W8 6JW London
    United KingdomBritishCompany Director35535680001
    STRADLING, Stuart Rhys
    68 Howards Lane
    Putney
    SW15 6QD London
    Geschäftsführer
    68 Howards Lane
    Putney
    SW15 6QD London
    United KingdomBritishStockbroker44265550001
    SYDOW, Karl Gordon
    17 Lonsdale Place
    N1 1EL London
    Geschäftsführer
    17 Lonsdale Place
    N1 1EL London
    UsaCompany Director8553020001
    WENHAM, Brian George
    Red Cottage Wey Road
    KT13 8HW Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Red Cottage Wey Road
    KT13 8HW Weybridge
    Surrey
    BritishBroadcasting Consultant1252580001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BRITANNIA FILMS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Stephen Anthony Evanas
    Peabody Close
    SW1V 4BA London
    39
    England
    06. Apr. 2016
    Peabody Close
    SW1V 4BA London
    39
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat BRITANNIA FILMS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 12. Jan. 2010
    Geliefert am 16. Jan. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form MG01 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re britannia films limited business premium account, account number 03596281.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 17. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Barclays bank PLC re britannia films limited barclays business premium account, account number: 50550914. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Development loan agreement and security assignment which was executed outside the united kingdom comprising property situated outside the united kingdom
    Erstellt am 29. Juli 1997
    Geliefert am 06. Aug. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Up to £110,944 together with a premium of 25% thereof and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    65% of renaissance's copyright whether vested contingent or future and all rights of whatever nature whether now known or hereafter created in the development work provisionally entitled "florentine". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • TF1 Films Production S.A.
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 13. Sept. 1994
    Geliefert am 19. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all the deposits referred to in the schedule all money payable pursuant to such deposits. All sums of money deposited or to be held in a business premium account no: 20106283. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Feb. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Agreement
    Erstellt am 04. Aug. 1992
    Geliefert am 19. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee of completion
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the film "much ado about nothing". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Film Finances
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 04. Aug. 1992
    Geliefert am 10. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the facility letter
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge throughout the universe (subject only to those rights to be granted to the B.B.c and efd pursuant to the B.B.C. agreement and the efd agreement resppectively upon payment in full of the B.B.C. advance and the efd advance respectively): all the filmrights,copyrights, in the film andc any other films and any sound recordings made in the production of the film or pursuant to anuy right aquired in connection with the said production . the said film being provisionally entitled " much ado about nothing" please seeform 395 for further details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Aug. 1992
    Geliefert am 10. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Please see doc for further details.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and deed of assignment
    Erstellt am 11. März 1992
    Geliefert am 27. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become from the company to the chargee pursuant to a facility letter of even date and/or this charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all the film rights and all that CO0PYRIGHT in the film and any other films and any soundrecordings made see 395 81 l 30/3 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 27. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of agreement & charge
    Erstellt am 27. Feb. 1992
    Geliefert am 28. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing all monies due or to becomefrom the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27/1/92 and or this charge
    Kurze Angaben
    All the companys right title and interest in the film including (a) the copyright and all other rights in all underlying material (b) the copyright in the film(c) all property aquired for or relatingto the film please see form 395 2 l 3/3 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Film and Television Completions PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 19. Okt. 1990
    Geliefert am 02. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The company as beneficial owner assigns absolutele to the bank subject only to the provison for redemption contained in the supplemental debenture) all, its right title and interest in and to the underwriting agreements as defined in the supplemental debenture. (Please see doc 395/m/44/l/5/11 for complete details).
    Berechtigte Personen
    • British & Commonwealth Merchant Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 06. März 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplement debenture
    Erstellt am 07. Feb. 1990
    Geliefert am 16. Feb. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to an underwriting agreement dated 17-10-88 as amended and restated in a certain supplement underwriting agreement dated 7-2-90 see form 395 (ref 173) for full details.
    Berechtigte Personen
    • British & Commonwealth Merchant Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1990Registrierung einer Belastung
    • 06. März 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Okt. 1989
    Geliefert am 27. Okt. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • British & Commonwealth Merchant Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1989Registrierung einer Belastung
    • 06. März 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Agreement between renaissance film PLC and film finances LTD
    Erstellt am 20. Okt. 1988
    Geliefert am 25. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Subject to the right of the bbc and the bank of boston LTD the following all in the right title and interest of the company in the film and the script on which it is based togethewr with the right of representing updating and exhibiting thefilm. For full details see form.
    Berechtigte Personen
    • Film Finances Limited
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 20. Okt. 1988
    Geliefert am 28. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Boston Limited
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1988Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0