MANCHESTER GARAGES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MANCHESTER GARAGES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02269542 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MANCHESTER GARAGES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MANCHESTER GARAGES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MANCHESTER GARAGES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PRIORSCREEN LIMITED | 21. Juni 1988 | 21. Juni 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MANCHESTER GARAGES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MANCHESTER GARAGES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. Mai 2021
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Philip Herbert als Geschäftsführer am 30. Juni 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Simon Willis als Direktor am 08. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Philip Herbert als Direktor am 01. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Paul Holden als Geschäftsführer am 31. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Trevor Garry Finn als Geschäftsführer am 31. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard James Maloney als Sekretär am 01. Jan. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hilary Claire Sykes als Sekretär am 01. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hilary Claire Sykes als Geschäftsführer am 01. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Trevor Garry Finn am 18. Okt. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MANCHESTER GARAGES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALONEY, Richard James | Sekretär | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | 222196170001 | |||||||
CASHA, Martin Shaun | Geschäftsführer | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Director | 41114490010 | ||||
WILLIS, Mark Simon | Geschäftsführer | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Director | 229010610001 | ||||
HOLROYD, John | Sekretär | Arncliffe House Farm Starbotton BD23 5HY Skipton North Yorkshire | British | 21483450001 | ||||||
SYKES, Hilary Claire | Sekretär | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | British | Director | 41559790001 | |||||
BRAMALL, Douglas Charles Antony | Geschäftsführer | Warren Farm Warren Lane Brearton HG3 3DB Harrogate | United Kingdom | British | Company Director | 29331220001 | ||||
FINN, Trevor Garry | Geschäftsführer | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Director | 2652610013 | ||||
FORSYTH, David Robertson | Geschäftsführer | Scotland Cottage Melbourne DE73 1BH Derby | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 55127120002 | ||||
HERBERT, Mark Philip | Geschäftsführer | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Director | 123285980005 | ||||
HOLDEN, Timothy Paul | Geschäftsführer | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Chartered Accountant | 148034310003 | ||||
HOLROYD, John | Geschäftsführer | Arncliffe House Farm Starbotton BD23 5HY Skipton North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 21483450001 | |||||
SYKES, Hilary Claire | Geschäftsführer | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Director | 41559790001 | ||||
YARWOOD, William John | Geschäftsführer | 182 Davyhulme Road Urmston M41 8QD Manchester | British | Company Director | 1577370001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MANCHESTER GARAGES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester Garage Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Loxley House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat MANCHESTER GARAGES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A security agreement | Erstellt am 13. Mai 2009 Geliefert am 21. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture made between the company (the "chargor") and the governor and company of the bank of scotland,as agent and security trustee for the secured parties | Erstellt am 13. Juni 2002 Geliefert am 21. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed | Erstellt am 23. Jan. 1998 Geliefert am 29. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined) which are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 2ND january 1998 | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 02. Jan. 1998 Geliefert am 16. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for the secured parties (as defined) the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property being f/h land and buildings on the north side of gorton lane manchester greater manchester t/n- GM87553; f/h land and buildings on the north side of gorton lane manchester t/n-LA277291 and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on any such property belonging to the company. .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Juli 1993 Geliefert am 27. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed & debenture | Erstellt am 03. Aug. 1990 Geliefert am 15. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries pursuant to any of the facility documents or any of the consortium documents as defined in this deed. | |
Kurze Angaben (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0