MANCHESTER GARAGES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMANCHESTER GARAGES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02269542
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MANCHESTER GARAGES LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MANCHESTER GARAGES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MANCHESTER GARAGES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PRIORSCREEN LIMITED21. Juni 198821. Juni 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MANCHESTER GARAGES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für MANCHESTER GARAGES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 28. Mai 2021

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Mark Philip Herbert als Geschäftsführer am 30. Juni 2019

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark Simon Willis als Direktor am 08. Apr. 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Mark Philip Herbert als Direktor am 01. Apr. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Paul Holden als Geschäftsführer am 31. März 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Trevor Garry Finn als Geschäftsführer am 31. März 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    6 SeitenAA

    Ernennung von Mr Richard James Maloney als Sekretär am 01. Jan. 2017

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Hilary Claire Sykes als Sekretär am 01. Jan. 2017

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Hilary Claire Sykes als Geschäftsführer am 01. Jan. 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Trevor Garry Finn am 18. Okt. 2016

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von MANCHESTER GARAGES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    222196170001
    CASHA, Martin Shaun
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector41114490010
    WILLIS, Mark Simon
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector229010610001
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Sekretär
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    British21483450001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector41559790001
    BRAMALL, Douglas Charles Antony
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    Geschäftsführer
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    United KingdomBritishCompany Director29331220001
    FINN, Trevor Garry
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector2652610013
    FORSYTH, David Robertson
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    Geschäftsführer
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant55127120002
    HERBERT, Mark Philip
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector123285980005
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant148034310003
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    BritishChartered Accountant21483450001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector41559790001
    YARWOOD, William John
    182 Davyhulme Road
    Urmston
    M41 8QD Manchester
    Geschäftsführer
    182 Davyhulme Road
    Urmston
    M41 8QD Manchester
    BritishCompany Director1577370001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MANCHESTER GARAGES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Manchester Garage Holdings Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06. Apr. 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer431045
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat MANCHESTER GARAGES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A security agreement
    Erstellt am 13. Mai 2009
    Geliefert am 21. Mai 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Override Agent)
    Transaktionen
    • 21. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee and debenture made between the company (the "chargor") and the governor and company of the bank of scotland,as agent and security trustee for the secured parties
    Erstellt am 13. Juni 2002
    Geliefert am 21. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 23. Jan. 1998
    Geliefert am 29. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined) which are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 2ND january 1998
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 02. Jan. 1998
    Geliefert am 16. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for the secured parties (as defined) the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined)
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property being f/h land and buildings on the north side of gorton lane manchester greater manchester t/n- GM87553; f/h land and buildings on the north side of gorton lane manchester t/n-LA277291 and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on any such property belonging to the company. .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Sept. 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Juli 1993
    Geliefert am 27. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed & debenture
    Erstellt am 03. Aug. 1990
    Geliefert am 15. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries pursuant to any of the facility documents or any of the consortium documents as defined in this deed.
    Kurze Angaben
    (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Citibank N.A.
    Transaktionen
    • 15. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 02. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0