EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED

EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02276013
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    APTA HEALTHCARE (NOTTINGHAM) LIMITED03. Jan. 199503. Jan. 1995
    REALCARE HOMES LIMITED21. Nov. 198821. Nov. 1988
    RIMFORGE LIMITED11. Juli 198811. Juli 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012

    1 SeitenTM02

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Jan. 2012

    Kapitalaufstellung am 18. Jan. 2012

    • Kapital: GBP 4,000,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    25 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Explanatory statement to sole member 14/05/2010
    RES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009

    25 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector163496070001
    BAKER, Graham
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    BritishChartered Accountant40240710001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Sekretär
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    BritishFinance Director53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Sekretär
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Sekretär
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Sekretär
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    LOUKES, Kenneth Martin
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    British6945830001
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Sekretär
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158306100001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Sekretär
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    BritishChartered Accountant69603410001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Sekretär
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001
    SMITH, Peter Anthony
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    Sekretär
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    British71842080001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Sekretär
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    BritishFinance Director69112020001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Geschäftsführer
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    BritishCompany Director57906600001
    BAKER, Graham
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    BritishChartered Accountant40240710001
    BALLANTYNE, Thomas Niven
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director68970050002
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector66559170001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    AmericanHealth Care Administrator51593550001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890003
    FARMER, Nicholas John
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector124228290001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    BritishDirector14241020001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Geschäftsführer
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Director53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Geschäftsführer
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    AmericanDirector100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishManaging Director111188390002
    GEE, Andrew Anthony Edward
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    Geschäftsführer
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    EnglandBritishDirector93592160001
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Geschäftsführer
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    BritishDirector66801660002
    GWATKIN, Peter Frederick Stapleton
    Shustoke Hall Moathouse Lane
    Shustoke Coleshill
    B46 2RJ Birmingham
    Geschäftsführer
    Shustoke Hall Moathouse Lane
    Shustoke Coleshill
    B46 2RJ Birmingham
    BritishCompany Director42082340004
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Geschäftsführer
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    BritishCompany Chairman79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Geschäftsführer
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporeanDirector101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Geschäftsführer
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritishDirector5579020001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritishDirector144822040001
    LOUKES, Kenneth Martin
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    BritishDirector6945830001

    Hat EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 23. März 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The obligations of the company to the chargee in a lease dated 23RD march 1998
    Kurze Angaben
    A deposit of £74,500 (initially) which will during the life of the rent deposit deed be increased as set out in the rent deposit deed.
    Berechtigte Personen
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. März 1998
    Geliefert am 07. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Inclusive of the l/h interest of the company in and to the "legal charge property" k/a site 5B2, copperfield road thamesmead all fixtures and the proceeds of sale. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Feb. 1996
    Geliefert am 14. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Mortgage 8,9 and 10 third avenue sherwood drive nottingham t/n's NT19209 and NT30826 all buildings and other structures any goodwill all olant macinery and items the proceeds of any claims under the insurances by way of assignment the rental sums and by way of floating charge all unattached plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Feb. 1996
    Geliefert am 14. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The chestnuts hotel main road rasdcliffe on trent nottinghamshire t/n NT155409 by way of fixed charge all buildings and structures by way of fixed charge any goodwill all plant machinery and other items and the proceeds of any claims under the insurances by way of assignment the rental sums by way of floating charge all unattached plant machinery and chattels.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Dez. 1995
    Geliefert am 12. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Aug. 1995
    Geliefert am 17. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The properties as detailed in the continuation sheet attached to the form 395 and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 1995
    Geliefert am 07. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H-willow court nursing home being land on the east side of croft lane, cherry willingham, west lindsey lincolnshire t/n-LL88541. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 1995
    Geliefert am 07. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H-white gables nursing home lincoln road skellingthorpe and land at skellingthorpe, north kesteven lincolnshire t/n-LL54775 and LL73989. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 1995
    Geliefert am 07. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H-wood view nursing home being land on the south west side and land and buildings lying to the south west of lincoln road and being 127 lincoln road branston north kesteven lincolnshire t/n-LL91827 and LL93202. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 1995
    Geliefert am 07. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-willow court nursing home being land on east side of croft lane cherry willingham west lindsey lincolneshire t/n-LL88541. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 24. Dez. 1991
    Geliefert am 07. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the security documents as defined
    Kurze Angaben
    See doc ref M560C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Jan. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    20. Aug. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praktiker
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0