EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED
Überblick
Unternehmensname | EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02276013 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
APTA HEALTHCARE (NOTTINGHAM) LIMITED | 03. Jan. 1995 | 03. Jan. 1995 |
REALCARE HOMES LIMITED | 21. Nov. 1988 | 21. Nov. 1988 |
RIMFORGE LIMITED | 11. Juli 1988 | 11. Juli 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 6 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR, Stephen Jonathan | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 163496070001 | ||||
BAKER, Graham | Sekretär | 26 Hazelhurst Road Kings Heath B14 7PJ Birmingham West Midlands | British | Chartered Accountant | 40240710001 | |||||
FEENEY, Martin | Sekretär | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | Finance Director | 53915080001 | |||||
FORD, Colin Andrew | Sekretär | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
HURRELL, Steven Alfred | Sekretär | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
KIME, Sean Thomas | Sekretär | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
LOUKES, Kenneth Martin | Sekretär | 23 The Chase HA7 3RU Stanmore Middlesex | British | 6945830001 | ||||||
MACFARLANE, Rona Jane | Sekretär | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158306100001 | |||||||
MCLEISH, William David | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
MURPHY, Charles Furber | Sekretär | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | Chartered Accountant | 69603410001 | |||||
RUTTER, Christopher | Sekretär | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Director | 103588940001 | |||||
SMITH, Peter Anthony | Sekretär | Forge Cottage Forge Lane, Shorne DA12 3DP Gravesend Kent | British | 71842080001 | ||||||
SPEIRS, Lesley Sarah | Sekretär | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | Finance Director | 69112020001 | |||||
ABLETT, Julie | Geschäftsführer | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | Company Director | 57906600001 | |||||
BAKER, Graham | Geschäftsführer | 26 Hazelhurst Road Kings Heath B14 7PJ Birmingham West Midlands | British | Chartered Accountant | 40240710001 | |||||
BALLANTYNE, Thomas Niven | Geschäftsführer | Greystones Milnthorpe Road, Holme LA6 1PX Carnforth Lancashire | England | British | Finance Director | 68970050002 | ||||
BARLOW, George Edward | Geschäftsführer | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | Director | 66559170001 | ||||
BOLOT, Timothy James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 107837080002 | ||||
BRADEEN, Chester Howard | Geschäftsführer | Pipers Cottage Grove Heath Road Ripley GU23 6EU Woking Surrey | American | Health Care Administrator | 51593550001 | |||||
BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 79917240001 | ||||
COLVIN, William | Geschäftsführer | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Director | 51697890003 | ||||
FARMER, Nicholas John | Geschäftsführer | 62 Freshwater Close Great Sankey WA5 3PU Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Director | 124228290001 | ||||
FARRALL, Elaine Ann | Geschäftsführer | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | Director | 14241020001 | |||||
FEENEY, Martin | Geschäftsführer | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | Finance Director | 53915080001 | ||||
FLAHERTY, James Paul | Geschäftsführer | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | Director | 100530310001 | |||||
FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Managing Director | 111188390002 | ||||
GEE, Andrew Anthony Edward | Geschäftsführer | 83a Sutherland Avenue TN16 3HG Biggin Hill Kent | England | British | Director | 93592160001 | ||||
GOSLING, Mark David | Geschäftsführer | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | Director | 66801660002 | |||||
GWATKIN, Peter Frederick Stapleton | Geschäftsführer | Shustoke Hall Moathouse Lane Shustoke Coleshill B46 2RJ Birmingham | British | Company Director | 42082340004 | |||||
HAMILTON, Thomas Banks | Geschäftsführer | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | Company Chairman | 79846610001 | |||||
JAP, Chee Miau | Geschäftsführer | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | Director | 101200680001 | ||||
LAWRENCE, Stephen John | Geschäftsführer | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | Director | 5579020001 | ||||
LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | Director | 144822040001 | ||||
LOUKES, Kenneth Martin | Geschäftsführer | 23 The Chase HA7 3RU Stanmore Middlesex | British | Director | 6945830001 |
Hat EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Erstellt am 23. März 1998 Geliefert am 09. Apr. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The obligations of the company to the chargee in a lease dated 23RD march 1998 | |
Kurze Angaben A deposit of £74,500 (initially) which will during the life of the rent deposit deed be increased as set out in the rent deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. März 1998 Geliefert am 07. Apr. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Inclusive of the l/h interest of the company in and to the "legal charge property" k/a site 5B2, copperfield road thamesmead all fixtures and the proceeds of sale. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 13. Feb. 1996 Geliefert am 14. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Mortgage 8,9 and 10 third avenue sherwood drive nottingham t/n's NT19209 and NT30826 all buildings and other structures any goodwill all olant macinery and items the proceeds of any claims under the insurances by way of assignment the rental sums and by way of floating charge all unattached plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 13. Feb. 1996 Geliefert am 14. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The chestnuts hotel main road rasdcliffe on trent nottinghamshire t/n NT155409 by way of fixed charge all buildings and structures by way of fixed charge any goodwill all plant machinery and other items and the proceeds of any claims under the insurances by way of assignment the rental sums by way of floating charge all unattached plant machinery and chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Dez. 1995 Geliefert am 12. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Aug. 1995 Geliefert am 17. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The properties as detailed in the continuation sheet attached to the form 395 and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Jan. 1995 Geliefert am 07. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H-willow court nursing home being land on the east side of croft lane, cherry willingham, west lindsey lincolnshire t/n-LL88541. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Jan. 1995 Geliefert am 07. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H-white gables nursing home lincoln road skellingthorpe and land at skellingthorpe, north kesteven lincolnshire t/n-LL54775 and LL73989. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Jan. 1995 Geliefert am 07. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H-wood view nursing home being land on the south west side and land and buildings lying to the south west of lincoln road and being 127 lincoln road branston north kesteven lincolnshire t/n-LL91827 and LL93202. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Jan. 1995 Geliefert am 07. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-willow court nursing home being land on east side of croft lane cherry willingham west lindsey lincolneshire t/n-LL88541. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 24. Dez. 1991 Geliefert am 07. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the security documents as defined | |
Kurze Angaben See doc ref M560C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0