OLD GIROVEND LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | OLD GIROVEND LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02277364 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OLD GIROVEND LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich OLD GIROVEND LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Challenge House International Drive GL20 8UQ Tewkesbury Gloucestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OLD GIROVEND LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GIROVEND LIMITED | 17. Dez. 2003 | 17. Dez. 2003 |
| G2 INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED | 23. Mai 2003 | 23. Mai 2003 |
| GIROVEND LIMITED | 04. Feb. 2000 | 04. Feb. 2000 |
| GIROVEND CASHLESS SYSTEMS (UK) LIMITED | 21. Okt. 1997 | 21. Okt. 1997 |
| GIROVEND SYSTEMS LIMITED | 29. Sept. 1988 | 29. Sept. 1988 |
| DINGLEMOOR LIMITED | 14. Juli 1988 | 14. Juli 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OLD GIROVEND LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OLD GIROVEND LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
legacy | 1 Seiten | 652a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 8 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 6 Seiten | MA | ||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed girovend LIMITED\certificate issued on 29/12/08 | 2 Seiten | CERTNM | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 10 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005 | 6 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Wer sind die Geschäftsführer von OLD GIROVEND LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THORINGTON-JONES, Gary, Mr. | Sekretär | 29 Meadowvale Road Lickey End B60 1JY Bromsgrove Worcestershire | British | 85541780001 | ||||||
| THORINGTON-JONES, Gary, Mr. | Geschäftsführer | 29 Meadowvale Road Lickey End B60 1JY Bromsgrove Worcestershire | England | British | 85541780001 | |||||
| WHITELOCK, Noel Keith | Geschäftsführer | 154 Cheltenham Road WR11 2LW Evesham Worcestershire | United Kingdom | British | 14940620001 | |||||
| ALLEN, Matthew Charles | Sekretär | 75 Park Road W4 3EY London | British | 37599910001 | ||||||
| BAILEY, John | Sekretär | Stockton Grange The Village Stockton On The Forest YO3 9UW York North Yorkshire | British | 41823950002 | ||||||
| BANYARD, Alec William James | Sekretär | 17 Hampstead Gardens SS5 5HN Hockley Essex | British | 32189370001 | ||||||
| FIETH, Robin Paul | Sekretär | Timbers Pyrton OX49 5AP Watlington Oxfordshire | British | 49907850002 | ||||||
| GREGSON, Robin Anthony | Sekretär | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | English | 107835250001 | ||||||
| KATZ, Peter David | Sekretär | 20 Tudor Close IG8 0LF Woodford Green Essex | British | 64682050001 | ||||||
| NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Sekretär | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | British | 116252510001 | ||||||
| PECK, Martin David | Sekretär | 30 Crofton Avenue Chiswick W4 3EW London | British | 78149370002 | ||||||
| WELCH, David Michael Geoffrey | Sekretär | Inigo House 29 Bedford Street WC2E 9ED London | British | 43153490002 | ||||||
| WELCH, David Michael Geoffrey | Sekretär | 7 Southampton Place WC1A 2DR London | British | 43153490001 | ||||||
| BARNSLEY, Micheal John | Geschäftsführer | Church Lane Marchington ST14 8LJ Uttoxeter Buttyard Croft Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 140579250001 | |||||
| BUTT, Hanz Helmuth | Geschäftsführer | Schluchtblick 14 Johannesberg 63867 South Africa | German | 68163180001 | ||||||
| CAMPBELL, Sylvia | Geschäftsführer | 18 Forth Place NE1 4EU Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 53211510001 | |||||
| DITCHBURN, John Blackett Dennison | Geschäftsführer | The Laurels Frieth RG9 6PJ Henley On Thames Oxfordshire | British | 61233990002 | ||||||
| DRUDY, Carmel Ann | Geschäftsführer | 15 Cinnamon Row Battersea SW11 3TW London | British | 40928410001 | ||||||
| FIETH, Robin Paul | Geschäftsführer | Timbers Pyrton OX49 5AP Watlington Oxfordshire | England | British | 49907850002 | |||||
| GAHAGNON, Jacques Andre | Geschäftsführer | 92 Place Louvois Velizy 78140 France | French | 68163380001 | ||||||
| GOVETT, Nigel Jeremy Cloudesley | Geschäftsführer | 15 Tantallon Court Woodstone Village DH4 6TJ Houghton Le Spring County Durham | British | 89929500001 | ||||||
| GREGSON, Robin Anthony | Geschäftsführer | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | England | English | 107835250001 | |||||
| HARRIS, Glyn | Geschäftsführer | 113-116 Bute Street CF1 6SB Cardiff South Glamorgan | British | 8555610002 | ||||||
| MCGRANE, Paul Steven | Geschäftsführer | 21 Stony Lane NR10 4QS Reepham Norwich | United Kingdom | British | 51004210002 | |||||
| MCNAIR, Iain | Geschäftsführer | 23 Mycenae Road SE3 7SF London Greater London | British | 85499250001 | ||||||
| MILLS, Mark Richard | Geschäftsführer | 55 Hove Road FY8 1XH Lytham St Annes Lancashire | British | 10402540005 | ||||||
| MORINAY, Luc Jean Marie | Geschäftsführer | 14 Rue De Tramelay Elancourt 78990 France | French | 68163140001 | ||||||
| NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Geschäftsführer | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | England | British | 116252510001 | |||||
| NWOSU HOPE, Nigel Peter | Geschäftsführer | Lakewood Minsteracres DH8 9RR Consett County Durham | British | 64095750001 | ||||||
| PERKINS, Dennis | Geschäftsführer | 18 Spring Grove HR8 2XB Ledbury Herefordshire | United Kingdom | British | 44490630001 | |||||
| RICHARDS, Keith | Geschäftsführer | 43 Malford Grove Gilwern NP7 0RN Abergavenny Gwent | British | 25612680001 | ||||||
| SARGENT, Christian William Lance | Geschäftsführer | 26 Cheriton Drive Thornhill CF14 9DF Cardiff South Glamorgan | British | 68162920001 | ||||||
| SCHOFIELD, Janet Elizabeth | Geschäftsführer | 43 Florence Road Wimbledon SW19 8TH London | British | 36356290002 | ||||||
| SMART, Richard Ernest | Geschäftsführer | Oak House,Webbs Lane Beenham RG7 5LL Reading Berkshire | British | 7970090001 | ||||||
| SMYTH, Peter Francis | Geschäftsführer | Flat 2 62 Queens Gate SW7 5JP London | Irish | 63863190002 |
Hat OLD GIROVEND LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 30. Apr. 2003 Geliefert am 03. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies (including interest accrued thereto) standing to the credit of the account to be opened in a UK clearing bank to be operated solely by the chargee or its solicitors in which the sum of fifteen thousand two hundred and thirty nine pounds has been deposited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Feb. 1997 Geliefert am 11. März 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All f/h and l/h land in england and wales including (but not limited to) the property at unit 6 (formerly unit B4) progress business centre,whittle parkway,bath road,slough t/no.bk 266697. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Sept. 1996 Geliefert am 19. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 09. März 1992 Geliefert am 13. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0