A.R.B. AUDIO & VISUAL HIRE LIMITED

A.R.B. AUDIO & VISUAL HIRE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameA.R.B. AUDIO & VISUAL HIRE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02277575
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von A.R.B. AUDIO & VISUAL HIRE LIMITED?

    • (9305) /

    Wo befindet sich A.R.B. AUDIO & VISUAL HIRE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von A.R.B. AUDIO & VISUAL HIRE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DAREKEY LIMITED15. Juli 198815. Juli 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von A.R.B. AUDIO & VISUAL HIRE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für A.R.B. AUDIO & VISUAL HIRE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Juni 2011

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 17. Juni 2011

    17 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Jan. 2011

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Beendigung der Bestellung von Michael Newton als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Juli 2010

    18 Seiten2.24B

    Vorschlag des Verwalters

    26 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Robbins Building Albert Street Rugby Warwickshire CV21 2SD am 15. Jan. 2010

    1 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2005

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    Wer sind die Geschäftsführer von A.R.B. AUDIO & VISUAL HIRE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    THOMPSON, Eleanor
    17 Statham Place
    Oldbrook
    MK6 2HB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    17 Statham Place
    Oldbrook
    MK6 2HB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant126618990001
    BOOTE, Robert Allen
    Coton Cottage
    Chacombe
    OX17 2JX Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Coton Cottage
    Chacombe
    OX17 2JX Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector5662430002
    BOOTE, Gillian
    Coton Cottage
    Chacombe
    OX17 2JX Banbury
    Oxfordshire
    Sekretär
    Coton Cottage
    Chacombe
    OX17 2JX Banbury
    Oxfordshire
    British5662420002
    ELKINS, Timothy Charles
    Mayfield 1 Manor Close
    Charwelton
    NN11 3YQ Daventry
    Northamptonshire
    Sekretär
    Mayfield 1 Manor Close
    Charwelton
    NN11 3YQ Daventry
    Northamptonshire
    British52462120001
    JONES, Adrian Martin Stuart
    69 Westwood Drive
    HP6 6RR Little Chalfont
    Buckinghamshire
    Sekretär
    69 Westwood Drive
    HP6 6RR Little Chalfont
    Buckinghamshire
    BritishChartered Certified Accountant79293310001
    NEWTON, Michael
    Middle Farm
    Newbold Grounds, Staverton
    NN11 6JZ Daventry
    Northamptonshire
    Sekretär
    Middle Farm
    Newbold Grounds, Staverton
    NN11 6JZ Daventry
    Northamptonshire
    British31046920003
    WALKER, Graeme Robert
    4 Fairmile Court
    Fairmile
    RG9 2JP Henley On Thames
    Oxfordshire
    Sekretär
    4 Fairmile Court
    Fairmile
    RG9 2JP Henley On Thames
    Oxfordshire
    British95439420001
    WEBB, Jill
    19 Cave Close
    Cawston Grange
    CV22 7GL Rugby
    Warwickshire
    Sekretär
    19 Cave Close
    Cawston Grange
    CV22 7GL Rugby
    Warwickshire
    British81897980002
    BOOTE, Robert Allen
    Coton Cottage
    Chacombe
    OX17 2JX Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Coton Cottage
    Chacombe
    OX17 2JX Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishEngineer5662430002
    BOOTT, Peter Francis
    1 Rudge Close
    Wollaton
    NG8 1HF Nottingham
    Geschäftsführer
    1 Rudge Close
    Wollaton
    NG8 1HF Nottingham
    EnglandBritishDirector285492220001
    BROOKS WARD, Nicholas Owen
    48 Saffron Close
    RG24 8XQ Chineham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    48 Saffron Close
    RG24 8XQ Chineham
    Hampshire
    BritishDirector112420230001
    FRANCIS, John Leslie
    Lower Frankfield
    Sevenoaks Road
    TN15 0HB Seal Chart
    Sevenoaks
    Geschäftsführer
    Lower Frankfield
    Sevenoaks Road
    TN15 0HB Seal Chart
    Sevenoaks
    United KingdomBritishDirector9263170003
    GARDINER, Paul Robert
    21 Manor Close
    MK17 9DJ Stoke Hammond
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    21 Manor Close
    MK17 9DJ Stoke Hammond
    Buckinghamshire
    BritishOperations Director84565000001
    GIBSON, David
    Woodcote
    Christmas Common
    OX49 5HL Watlington
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Woodcote
    Christmas Common
    OX49 5HL Watlington
    Oxfordshire
    BritishDirector89527820001
    HILL, Julian Peter Dunlop
    Dawslea Barn
    Hollist Lane
    GU29 9AD Midhurst
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Dawslea Barn
    Hollist Lane
    GU29 9AD Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritishFinance Director892150002
    JONES, Adrian Martin Stuart
    69 Westwood Drive
    HP6 6RR Little Chalfont
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    69 Westwood Drive
    HP6 6RR Little Chalfont
    Buckinghamshire
    BritishChartered Certified Accountant79293310001
    NEWTON, Michael
    Middle Farm
    Newbold Grounds, Staverton
    NN11 6JZ Daventry
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Middle Farm
    Newbold Grounds, Staverton
    NN11 6JZ Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritishEngineer31046920003
    WALKER, Graeme Robert
    4 Fairmile Court
    Fairmile
    RG9 2JP Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    4 Fairmile Court
    Fairmile
    RG9 2JP Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishDirector95439420001

    Hat A.R.B. AUDIO & VISUAL HIRE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 26. März 2004
    Geliefert am 27. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Euro Sales Finance PLC
    Transaktionen
    • 27. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Jan. 2004
    Geliefert am 24. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 26. Feb. 2003
    Geliefert am 04. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Business premium account account number 90276995. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 26. Nov. 2001
    Geliefert am 27. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Okt. 2000
    Geliefert am 18. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 06. Jan. 1999
    Geliefert am 08. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Nov. 1997
    Geliefert am 02. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 22. Okt. 1991
    Geliefert am 31. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all goodwill & uncalled capital for the time being of the company (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 15. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 21. Okt. 1988
    Geliefert am 28. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excludng those mentioned above) uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 15. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 1988
    Geliefert am 29. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from THE2OMPANY to the chargee under the terms of an agreement dated 26/7/88
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all (see form 395 for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Menvier-Swain Group Services LTD
    Transaktionen
    • 29. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 30. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat A.R.B. AUDIO & VISUAL HIRE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. Jan. 2010Beginn der Verwaltung
    17. Juni 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Andrew Stephen Mcgill
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0