EUROSIGNS (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EUROSIGNS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02283390 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EUROSIGNS (UK) LIMITED?
- Bau von Straßen und Autobahnen (42110) / Bauwesen
Wo befindet sich EUROSIGNS (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Riverside House Irwell Street M3 5EN Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EUROSIGNS (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RINGWAY SIGNS LIMITED | 27. Okt. 1988 | 27. Okt. 1988 |
| CORINFIELD LIMITED | 03. Aug. 1988 | 03. Aug. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EUROSIGNS (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EUROSIGNS (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 31 Seiten | AM23 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 31 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 28 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters | 3 Seiten | AM11 | ||
Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt | 11 Seiten | AM16 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Tower 12 18-22 Bridge Street Spinningfields Manchester M3 3BZ zum Riverside House Irwell Street Manchester M3 5EN am 02. Jan. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 30 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 32 Seiten | AM10 | ||
Beendigung der Bestellung von Demis Armen Ohandjanian als Geschäftsführer am 22. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Demis Armen Ohandjanian als Direktor am 22. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 3 Seiten | AM06 | ||
Vorschlag des Verwalters | 45 Seiten | AM03 | ||
Beendigung der Bestellung von Chris Napier als Geschäftsführer am 29. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Winterstoke Road Weston-Super-Mare Somerset BS24 9BQ United Kingdom zum Tower 12 18-22 Bridge Street Spinningfields Manchester M3 3BZ am 10. Dez. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||
Beendigung der Bestellung von David Anthony Myles als Geschäftsführer am 23. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Erfüllung der Belastung 022833900005 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Eintragung der Belastung 022833900005, erstellt am 17. Sept. 2018 | 27 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 022833900004, erstellt am 14. Sept. 2018 | 25 Seiten | MR01 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2018 bis 31. März 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||
Change of details for Timec Group Limited as a person with significant control on 26. Feb. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||
Kapitalaufstellung am 26. Juli 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von EUROSIGNS (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYSIONEK, Susan Mary | Sekretär | Albion House Springfield Road RH12 2RW Horsham West Sussex | British | 78777420001 | ||||||
| NORTON, Peter John | Sekretär | Acorn Lodge Old Brighton Road RH11 9AJ Pease Pottage West Sussex | British | 2386180002 | ||||||
| WITHERS, Robin William | Sekretär | 19 Woodmancourt GU7 2BT Godalming Surrey | British | 9465040003 | ||||||
| ATKINSON, Dixon John | Geschäftsführer | The Captains House 41 Fedden Village Nore Road BS20 8EJ Portishead Somerset | British | 38942560001 | ||||||
| BATUT, Gregoire Claude Albert | Geschäftsführer | Albion House Springfield Road RH12 2RW Horsham West Sussex | England | French | 162291590002 | |||||
| CROSS, Eric Robert Ian | Geschäftsführer | The Coach House The Green Shamley Green GU5 0UA Guildford Surrey | England | British | 94282240001 | |||||
| FORSTER, Lindsay | Geschäftsführer | Grange Paddock Mark TA9 4RW Nr Highbridge 22 Somerster Uk | British | 137387850001 | ||||||
| GIROD, Claude | Geschäftsführer | Albion House Springfield Road RH12 2RW Horsham West Sussex | France | French | 161338090001 | |||||
| GIROD, Philippe, Monsieur | Geschäftsführer | Belle Fontaine FOREIGN Morez 39400 France | France | French | 29409290001 | |||||
| GIROD, Signaux | Geschäftsführer | Bellefontaine Morez 39400 France | France | French | 29409300002 | |||||
| GREGG, Richard | Geschäftsführer | 10 Middlecroft CH3 7HF Guilden Sutton Cheshire | United Kingdom | British | 148915490001 | |||||
| LEE, David | Geschäftsführer | 9 Halyards Ferry Road Topsham EX3 0JT Exeter Devon | United Kingdom | British | 50707250001 | |||||
| LUNDY, David Jonathan | Geschäftsführer | 5 Churchward Road Worle BS22 0YX Weston Super Mare Avon | British | 75524660001 | ||||||
| MYLES, David Anthony | Geschäftsführer | Weston-Super-Mare BS24 9BQ Somerset Winterstoke Road United Kingdom | England | British | 196253820001 | |||||
| NAPIER, Chris | Geschäftsführer | 18-22 Bridge Street Spinningfields M3 3BZ Manchester Tower 12 | United Kingdom | British | 243426830001 | |||||
| NEWLAND, Alan Henry | Geschäftsführer | 21 Ocean Drive Ferring BN12 5QN Worthing West Sussex | British | 21567800001 | ||||||
| NORTON, Peter John | Geschäftsführer | Acorn Lodge Old Brighton Road RH11 9AJ Pease Pottage West Sussex | British | 2386180002 | ||||||
| OHANDJANIAN, Demis Armen | Geschäftsführer | The Mill Lane Glenfield LE3 8DX Leicester C/O Gssl Mill Lane Industrial Estate, England | United Kingdom | British | 118283730007 | |||||
| OHANDJANIAN, Demis Armen | Geschäftsführer | Mill Lane Industrial Estate LE3 8DX Glenfield C/O Glenfield Storage Solutions Limited Leicester United Kingdom | United Kingdom | British | 118283730007 | |||||
| PENNOCK, Roger James | Geschäftsführer | Bashurst Copse RH13 0NZ Itchingfield Wildacres West Sussex | United Kingdom | British | 138095250001 | |||||
| ROBERTS, Peter | Geschäftsführer | TA5 1JB Over Stowey Pear Tree Farm Somerset | British | 136572690001 | ||||||
| SULLIOT, Patrick | Geschäftsführer | Albion House Springfield Road RH12 2RW Horsham West Sussex | Uk | French | 120511630003 | |||||
| WARDROP, Scott Alexander | Geschäftsführer | Albion House Springfield Road RH12 2RW Horsham West Sussex | England | British | 60380650003 | |||||
| WILLIS, Simon Lloyd | Geschäftsführer | Springfield Road RH12 2RW Horsham Albion House West Sussex England | England | English | 117465520002 | |||||
| WITHERS, Robin William | Geschäftsführer | 19 Woodmancourt GU7 2BT Godalming Surrey | British | 9465040003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EUROSIGNS (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurosigns Holdings Limited | 14. Feb. 2018 | Winterstoke Road BS24 9BQ Weston-Super-Mare Eurosigns (Uk) Limited England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Eurovia Uk Limited | 24. Dez. 2016 | Springfield Road RH12 2RW Horsham Albion House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EUROSIGNS (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 17. Sept. 2018 Geliefert am 24. Sept. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung By way of first legal mortgage, all land (as defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01 ).. in the debenture “land” means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant’s fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 14. Sept. 2018 Geliefert am 21. Sept. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung By way of first legal mortgage, all land (as defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01 ).. in the debenture “land” means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant’s fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 23. Feb. 1993 Geliefert am 25. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that land and premises at old mixon winterstoke rd,weston super mare,avon............and the proceeds of sale thereof; goodwill of business................see company's microfiche for details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 31. Mai 1990 Geliefert am 12. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a: plot 25 warne road winterstoke commercial estate weston super mare avon and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 28. Nov. 1988 Geliefert am 02. Dez. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat EUROSIGNS (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0