BJC (HEATHROW) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BJC (HEATHROW) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02283763 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BJC (HEATHROW) LIMITED?
- (7011) /
- (7499) /
Wo befindet sich BJC (HEATHROW) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hanson House 14 Castle Hill SL6 4JJ Maidenhead |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BJC (HEATHROW) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| YORKGLADE LIMITED | 03. Aug. 1988 | 03. Aug. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BJC (HEATHROW) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BJC (HEATHROW) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Feb. 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Gimmler als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Robert Gimmler am 01. Sept. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BJC (HEATHROW) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYSON, Roger Thomas Virley | Sekretär | 2 Gadd Close RG40 5PQ Wokingham Berkshire | British | 113777700001 | ||||||
| GRETTON, Edward Alexander | Geschäftsführer | West Bradford BB7 4SN Clitheroe Old Hall Lancashire | England | British | 130888540001 | |||||
| GUYATT, Benjamin John | Geschäftsführer | Normandy Road Wroughton SN4 0UJ Swindon 9 Wiltshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131516210001 | |||||
| LECLERCQ, Christian | Geschäftsführer | Court Drive SL6 8LX Maidenhead 2 Berkshire United Kingdom | England | Belgian | 130757120001 | |||||
| DRANSFIELD, Graham | Sekretär | Downs Hill BR3 5HB Beckenham 18 Kent | British | 4655640001 | ||||||
| KIPPEN, Michael Leslie | Sekretär | Flat 19a 42 Pulteney Street BA2 4DR Bath | British | 12230900001 | ||||||
| ROSSITER, Brian Edward | Sekretär | 26 Oakdale Court Downend BS16 6DZ Bristol South Gloucestershire | British | 11314290001 | ||||||
| TUNNACLIFFE, Paul Derek | Sekretär | 6 Ashburnham Park KT10 9TW Esher Surrey | British | 127202460001 | ||||||
| ABLETT, Malcolm James | Geschäftsführer | Country Place Fir Tree Hill Chandlers Cross WD3 4LZ Sarratt Hertfordshire | England | British | 6258350001 | |||||
| BOLTER, Andrew Christopher | Geschäftsführer | 110 North View Road Crouch End N8 7LP London | British | 90294620001 | ||||||
| COMBA, Alexander Michael | Geschäftsführer | 136 Andrewes House Barbican EC2Y 8BA London | England | British | 5466420005 | |||||
| COULSON, Ruth | Geschäftsführer | Flat 4 14 Steeles Road NW3 4SE London | Australian | 109716390001 | ||||||
| DRANSFIELD, Graham | Geschäftsführer | Downs Hill BR3 5HB Beckenham 18 Kent | England | British | 4655640001 | |||||
| EGAN, David John | Geschäftsführer | Valley Road WD3 4BJ Rickmansworth 70 Hertfordshire | United Kingdom | British | 324778100001 | |||||
| GIMMLER, Richard Robert | Geschäftsführer | Church Walk Ashton Keynes SN6 6PB Swindon Glebe House Wiltshire | England | British | 131676390004 | |||||
| HURRELL, Samantha Jane | Geschäftsführer | Saffron Wharf, 20 Shad Thames SE1 2YQ London | British | 68385620001 | ||||||
| LUDLAM, Kenneth John | Geschäftsführer | Longwood House 12a Mavelstone Close BR1 2PJ Bromley Kent | United Kingdom | British | 3893370002 | |||||
| NICHOLSON, Paul William | Geschäftsführer | Hammerfield Cansiron Lane RH19 3SE Ashurst Wood West Sussex | British | 10544180001 | ||||||
| READ, Justin Richard | Geschäftsführer | 46b Saint Georges Drive SW1V 4BT London | England | British | 67023680001 | |||||
| SWIFT, Nicholas | Geschäftsführer | 34 The Grove AL9 7RN Brookmans Park Hertfordshire | United Kingdom | British | 90315200001 | |||||
| TURNER, Peter John | Geschäftsführer | 75 Carlton Hill St Johns Wood NW8 0EN London | British | 2901130001 |
Hat BJC (HEATHROW) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Erstellt am 16. Jan. 1990 Geliefert am 17. Jan. 1990 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from bjc (heathrow) limited to the sumitoms bank limited as agent (as defined) and to the banks (as defined) pursuant to the loan agreement dated 22/12/89 and the security documents (as defined) | |
Kurze Angaben (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 30. Mai 1989 Geliefert am 05. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and trustee for the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 25.5.89 and the security documents (as defined) | |
Kurze Angaben (Please see doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 18. Jan. 1989 Geliefert am 23. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the letter dated 16/1/89 and/or in connection with the facility granted and this mortgage debenture | |
Kurze Angaben F/H property k/a land to the north of bath road harlington T.no. Agl 658 floating charge over the undertaking & all other property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0