GERRARD (OMH) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GERRARD (OMH) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02284499 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GERRARD (OMH) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich GERRARD (OMH) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GERRARD (OMH) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| OLD MUTUAL HOLDINGS LIMITED | 11. Nov. 2002 | 11. Nov. 2002 |
| OLD MUTUAL SECURITIES LIMITED | 01. Juni 2000 | 01. Juni 2000 |
| ALBERT E SHARP LIMITED | 01. Jan. 1995 | 01. Jan. 1995 |
| ALBERT E. SHARP & CO. | 05. Aug. 1988 | 05. Aug. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GERRARD (OMH) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GERRARD (OMH) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Churchill Place London E14 5HP zum Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR am 27. Feb. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. Feb. 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Dr Philip Andrew Frank Byle als Direktor am 19. Juni 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mark Andrew Richards als Direktor am 19. Juni 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas John Garnett als Geschäftsführer am 22. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Richard Henry Philipps als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Currie als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GERRARD (OMH) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCOSEC LIMITED | Sekretär | 1 Churchill Place E14 5HP London | 49004930002 | |||||||
| BYLE, Philip Andrew Frank, Dr. | Geschäftsführer | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 175463080001 | |||||
| PHILIPPS, Richard Henry | Geschäftsführer | Churchill Place E14 5HP London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 178406100001 | |||||
| RICHARDS, Mark Andrew | Geschäftsführer | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 182116990001 | |||||
| FISHER, Peter Blake | Sekretär | Old Ridgeway Cottage Crown Lane Wychbold WR9 0BX Droitwich Worcestershire | British | 25278500001 | ||||||
| HILL, Edwina Anne | Sekretär | 27 Bishops Meadow Weeford Road B75 5PQ Sutton Coldfield West Midlands | British | 44399680002 | ||||||
| MAYOR, Sukesh Chander | Sekretär | 62 Herbert Road Emerson Park RM11 3LL Hornchurch Essex | British | 72392270001 | ||||||
| SLOCOMBE, Stephen Roy | Sekretär | 92 Stratton Drive IG11 9HD Barking Essex | British | 55097590002 | ||||||
| SMELLIE, Keith Graham | Sekretär | South Lawn CV35 7AA Rowington Warwick | British | 97352560001 | ||||||
| SUTTON, Ian Nicholas | Sekretär | 83a Hervey Road Blackheath SE3 8BX London | British | 37516040002 | ||||||
| TELFER, Miranda Lauraine | Sekretär | Lingfield House East Grinstead RH7 6ES Lingfield | British | 80083220001 | ||||||
| AIREY, Christopher Jonathan | Geschäftsführer | Little Newarks Newarks Road Good Easter CM1 4SA Chelmsford Essex | British | 45740380001 | ||||||
| ANSTEE, Eric Edward | Geschäftsführer | Whitethorns Weydown Road GU27 1DS Haslemere Surrey | United Kingdom | British | 76479900001 | |||||
| ATKINSON, Kevin Derek | Geschäftsführer | Stanage Roslyn Road, Wellington TF1 3AX Telford Shropshire | England | British | 97538420001 | |||||
| AUSTIN, Richard Graham Gosset | Geschäftsführer | Olde Timbers Pumphouse Lane Hanbury B60 4BX Bromsgrove Worcestershire | British | 3533270001 | ||||||
| BARON, Rupert Nigel Kendall | Geschäftsführer | 2 Rectory Road SW13 0DT London | British | 30084840002 | ||||||
| BARRELL, Alexander Conan | Geschäftsführer | Skinners Hill Cottage Eyford Park Upper Slaughter GL54 2JN Cheltenham Gloucestershire | British | 59253480001 | ||||||
| BARRETT, Del Amanda, Dr | Geschäftsführer | 102a Marlborough 61 Walton Street SW3 2JY London | England | British | 39721540001 | |||||
| BAWDEN, Derek Charles | Geschäftsführer | The Cottage 65 Water Lane NN4 6HH Wootton Northampton | British | 59367250001 | ||||||
| BENNETT, Timothy Michael Roth | Geschäftsführer | 62 Sir Johns Road B29 7ER Selly Park Birmingham | British | 70298090001 | ||||||
| BERNAYS, Richard Oliver | Geschäftsführer | 82 Elgin Crescent W11 2JL London | United Kingdom | British | 98729980001 | |||||
| BLATCHLY, Christopher Nigel | Geschäftsführer | Old Comptons Comptons Lane RH13 6DP Horsham West Sussex | British | 26871210002 | ||||||
| BLOUNT, Christopher | Geschäftsführer | Cornerways The Green, Leafield OX29 9NP Witney Oxfordshire | England | British | 89344930001 | |||||
| BOGLE, Robert Oswald | Geschäftsführer | 31 Foley Road East Streetly B74 3HP Sutton Coldfield West Midlands | British | 6832140001 | ||||||
| BOLSOVER, Michael Timothy | Geschäftsführer | Wakehurst Limes Close Bramshott GU30 7SL Liphook Hampshire | England | British | 104281460001 | |||||
| BROCKLEBANK, Roger James | Geschäftsführer | Nursery Cottage Bull Hill Lane Astley Burf DY13 0SE Stourport On Severn Worcestershire | British | 44399140001 | ||||||
| CAMPBELL, Gordon Edward | Geschäftsführer | 34 Inchford Road B92 9QD Solihull West Midlands | British | 6832150001 | ||||||
| CAMPBELL, Neil | Geschäftsführer | Forge Cottage Street End BS40 7TL Blaydon Bristol | United Kingdom | British | 59407690001 | |||||
| CAMPBELL, Norman Hunter | Geschäftsführer | 31 Montgomery Street G76 0AS Eaglesham | Scotland | British | 10030001 | |||||
| CASHDAN, David | Geschäftsführer | 11 Walsingham St Johns Wood Park NW8 6RG London | British | 34609460001 | ||||||
| CASSIE, John | Geschäftsführer | 12 Barn Road Handsacre WS15 4TA Rugeley Staffordshire | British | 85363490001 | ||||||
| CONDER, Simon Andrew | Geschäftsführer | Elizabeth Dane 5c Burnt Ash Lane BR1 4DJ Bromley Kent | United Kingdom | British | 87427400001 | |||||
| COOKE, Trevor Charles | Geschäftsführer | Clifton Cottage Cliftons Lane RH2 9RA Reigate Surrey | United Kingdom | British | 141581640001 | |||||
| CULL, Graeme Frank | Geschäftsführer | Strathbeg 6 Park Road GU22 7BW Woking Surrey | British | 62391710001 | ||||||
| CURRIE, David Mclean | Geschäftsführer | Churchill Place E14 5HP London 1 England | Scotland | British | 136790250001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GERRARD (OMH) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrard Management Services Limited | 06. Apr. 2016 | Churchill Place E14 5HP London 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat GERRARD (OMH) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security deed | Erstellt am 26. Juni 2000 Geliefert am 05. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred by the company to the chargee (whether solely or jointly or jointly or severally with another or others and whether as principal or surely and whether actual or contingent present and future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsover and including without limitation, any such debts, obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined in the security deed) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible account see ch microfiche for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security deed | Erstellt am 01. Feb. 2000 Geliefert am 15. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including, without limitation, in connection with the facility agreement; any assured payment by the chargee; or any transfer of stock to the company by means of crest; or any agreement to transfer stock to the company by means of crest; or any issue of stock to the company by means of crest | |
Kurze Angaben First fixed charge all sums and payments hereafter receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of, or any agreement to transfer or debit stock for any eligible stock account of or in the name of or otherwise referable to the company in crest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 23. Juli 1998 Geliefert am 03. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from albert e sharp holdings PLC to the chargee on any account whatsoever provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon | |
Kurze Angaben 30802964. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 13. Apr. 1993 Geliefert am 20. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All shares stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment | Erstellt am 09. Juli 1992 Geliefert am 16. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys due or owing due as specified in the guarantee dated 9TH july 1992 see form 395 ref. M249C for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GERRARD (OMH) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0