RIPPLE EFFECT INTERNATIONAL
Überblick
| Unternehmensname | RIPPLE EFFECT INTERNATIONAL |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited' |
| Unternehmensnummer | 02290024 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RIPPLE EFFECT INTERNATIONAL?
- Dienstleistungen für den Pflanzenanbau (01610) / Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei
- Dienstleistungen für die Tierhaltung (außer Unterbringung und Pflege von Nutztieren) a.n.g. (01629) / Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei
- Bildungsunterstützende Dienstleistungen (85600) / Erziehung
Wo befindet sich RIPPLE EFFECT INTERNATIONAL?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Runway East / Kings Court Parsonage Lane BA1 1ER Bath England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RIPPLE EFFECT INTERNATIONAL?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SEND A COW | 19. Feb. 2007 | 19. Feb. 2007 |
| SENDACOW STOCKAID LTD | 10. Juni 1999 | 10. Juni 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RIPPLE EFFECT INTERNATIONAL?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Juni 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. März 2027 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für RIPPLE EFFECT INTERNATIONAL?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 31. Okt. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 14. Nov. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 31. Okt. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für RIPPLE EFFECT INTERNATIONAL?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | Seiten | GAZ1 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2025 | 44 Seiten | AA | ||
Ernennung von Ms Lois Muraguri als Direktor am 12. Dez. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Old Estate Yard Newton St Loe Bath BA2 9BR zum Runway East / Kings Court Parsonage Lane Bath BA1 1ER am 27. Juni 2025 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Alison Jane Griffith als Geschäftsführer am 12. Dez. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Simon Doherty als Geschäftsführer am 12. Dez. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephanie Dennison als Geschäftsführer am 12. Dez. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2024 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2024 | 43 Seiten | AA | ||
Ernennung von Prina Rasikbhai Patel als Sekretär am 04. März 2024 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Prina Rasikbhai Patel als Direktor am 04. März 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Karthikeyan Dasari Chinna als Direktor am 04. März 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Timothy David Passey als Direktor am 04. März 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mrs Shallin Farai Chikoto als Direktor am 04. März 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2023 | 45 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Fiona Crisp als Geschäftsführer am 14. Dez. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von David Nathan Tendai Kuwana als Geschäftsführer am 24. Okt. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Notification of Peter Jeffries as a person with significant control on 24. März 2023 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Cessation of John Geake as a person with significant control on 24. März 2023 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter John Jeffries am 24. März 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Geake als Geschäftsführer am 24. März 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Peter John Jeffries als Direktor am 24. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von RIPPLE EFFECT INTERNATIONAL?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATEL, Prina Rasikbhai | Sekretär | Parsonage Lane BA1 1ER Bath Runway East / Kings Court England | 320687670001 | |||||||
| BRUNWIN, Elizabeth Sarah | Geschäftsführer | Parsonage Lane BA1 1ER Bath Runway East / Kings Court England | England | British | 272405900001 | |||||
| CHIKOTO, Shallin Farai | Geschäftsführer | Parsonage Lane BA1 1ER Bath Runway East / Kings Court England | England | British | 314467230001 | |||||
| DASARI CHINNA, Karthikeyan | Geschäftsführer | Parsonage Lane BA1 1ER Bath Runway East / Kings Court England | United Kingdom | British | 157749270001 | |||||
| GILL, Simon Robert | Geschäftsführer | Parsonage Lane BA1 1ER Bath Runway East / Kings Court England | Scotland | British | 196687780003 | |||||
| GILLAM, Andrew John | Geschäftsführer | Parsonage Lane BA1 1ER Bath Runway East / Kings Court England | United Kingdom | British | 255316700001 | |||||
| JEFFRIES, Peter John, Doctor | Geschäftsführer | The Old Estate Yard Newton St Loe BA2 9BR Bath | Scotland | British | 187478900003 | |||||
| MURAGURI, Lois | Geschäftsführer | Parsonage Lane BA1 1ER Bath Runway East / Kings Court England | Scotland | British | 342579590001 | |||||
| NAPIER, Patricia Gray | Geschäftsführer | Parsonage Lane BA1 1ER Bath Runway East / Kings Court England | United Kingdom | British | 292572730001 | |||||
| PASSEY, Timothy David | Geschäftsführer | Parsonage Lane BA1 1ER Bath Runway East / Kings Court England | England | British | 320680960001 | |||||
| PATEL, Prina Rasikbhai | Geschäftsführer | Parsonage Lane BA1 1ER Bath Runway East / Kings Court England | United Kingdom | British | 320687490001 | |||||
| ADDICOTT, Gerald | Sekretär | Corston Fields Farm Corston BA2 9EZ Bath Avon | British | 16894420001 | ||||||
| BOWMAN, Edred Nigel | Sekretär | 22 Saint Andrews View Fontmell Magna SP7 0QY Shaftesbury Dorset | British | 88735940001 | ||||||
| HEMMING, Jennifer Ann | Sekretär | 20 Grange Park Henleaze BS9 4BP Bristol | British | 86021880002 | ||||||
| LONGMAN, John Frederick Knight | Sekretär | Ditcheat Hill Farm Ditcheat BA4 6TL Shepton Mallet Somerset | British | 15032970001 | ||||||
| SUDBURY, Katrina Anne Pennant | Sekretär | Spa House Middle Hill Box SN14 9QS Corsham Wiltshire | British | 24327090001 | ||||||
| ADDICOTT, Rosaline Christine May | Geschäftsführer | Corston Fields Farm Corston BA2 9EZ Bath Bath & North East Somerset | British | 78430770001 | ||||||
| ALFORD, Gerald | Geschäftsführer | Parkleigh Silverton EX5 4DD Exeter Devon | British | 16894440001 | ||||||
| BLACKWELL, Alison Clare | Geschäftsführer | The Old Estate Yard Newton St Loe BA2 9BR Bath | England | British | 86021740003 | |||||
| BOWMAN, Edred Nigel | Geschäftsführer | 22 Saint Andrews View Fontmell Magna SP7 0QY Shaftesbury Dorset | British | 88735940001 | ||||||
| BRAGG, David | Geschäftsführer | Kelland Barton Lapford EX17 6AG Crediton Devon | British | 16894500001 | ||||||
| BUSH, Anthony James | Geschäftsführer | Moat House Farm Failand Road Wraxall BS19 1PG Bristol Avon | British | 46112400001 | ||||||
| CLARKE, Kenneth Ian Howard | Geschäftsführer | Cleevehead Cross BS25 2EG Axbridge Somerset | British | 36766200001 | ||||||
| COSSTICK, Ann Victoria | Geschäftsführer | 43 Marius Road SW17 7QU London | England | British | 117977120001 | |||||
| CRACKNELL, Theodore John | Geschäftsführer | Withymoor Farm Kilcot GL18 1PG Newent Gloucestershire | United Kingdom | British | 26595400001 | |||||
| CRISP, Fiona | Geschäftsführer | The Old Estate Yard Newton St Loe BA2 9BR Bath | England | British | 204659060001 | |||||
| DARCH, Kenneth | Geschäftsführer | Sidbrook Farm Greenway Monkton Heathfield TA2 8NH Taunton Som | British | 16894520001 | ||||||
| DENNISON, Stephanie | Geschäftsführer | The Old Estate Yard Newton St Loe BA2 9BR Bath | England | Australian | 204659480001 | |||||
| DOHERTY, Simon | Geschäftsführer | The Old Estate Yard Newton St Loe BA2 9BR Bath | Northern Ireland | British | 198848110001 | |||||
| EGITTO, Christopher Joseph Alessandro | Geschäftsführer | Harrowdene Road BS4 2JJ Bristol 72 England | England | British | 148600620001 | |||||
| ELLIOT, Timothy David | Geschäftsführer | Newton St Loe BA2 9BR Bath The Old Estate Yard Somerset | England | British | 35563970002 | |||||
| FRIEND, Andrew Ernest | Geschäftsführer | Bradbury Barton EX37 9RE Chittlehampton Devon | England | British | 223641630001 | |||||
| GEAKE, John | Geschäftsführer | BA2 9BR Newton St Loe The Old Estate Yard Bath United Kingdom | Austria | British | 194261820001 | |||||
| GLASGOW, Ian Harvey | Geschäftsführer | The Old Vicarage Winsley BA15 2LP Bradford On Avon Wiltshire | British | 48686560001 | ||||||
| GRIFFITH, Alison Jane | Geschäftsführer | The Old Estate Yard Newton St Loe BA2 9BR Bath | England | British | 266650810001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RIPPLE EFFECT INTERNATIONAL?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Doctor Peter John Jeffries | 24. März 2023 | Parsonage Lane BA1 1ER Bath Runway East / Kings Court England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr John Geake | 06. Apr. 2016 | The Old Estate Yard Newton St Loe BA2 9BR Bath | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Austria | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0