BEACONTREE ESTATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBEACONTREE ESTATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02291562
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BEACONTREE ESTATES LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich BEACONTREE ESTATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    St Martin's House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BEACONTREE ESTATES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CNC (EPSOM) LIMITED21. Okt. 198821. Okt. 1988
    FILEPAPER LIMITED31. Aug. 198831. Aug. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BEACONTREE ESTATES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BEACONTREE ESTATES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BEACONTREE ESTATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. März 2016

    20 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 31. Mai 2013

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. März 2015

    14 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. März 2014

    13 Seiten4.68

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    2 SeitenRM02

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    RM01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    5 SeitenRM01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 21. Aug. 2012

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 2Nd Floor, the Atrium 31 Church Road, Ashford Middlesex TW15 2UD* am 20. März 2013

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Sept. 2012

    Kapitalaufstellung am 20. Sept. 2012

    • Kapital: GBP 1,000,000
    SH01

    legacy

    4 SeitenLQ01

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    17 SeitenAR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    02. Apr. 2012The form replaces the AR01 registered on 12/08/2011 as it was not properly delivered

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    02. Apr. 2012A replacement AR01 was registered on 02/04/2012

    legacy

    9 SeitenMG01

    legacy

    12 SeitenMG06

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    13 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von BEACONTREE ESTATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AVIS, Marie Annick
    Farley Green
    Albury
    GU5 9DN Guildford
    Barn Cottage
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Farley Green
    Albury
    GU5 9DN Guildford
    Barn Cottage
    Surrey
    United Kingdom
    British91430630002
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Geschäftsführer
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    LOCKER, Robert John
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    Geschäftsführer
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    EnglandBritish155603490001
    BLACKETT, Kathleen
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    Sekretär
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    British1501820001
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Sekretär
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    British2667400002
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    12 Bonser Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    Sekretär
    12 Bonser Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    British2667400001
    WESTON, Carole Linda
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    Sekretär
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    British62673550003
    HAVER, Raymond Victor
    21 Denehurst Gardens
    IG8 0PA Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    21 Denehurst Gardens
    IG8 0PA Woodford Green
    Essex
    British15226710001
    JOHNSTON, James Vincent
    18 Testwood Road
    SL4 5RW Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    18 Testwood Road
    SL4 5RW Windsor
    Berkshire
    British35134150001
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Geschäftsführer
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    MAIS, Richard Jeremy Ian
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish1464610001
    NEDHAM, Andrew James
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    Geschäftsführer
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    British66426700001
    NEWEITT, Stephen Jeremy
    53 Coleridge Way
    BR6 0UQ Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    53 Coleridge Way
    BR6 0UQ Orpington
    Kent
    British35411650001
    UPTON, Richard
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish46440870005
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish2667400002

    Hat BEACONTREE ESTATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental mortgage
    Erstellt am 28. Sept. 2010
    Geliefert am 07. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The ground and first floor rear centre offices brooklyn house the green west drayton middlesex t/no AGL55700; assigns the rents, proceeds of insurance, any premium. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 26. Sept. 2010
    Erworben am 28. Sept. 2010
    Geliefert am 07. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Full title guarantee and as security for the payment of all liabilities by way of fixed charge all its present and future see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2010Registrierung eines Erwerbs (MG06)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 26. Aug. 2009
    Geliefert am 01. Sept. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings at marshgate trading estate taplow t/no BM99637, 2 parcels of land on the south side of the B1334 and land and buildings lying to the south of north seaton industrial estate ashington t/no ND102629, 12 richmond street weston super mare t/no AV144818, parkside mills bridge street and land and buildings on north side of school street golborne (millingford industrial estate) t/no GM230087; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2009
    • 102. Juni 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 126. März 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 319. Feb. 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 419. Feb. 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 319. Feb. 2014Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
    • 419. Feb. 2014Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
      • Aktenzeichen 3
      • Aktenzeichen 4
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 16. Dez. 2004
    Geliefert am 22. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juli 2000
    Geliefert am 26. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the senior finance documents (or any of them) to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Agent)
    Transaktionen
    • 26. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Account charge deed
    Erstellt am 04. Dez. 1997
    Geliefert am 13. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from cnc properties PLC to the chargee under a loan agreement dated 4TH december 1997 and all monies due from the cnc properties PLC and the second chargors being:- the valley centre limited, cnc estates limited, beacontree estates limited and shelfco (no 1381) limited under the security documents and any of them and all monies due from cnc properties PLC and the second chargors under the account charge deed
    Kurze Angaben
    All monies from time to time credited to and for the time being standing to the credit of the charged account together with all interest accrued and all other assets of the company and the second chargors. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rents assignment
    Erstellt am 04. Dez. 1997
    Geliefert am 13. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the cnc properties PLC to the chargee under the facility agreement dated 4TH december 1997 and the security documents (as defined in the facility agreement) and all monies due from the company to the chargee on any account whatsoever (including all sums covenanted to be paid by the company pursuant to a guarantee dated 4TH december 1997)
    Kurze Angaben
    All its rights title and interest present and future to and in the assigned property which means all rents and other income and all other monies in respect of the property (including under the leases and the future leases and any of them). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rents assignment
    Erstellt am 04. Dez. 1997
    Geliefert am 13. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the cnc properties PLC to the chargee under the facility agreement dated 4TH december 1997 and the security documents (as defined in the facility agreement) and all monies due from the company to the chargee on any account whatsoever (including all sums covenanted to be paid by the company pursuant to a guarantee dated 4TH december 1997)
    Kurze Angaben
    All its rights title and interest present and future to and in the assigned property which means all rents and other income and all other monies in respect of the property (including under the leases and the future leases and any of them). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 04. Dez. 1997
    Geliefert am 13. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the cnc properties PLC to the chargee under the facility agreement dated 4TH december 1997 and the security documents (as defined in the facility agreement) and all monies due from the company to the chargee on any account whatsoever (including all sums covenanted to be paid by the company pursuant to a guarantee dated 4TH december 1997)
    Kurze Angaben
    F/H land k/a units 1, 2 & 5 maple grove business park part t/no.NGL498430 and all plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 04. Dez. 1997
    Geliefert am 13. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the cnc properties PLC to the chargee under the facility agreement dated 4TH december 1997 and the security documents (as defined in the facility agreement) and all monies due from the company to the chargee on any account whatsoever (including all sums covenanted to be paid by the company pursuant to a guarantee dated 4TH december 1997)
    Kurze Angaben
    F/H land k/a cippenham lodge cippenham lane weekes drive slough berkshire t/no.BK266986 and all plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge by guarantor
    Erstellt am 30. Okt. 1997
    Geliefert am 05. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from cnc properties PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold land and buildings on the west side of leach street and cranberry street the north side of stuart street the east side of fishwick street and the south side of bilberry street title number la 122271; freehold land and buildings on the north side of stuart street title number GM540309 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery benefit of any leases, rents, monies, contracts, agreements, proceeds of sale, insurances. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. März 1997
    Geliefert am 21. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage:-f/h land and buildings known as langar trading estate harby road langar rushcliffe nottinghamshire t/n-NT316825. By way of fixed charge:- the plant machinery and fixtures and fittings of the company, the furniture furnishings equipment tools and other chattels of the company, the present and future goodwill of any business and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 30. Okt. 1995
    Geliefert am 10. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from clarke, nickolls & coombs PLC or the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the agreement dated 24TH october 1995
    Kurze Angaben
    All the property as detailed on the reverse and continuation sheet of the form 395 and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. März 1995
    Geliefert am 17. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from clarke, nickolls & coombs PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a units 6 & 7 maple grove business centre, green lane, hounslow, mioddlesex t/no. AGL22263 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 05. Sept. 1994
    Erworben am 23. Dez. 1996
    Geliefert am 01. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The aggregate of: (a) the present or future,actual or contingent obligations of cnc properties PLC under a loan agreement dated 20 january 1994 as varied by a supplemental loan agreement dated 5 september 1994 and a second supplemental loan agreement dated 23 december 1996 and of the company under the loan agreement as amended;and (b) all indemnification and expense reimbursement obligations of cnc properties PLC and beacontree estates limited under the said loan agreement
    Kurze Angaben
    First legal mortgage the f/h property (including all fittings,fixtures and fixed or heavy plant and machinery thereon) now owned by beacontree estates limited,forming part of land on the west side of haig road,knutsford,cheshire.t/no.CH302335.fixed charge all the company's right,title and interest in and to any proceeds of any insurance of all the property which is at the date of the charge or may become subject to the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Canadian Imperial Bank of Commerce
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1997Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 13. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Erstellt am 01. Juli 1994
    Geliefert am 08. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole that plot or area of ground lying on the north west side of eldon street, greenock together with the buildings thereon t/no. REN31815. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 20. Jan. 1994
    Erworben am 23. Dez. 1996
    Geliefert am 01. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The aggregate of: (a) the present or future,actual or contingent obligations of cnc properties PLC under a loan agreement dated 20 january 1994 as varied by supplemental loan agreements dated 5 september 1994 and 23 december 1996 and of the company under the loan agreement as amended;and (b) all indemnification and expense reimbursement obligations of cnc properties PLC and beacontree estates limited under the said loan agreement
    Kurze Angaben
    The company with full title guarantee thereby: charges by way of first legal mortgage the f/h property (including all fittings,fixtures and fixed or heavy plant and machinery thereon) t/nos.MX313519,MX303342,MX421647,MX329817,MX314283,NGL91082 and NGL498430 together with such estate and interest as the company has in the two pieces of land edged red on the plans attached to a transfer dated 22 july 1988.fixed charge all the company's right,title and interest in and to any proceeds of any insurance of all the property which is at the date of the charge or may become subject to the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Canadian Imperial Bank of Commerce
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1997Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 13. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 20. Jan. 1994
    Erworben am 23. Dez. 1996
    Geliefert am 01. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The aggregate of: (a) the present or future,actual or contingent obligations of cnc properties PLC under a loan agreement dated 20 january 1994 as varied by a supplemental loan agreements dated 5 september 1994 and 23 december 1996 and of the company under the loan agreement as amended;and (b) all indemnification and expense reimbursement obligations of cnc properties PLC and beacontree estates limited under the said loan agreement
    Kurze Angaben
    The company with full title guarantee thereby: a) first legal mortgage the f/h property (including all fittings,fixtures and fixed or heavy plant and machinery thereon) now owned by the company k/a cippenham lodge,cippenham lane,weekes drive,slough,berkshire.t/no.BK266086.fixed charge all the company's right,title and interest in and to any proceeds of any insurance of all the property subject to the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Canadian Imperial Bank of Commerce
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1997Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 13. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Okt. 1988
    Geliefert am 11. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a units 17 & 18 longmead industrial estate, blenheim road epsom, surrey (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Clarke Nickolls & Coombs PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 10. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Okt. 1988
    Geliefert am 07. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a units 17&18 blenheim road longmead industrial estate, epsom surrey - title no:- sy 589633 together with fixed plant & machinery & other fixtures assigns the goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 10. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Okt. 1988
    Geliefert am 07. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of floating security the whole of the company to. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 10. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BEACONTREE ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    2
    DatumTyp
    07. März 2013Beginn der Liquidation
    29. Sept. 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praktiker
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praktiker
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    4Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Receiver Manager
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0