G B AIRWAYS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameG B AIRWAYS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02294109
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von G B AIRWAYS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich G B AIRWAYS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o ERNST AND YOUNG LLP
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von G B AIRWAYS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FORGEUPPER LIMITED08. Sept. 198808. Sept. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von G B AIRWAYS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für G B AIRWAYS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für G B AIRWAYS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Hanger 89 London Luton Airport Luton Bedfordshire LU2 9PF* am 01. Juli 2013

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 23. Mai 2013

    • Kapital: GBP 1.00
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    3 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 20 vollständig

    3 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 21 vollständig

    3 SeitenMR04

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von G B AIRWAYS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PEMBERTON, Giles
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Sekretär
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    British112636270002
    CAMPBELL, Michael
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Geschäftsführer
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    EnglandBritish77951860002
    KENNEDY, Christopher John
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Geschäftsführer
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    United KingdomBritish62227310005
    MCCALL, Carolyn Julia
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Geschäftsführer
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    EnglandBritish39252480013
    ATTWOOD, Christopher Raymond
    Southwinds 1 The Drive
    Warwick Park
    TN2 5ER Tunbridge Wells
    Kent
    Sekretär
    Southwinds 1 The Drive
    Warwick Park
    TN2 5ER Tunbridge Wells
    Kent
    British106529990001
    HAWKINS, John Charles
    5 Broom Grove
    RG11 4TX Wokingham
    Berkshire
    Sekretär
    5 Broom Grove
    RG11 4TX Wokingham
    Berkshire
    British15916200002
    MAY, Iain Richard Campbell
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    Sekretär
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    British32619030002
    ALEXANDER CBE, William John
    Roughwood Croft
    Fair Mile
    RG9 2OX Henley On Thames
    Oxon
    Geschäftsführer
    Roughwood Croft
    Fair Mile
    RG9 2OX Henley On Thames
    Oxon
    British124928410001
    ALIKER, Paul Charles
    3 Greenford Close
    Orwell
    S98 5QA Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    3 Greenford Close
    Orwell
    S98 5QA Cambridge
    Cambridgeshire
    British39046710001
    ATTWOOD, Christopher Raymond
    Southwinds 1 The Drive
    Warwick Park
    TN2 5ER Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    Southwinds 1 The Drive
    Warwick Park
    TN2 5ER Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish106529990001
    CARR, Jeffrey
    5 Bellridge Place
    Knotty Green
    HP9 2DN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    5 Bellridge Place
    Knotty Green
    HP9 2DN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish103780760001
    GAGGERO, James Peter George
    3 Europa Road
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    3 Europa Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish133601430001
    GAGGERO, Joseph James
    Flat 27
    Chalfont House
    SW1X 8NG 49 Gadogan Lane
    London
    Geschäftsführer
    Flat 27
    Chalfont House
    SW1X 8NG 49 Gadogan Lane
    London
    United KingdomBritish11079290001
    GILMOUR, William Macmillan Davidson
    85 Leicester Road
    Shepshed
    LE12 9DF Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    85 Leicester Road
    Shepshed
    LE12 9DF Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritish65542220001
    GOODING, Valerie Frances
    No 19 Bloomsbury Mansions
    13-16 Bedford Way
    WC1B 5ER London
    Geschäftsführer
    No 19 Bloomsbury Mansions
    13-16 Bedford Way
    WC1B 5ER London
    United KingdomBritish36478520005
    GOODING, Valerie Frances
    22 Spencer Road
    KT8 0SP East Molesey
    Surrey
    Geschäftsführer
    22 Spencer Road
    KT8 0SP East Molesey
    Surrey
    EnglandBritish36478520001
    GURASSA, Charles Mark
    60 Camden Square
    NW1 9XE London
    Geschäftsführer
    60 Camden Square
    NW1 9XE London
    British46748300002
    HAMMAD, Saad Hassan
    3 Priory Gardens
    W4 1TT London
    Geschäftsführer
    3 Priory Gardens
    W4 1TT London
    UkBritish38921050004
    HARRISON, Andrew
    Wimbushes
    Ragged Hall Lane
    AL2 3NW St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Wimbushes
    Ragged Hall Lane
    AL2 3NW St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish9006050004
    HATTON, Anthony Kevin
    Stoke Park Farm Cottage London Road
    GU1 1XJ Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Stoke Park Farm Cottage London Road
    GU1 1XJ Guildford
    Surrey
    EnglandBritish29381720001
    HAWKINS, John Charles
    5 Broom Grove
    RG11 4TX Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    5 Broom Grove
    RG11 4TX Wokingham
    Berkshire
    British15916200002
    HYDE, David
    Bimini Christchurch Road
    GU25 4PX Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bimini Christchurch Road
    GU25 4PX Virginia Water
    Surrey
    British5068070001
    KENWORTHY, Peter
    5 Bakehouse Barn Close
    RH12 5JE Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    5 Bakehouse Barn Close
    RH12 5JE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish47694840001
    MAY, Iain Richard Campbell
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    GbrBritish32619030002
    MITCHELL, George Alexander
    19 Rivermount Gardens
    GU2 4DN Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    19 Rivermount Gardens
    GU2 4DN Guildford
    Surrey
    British95548010001
    MORGAN, John Sherwood
    Brackley Cottage
    Bull Lane
    SL9 8RY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Brackley Cottage
    Bull Lane
    SL9 8RY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish99812910001
    OSBORNE, John Graham
    73 Honeycrock Lane
    Salfords
    RH1 5DG Redhill
    Surrey
    Geschäftsführer
    73 Honeycrock Lane
    Salfords
    RH1 5DG Redhill
    Surrey
    British56259410001
    PATTERSON, John Howard
    The Oaks Horsham Road
    Mid Holmwood
    RH5 4ER Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Oaks Horsham Road
    Mid Holmwood
    RH5 4ER Dorking
    Surrey
    British27951160001
    PECK, Graham Douglas Grindell, Captain
    Flower Garden Cottage Birch Grove
    Horsted Keynes
    RH17 7DQ Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Flower Garden Cottage Birch Grove
    Horsted Keynes
    RH17 7DQ Haywards Heath
    West Sussex
    British59440780001
    SAYER, Raymond
    14 Llanvair Close
    South Ascot
    SL5 9HX Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    14 Llanvair Close
    South Ascot
    SL5 9HX Ascot
    Berkshire
    British15916230001
    SERRANO, Guillermo, Senor
    4 Gavilanes
    28035
    FOREIGN Madrid
    Spain
    Geschäftsführer
    4 Gavilanes
    28035
    FOREIGN Madrid
    Spain
    Spanish20295130001
    STREET, Michael Anthony
    The Waterfront
    300 Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Waterfront
    300 Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    Berkshire
    EnglandBritish46956720001
    WARD, William John James, Captain
    37 Blackheath Park
    SE3 9RW London
    Geschäftsführer
    37 Blackheath Park
    SE3 9RW London
    Irish104699510001

    Hat G B AIRWAYS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 25. Mai 2007
    Geliefert am 31. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders,security trustee and/or the facility agent on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right,title and interest (present and future) in and to the aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 31. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 25. Mai 2007
    Geliefert am 31. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the assignor to the lenders,security trustee and/or the facility agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the assignor's right,title and interest (present and future) in,to and under the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 31. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of deposit
    Erstellt am 22. Nov. 2006
    Geliefert am 23. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation 22368918 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge of deposit
    Erstellt am 03. Nov. 2006
    Geliefert am 04. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit initially of us $700,000 credited to account designation rbsgbairusda with the bank and any addition to that deposit and any deposit from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from or out of such initial deposit or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge of deposit
    Erstellt am 23. Aug. 2006
    Geliefert am 12. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The deposit credited to account number 22368918 and all other monies standing to the credit of that account and any other deposit or account from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 23. Mai 2006
    Geliefert am 13. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the chargee and/or the facility agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the assignors right title and interest in to and under the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 13. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Mai 2006
    Geliefert am 13. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the chargee and/or the facility agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the aircraft being airbus A321-200 s/n 2682 registration mark g-ttie. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 13. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Purchase agreement assignment
    Erstellt am 10. Apr. 2006
    Geliefert am 28. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the chargee and/or the facility agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in under and to the ba purchase agreement in so far as it relates to the aircraft being airbus A321-200 aircraft to be registered as g-ttif. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Purchase agreement assignment
    Erstellt am 10. Apr. 2006
    Geliefert am 28. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the chargee and/or the facility agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in under and to the ba purchase agreement in so far as it relates to the aircraft being airbus A321-200 aircraft with s/no 2682 to be registered as g-ttie. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An assignment of insurances
    Erstellt am 16. Nov. 2005
    Geliefert am 23. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the company's rights, title and interest, present and future, to the benefit of, and in respect of the proceeds arising, under: all insurances and any requisistion compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Aerospace Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An aircraft lease agreement relating to one airbus A320-232 serial number 2137
    Erstellt am 14. Nov. 2005
    Geliefert am 23. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any amount paid to the lessor from time to time in accordance with clause 8 of the lease as a security deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Aerospace Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 12. Mai 2005
    Geliefert am 24. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the chargee and/or the facility agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigned property being all of the rights, title and interest, present and future of the company to all the benefits of, and all the claims under, all policies and contracts of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 24. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 12. Mai 2005
    Geliefert am 24. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the security trustee and/or the facility agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale
    Transaktionen
    • 24. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 30. März 2004
    Geliefert am 07. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The right title and interest present and future to the benefit of and in respect of proceeds arising under all insurances and any requisition compensation relating to the aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Aviation Capital Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Aircraft lease agreement
    Erstellt am 19. Dez. 2003
    Geliefert am 06. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A security deposit of two months' rent and all interest accrued thereon.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Aviation Capital Limited
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage deed
    Erstellt am 11. Dez. 2003
    Geliefert am 22. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other part to the operative documents to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right, tite and interest (present and future) in and to the aircraft being one (1) airbus A320-232 aircraft bearing manufacturer's s/no 2137 excluding the engines or engines from time to time installed on the aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale, as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 11. Dez. 2003
    Geliefert am 22. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due form the company or any other party to the operative documents to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest of the company in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale as Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 02. Mai 2003
    Geliefert am 06. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the proceeds arising out of all insurances and all requisition compensation.
    Berechtigte Personen
    • Acg Acquisition 38 Llc
    Transaktionen
    • 06. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 29. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 10. Apr. 2003
    Geliefert am 14. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest to and in all insurances in respect of all risks of physical loss or damage effected in relation to the aircraft and all benefits thereof. Any requisition compensation relating to the aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Acg Acquisition 37 Llc
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 29. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 13. Feb. 2003
    Geliefert am 18. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All insurances; any requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Acg Acquisition 31 Llc
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 29. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Lease relating to one airbus A320-232 aircraft bearing serial number 1918
    Erstellt am 23. Jan. 2003
    Geliefert am 07. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A security deposit in the sum of one month's rent payable by the lessee to the lessor pursuant to clause 7.1 of the lease and all rights of the lessee to payment thereof the debt represented thereby and all interest thereon and/or any and all interest of the lessee therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Acg Acquisition 31 Llc
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 29. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Lease relating to one airbus A320-232 aircraft bearing serial number 1969
    Erstellt am 23. Jan. 2003
    Geliefert am 07. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A security deposit in the sum of one month's rent payable by the lessee to the lessor pursuant to clause 7.1 of the lease and all rights of the lessee to payment thereof the debt represented thereby and all interest thereon and/or any and all interest of the lessee therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Acg Aquisition 37 Llc
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 29. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Lease relating to one airbus A320-232 aircraft bearing serial number 1993
    Erstellt am 23. Jan. 2003
    Geliefert am 07. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A security deposit in the sum of one month's rent payable by the lessee to the lessor pursuant to clause 7.1 of the lease and all rights of the lessee to payment thereof the debt represented thereby and all interest thereon and/or any and all interest of the lessee therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Acg Acquisition 38 Llc
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 29. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of insurances
    Erstellt am 12. Dez. 2002
    Geliefert am 20. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the rights title and interest of the assignor in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 12. Dez. 2002
    Geliefert am 20. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its rights title and interest (present and future) in and to the aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat G B AIRWAYS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Juni 2013Beginn der Liquidation
    11. Sept. 2014Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Guy Boughey
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Praktiker
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Praktiker
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0