MURCHISON ASSOCIATES LIMITED

MURCHISON ASSOCIATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMURCHISON ASSOCIATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02299788
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MURCHISON ASSOCIATES LIMITED?

    • Pflegeheime (86102) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich MURCHISON ASSOCIATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite 201 Second Floor Design Centre East
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MURCHISON ASSOCIATES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BUGNICE LIMITED26. Sept. 198826. Sept. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MURCHISON ASSOCIATES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MURCHISON ASSOCIATES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MURCHISON ASSOCIATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jon Hather am 09. Apr. 2014

    2 SeitenCH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 27. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share capital redemption account cancelled 21/01/2014
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Michael Parsons als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    13 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jon Hather am 25. März 2013

    2 SeitenCH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    15 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    13 SeitenAA

    Ernennung von Mr Ian Portal als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Jon Hather als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Suite 201 the Chambers Chelsea Harbour London SW10 0XF* am 13. Dez. 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    14 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MURCHISON ASSOCIATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PORTAL, Ian
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Sekretär
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    165723970001
    DUNCAN, David Gregor
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish97755760001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish68848420006
    ANDERSON, Michael
    Adelaide House
    London Bridge
    EC4R 9HA London
    Sekretär
    Adelaide House
    London Bridge
    EC4R 9HA London
    British97755830001
    DUNCAN, David Gregor
    Flat 43 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    Sekretär
    Flat 43 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    British97755760001
    FAFALIOS, Mark George
    Keeran Raleigh Drive
    Claygate
    KT10 9DE Esher
    Surrey
    Sekretär
    Keeran Raleigh Drive
    Claygate
    KT10 9DE Esher
    Surrey
    American51597550001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Sekretär
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    NICHOLSON, Paul
    253 Chipstead Way
    SM7 3JW Banstead
    Surrey
    Sekretär
    253 Chipstead Way
    SM7 3JW Banstead
    Surrey
    British62799290001
    STROWBRIDGE, John Michael Barrie
    23 Belfry Lane The Green
    Collingtree
    NN4 0PB Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    23 Belfry Lane The Green
    Collingtree
    NN4 0PB Northampton
    Northamptonshire
    British67092700003
    WALKER, Carl St Michael
    8a Lawn Road
    Belsize Park
    NW3 2XS London
    Sekretär
    8a Lawn Road
    Belsize Park
    NW3 2XS London
    British58959110001
    ABRAHAMS, David
    Hanyards 12 The Ridgeway
    EN6 4AR Cuffley
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Hanyards 12 The Ridgeway
    EN6 4AR Cuffley
    Hertfordshire
    EnglandBritish56483900002
    ALSTON, David Jospeh, Dr
    Cottesloe Golf Lane
    Church Brampton
    NN6 8AY Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Cottesloe Golf Lane
    Church Brampton
    NN6 8AY Northampton
    Northamptonshire
    British45760050001
    BEALE, David George
    North Fambridge Hall
    CM3 6LU Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    North Fambridge Hall
    CM3 6LU Chelmsford
    Essex
    British8589230001
    ELESPURU, Peter Francis
    PO BOX 25639
    Riyadh 11766 Kingdom
    FOREIGN Saudi Arabia
    Geschäftsführer
    PO BOX 25639
    Riyadh 11766 Kingdom
    FOREIGN Saudi Arabia
    American44082580002
    FAFALIOS, Mark George
    Keeran Raleigh Drive
    Claygate
    KT10 9DE Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Keeran Raleigh Drive
    Claygate
    KT10 9DE Esher
    Surrey
    American51597550001
    GIBSON, Frederick Anthony
    Kiln Howe
    Colwinston
    CF71 7NE Cowbridge
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    Kiln Howe
    Colwinston
    CF71 7NE Cowbridge
    South Glamorgan
    WalesBritish82874520002
    HAYWARD, Alan
    48 Christ Church Street
    Chelsea
    SW3 4AR London
    Geschäftsführer
    48 Christ Church Street
    Chelsea
    SW3 4AR London
    United KingdomBritish36416850002
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Irish116537370001
    MILLS-WEBB, James Sydney Edward
    The Orchard 24 Astley Road
    HP1 1HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Orchard 24 Astley Road
    HP1 1HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British78967370001
    PARSONS, Michael Dennis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish44895330007
    STROWBRIDGE, John Michael Barrie
    23 Belfry Lane The Green
    Collingtree
    NN4 0PB Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    23 Belfry Lane The Green
    Collingtree
    NN4 0PB Northampton
    Northamptonshire
    British67092700003
    ZORN, Jeffrey Lee
    PO BOX 11461
    FOREIGN Riyadh
    Saudi Arabia
    Geschäftsführer
    PO BOX 11461
    FOREIGN Riyadh
    Saudi Arabia
    Usa28908640001

    Hat MURCHISON ASSOCIATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 14. Dez. 2012
    Geliefert am 19. Dez. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Okt. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An intercreditor and subordination agreement
    Erstellt am 13. Juli 2006
    Geliefert am 25. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Subject to clause 10.2 if at any time prior to the discharge in full of the liabilities of the senior creditors, any lender or investor receives or recovers any payment or distribution of, or on account of or in relation to, any of the liabilities which is not permitted by clause 7 any amount by way of set-off in respect of any of the liabilities owed to them which does not give effect to a payment permitted by clause 7. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 25. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Subordination agreement
    Erstellt am 13. Juli 2006
    Geliefert am 20. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company as junior creditor under the subordination agreement has undertaken to the security trustee that if: any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor recieves all or any amount.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 13. Juli 2006
    Geliefert am 20. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The bridge secured obligations being all monies due or to become due from each bridge obligor to the bridge finance parties or bridge overdraft banks (or any of them) and the opco secured obligations being all monies due or to become due from each opco obligor to the opco finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The "Securitytrustee")
    Transaktionen
    • 20. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 19. Okt. 2004
    Geliefert am 02. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Hickathrift house smeeth road marshland st james norfolk, f/h, t/n NK259695, NK300644, hickathrift hollow school road marshland st james norfolk f/h t/n NK178918, collingtree park nursing home, 110 windingbrook lane, northampton f/h, t/n NN166935,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries(The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 29. Apr. 2004
    Geliefert am 13. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F.h property known as hickathrift house smeeth road marshland st james norfolk t/n's NK259695 and NK2300644, the f/h property known as hickathrift hollow school road marshland st james norfolk, t/n NK178918, the f/h property known as collingtree park nursing home, 110 windingbrook lane, northampton, t/n NN166935. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries(The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 13. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Nov. 2003
    Geliefert am 11. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H collingtree park residential home 110 windingbrook lane northampton. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Okt. 2003
    Geliefert am 18. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hickathrift too 211 smeeth road marshland st james norfolk PE14 8ES. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juni 2001
    Geliefert am 12. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hickathrift house smeeth road marshland st james lincs t/n NK259695. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juni 2001
    Geliefert am 02. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 15. Dez. 1995
    Geliefert am 23. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Dez. 1995
    Geliefert am 23. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Collingtree park nursing home 110 winding brook lane collingtree northampton with the benefit of all rights, licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property....... See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 03. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 03. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1) land & buildings k/a the nursing home site collingtree park, northampton t/no nn 127650 2). floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Sept. 1989
    Geliefert am 27. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Part of land north of ash lane and land north of watering lane collingtree northampton.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 13. Sept. 1989
    Geliefert am 27. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 08. Jan. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0