THE UK CHANNEL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE UK CHANNEL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02301363 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE UK CHANNEL LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich THE UK CHANNEL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The London Television Centre Upper Ground SE1 9LT London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE UK CHANNEL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THE HOME SERVICE CHANNEL LIMITED | 20. Juli 1989 | 20. Juli 1989 |
| MANI LIMITED | 30. Sept. 1988 | 30. Sept. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE UK CHANNEL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE UK CHANNEL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Eleanor Kate Irving am 16. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Helen Jane Tautz am 16. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 200 Grays Inn Road London WC1X 8HF am 12. Okt. 2009 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 2 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 8 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 2 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 2 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE UK CHANNEL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRVING, Eleanor Kate | Geschäftsführer | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 79177030002 | |||||
| TAUTZ, Helen Jane | Geschäftsführer | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 37564540001 | |||||
| ABDOO, David | Sekretär | 78 Airedale Avenue Chiswick W4 2NN London | British | 40437090001 | ||||||
| HOWLE, Michael Anthony | Sekretär | 46 Dowlans Road KT23 4LE Great Bookham Surrey | British | 32460850001 | ||||||
| LUCAS, Anthony Ronald | Sekretär | Flat 12 Beatrix House 208 Old Beatrix Road SW5 0BP London | British | 30771870001 | ||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Sekretär | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||
| ANCLIFF, Christopher John | Geschäftsführer | 121 Chestnut Grove SW12 8JH London | British | 52876050001 | ||||||
| BIRDSEYE, Sarah Elizabeth | Geschäftsführer | 4 Bowood Road SW11 6PE London | British | 69659880002 | ||||||
| BUGGY, Alan Richard | Geschäftsführer | 927 Westover Road Stamford Connecticut FOREIGN Usa | American | 4860890001 | ||||||
| CONSTANT, Richard Michael | Geschäftsführer | 6 Balniel Gate SW1V 3SD London | United Kingdom | British | 43836310003 | |||||
| CRESSWELL, John | Geschäftsführer | Rosslyn House 8 Park Road SO22 6AA Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 39795820003 | |||||
| DILNOTT-COOPER, Rupert Michael Walter James | Geschäftsführer | 23 Glenmore Road NW3 4BY London | England | British | 52448400001 | |||||
| FORREST, Ian Mcclure | Geschäftsführer | Brewhurst House Brewhurst RH14 0RJ Loxwood West Sussex | British | 2327400003 | ||||||
| GOROG, William Christopher | Geschäftsführer | 9044 Melrose Avenue FOREIGN Los Angeles 90069 Usa | American | 96074620002 | ||||||
| HAIMOVITZ, Jules | Geschäftsführer | 10551 Wilshire Boulevard 90024 Los Angeles California U.S.A. | American | 43075680001 | ||||||
| HUTCHINGS, David George | Geschäftsführer | Crepping Hall CO6 2AL Wakes Colne Essex | British | 10085500002 | ||||||
| JACQUES, John Douglas | Geschäftsführer | White Gates 81 East Lane West Horsley KT24 6LR Leatherhead Surrey | British | 3170310001 | ||||||
| JOHNSON, David | Geschäftsführer | 50 Rayleigh Road Hutton CM13 1BA Brentwood Essex | England | British | 76706450001 | |||||
| LUCAS, Anthony Ronald | Geschäftsführer | Flat 12 Beatrix House 208 Old Beatrix Road SW5 0BP London | British | 30771870001 | ||||||
| MARRINAN, James | Geschäftsführer | 206815 Hot Springs Place Agoura Hills California Ca91301 FOREIGN Usa | American | 17905570001 | ||||||
| MEDLICOTT, William Jonathan | Geschäftsführer | Wild Boars Monteswood Lane RH17 7NS Horsted Keynes West Sussex | England | English | 44636500002 | |||||
| POHL, Henry Theodore | Geschäftsführer | 227 Hanworth Road TW12 3EF Hampton Middlesex | British | 32450180001 | ||||||
| SANITSKY, Robert | Geschäftsführer | 9100 Wilshire Boulevard Suite 600 90212 Beverley Hills Los Angeles California Usa | Usa | 53433450001 | ||||||
| SMITH, Kathryn | Geschäftsführer | 9 Hanover Steps Saint Georges Fields W2 2YG London | British | 77161950001 | ||||||
| TILL, Stewart Myles | Geschäftsführer | Barrymore 6 High Street RG10 8HY Wargrave Berkshire | British | 24204890001 | ||||||
| WILLIAMS, Lucinda Mary | Geschäftsführer | 34 Helena Road SL4 1JN Windsor Berkshire | British | 55121890001 |
Hat THE UK CHANNEL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee & debenture | Erstellt am 06. Feb. 1991 Geliefert am 14. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreements dated 5/2/91 and all other facility documents on defined | |
Kurze Angaben (See doc M132 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Amanded and restated copyright collaterol assignment agreement | Erstellt am 05. Feb. 1991 Geliefert am 14. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined) | |
Kurze Angaben All of the company's right title and interest in the " collaferal" (see form 395 ref M108 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trademark security agreement | Erstellt am 05. Feb. 1991 Geliefert am 14. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined) | |
Kurze Angaben All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 395 - ref M124 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Us security agreement (created by the home service channel limited now k/a the U.K. channel limited) | Erstellt am 05. Feb. 1991 Geliefert am 14. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined) | |
Kurze Angaben All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 396- ref m 116 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0