NEWINCCO 839 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNEWINCCO 839 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02301998
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NEWINCCO 839 LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich NEWINCCO 839 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Clock House
    Paines Lane
    HA5 3BZ Pinner
    Middlesex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NEWINCCO 839 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DELANCEY ESTATES LIMITED07. Jan. 199707. Jan. 1997
    ARTESIAN ESTATES PLC23. Dez. 198823. Dez. 1988
    FAROVER PLC04. Okt. 198804. Okt. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEWINCCO 839 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für NEWINCCO 839 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Jan. 2013

    14 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2012

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Jan. 2012

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juli 2011

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Jan. 2011

    6 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 6th Floor Lansdowne House Berkeley Square London W1J 6ER am 06. Feb. 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Jan. 2010

    LRESSP

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Kapitalaufstellung am 22. Jan. 2010

    • Kapital: GBP 218,441.77
    5 SeitenSH19

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share redemption reserve & share prem acc cancelled 21/01/2010
    RES13

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    4 Seiten363a

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed delancey estates LIMITED\certificate issued on 09/06/08
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    18 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005

    17 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von NEWINCCO 839 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Sekretär
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    93189540002
    PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Geschäftsführer
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    93189540002
    PORTMAN ADMINISTRATION 2 LIMITED
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Geschäftsführer
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    88224330004
    CUNNINGHAM, Antony Paul
    Forest Lodge High Street
    Balcombe
    RH17 6JZ Haywards Heath
    West Sussex
    Sekretär
    Forest Lodge High Street
    Balcombe
    RH17 6JZ Haywards Heath
    West Sussex
    British44992380001
    MOSS, Andrew Graham
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    Sekretär
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    British4573140002
    BREEN, Richard Christopher
    60 Webbs Road
    SW11 6SE London
    Geschäftsführer
    60 Webbs Road
    SW11 6SE London
    United KingdomBritish37178200001
    BROOKSBANK, George Edward Hugh
    58 Cumberland Street
    SW1V 4LZ London
    Geschäftsführer
    58 Cumberland Street
    SW1V 4LZ London
    British45758820002
    CUNNINGHAM, Antony Paul
    Forest Lodge High Street
    Balcombe
    RH17 6JZ Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Forest Lodge High Street
    Balcombe
    RH17 6JZ Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish44992380001
    DIXON, Peter Herbert, The Honourable
    The Old Rectory
    Yattendon
    RG18 0UR Thatcham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Yattendon
    RG18 0UR Thatcham
    Berkshire
    British37300330001
    EDELMAN, Martin Lee
    Hillside Road Rye
    Westchester
    New York 10580
    55
    United States
    Geschäftsführer
    Hillside Road Rye
    Westchester
    New York 10580
    55
    United States
    United StatesAmerican133811640001
    EMMETT, Graham Anthony Johnathan
    Rushmead
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Rushmead
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    British66041940002
    GARFIELD, John Stuart Godwin
    20 Egerton Gardens Mews
    SW3 London
    Geschäftsführer
    20 Egerton Gardens Mews
    SW3 London
    British22311780001
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Mulberry Lodge
    Mill Hill Barnes
    SW13 0HS London
    Geschäftsführer
    Mulberry Lodge
    Mill Hill Barnes
    SW13 0HS London
    United KingdomBritish60475780002
    HADEN SCOTT, Timothy
    6 Russell Hill
    CR8 2JA Purley
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Russell Hill
    CR8 2JA Purley
    Surrey
    British63220740001
    HYAMS, David Joseph
    Milner House
    Manchester Square
    W1A 1BA London
    Geschäftsführer
    Milner House
    Manchester Square
    W1A 1BA London
    British44894350003
    KATZ, Richard William
    Villa La Sirena
    Vico Dell Olivetta 12
    FOREIGN Mortola Inferiore 18039 (Im)
    Ventimiglia Italy
    Geschäftsführer
    Villa La Sirena
    Vico Dell Olivetta 12
    FOREIGN Mortola Inferiore 18039 (Im)
    Ventimiglia Italy
    British59404510001
    LEWIS, Philip Geoffrey
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    Geschäftsführer
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    EnglandBritish6639590001
    MANSER, Peter John
    1 Airlie Gardens
    W8 7AJ London
    Geschäftsführer
    1 Airlie Gardens
    W8 7AJ London
    British71263200001
    MOSS, Andrew Graham
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    Geschäftsführer
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    United KingdomBritish4573140002
    RAZZALL, Edward Timothy
    9b Landsdowne Walk
    W11 9LN London
    Geschäftsführer
    9b Landsdowne Walk
    W11 9LN London
    British72530280002
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Geschäftsführer
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritish38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Geschäftsführer
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001

    Hat NEWINCCO 839 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A fixed and floating security document
    Erstellt am 29. Nov. 2001
    Geliefert am 12. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by any obligor to any finance party under or in connection with any finance document
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 01E Royal Bank of Scotland PLC (The "Agent" Which Expression Includes Its Successors and Assigns as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Feb. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 17. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of securities
    Erstellt am 25. Mai 2000
    Geliefert am 30. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the loan agreement dated 7 february 2000
    Kurze Angaben
    All stocks shares bonds warrants or other securities from time to time and all income derived therefrom.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit agreement and charge on cash deposit
    Erstellt am 15. Sept. 1999
    Geliefert am 30. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from the company to the chargee under clause 6.4 (indemnity from the borrower) of the credit agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    All of the company's right title and interest in and to the deposit account and the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 15. Sept. 1999
    Geliefert am 30. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined in the credit agreement) under each finance document (as defined) (other than after the final maturity date, the deposit agreement and clause 6.4 (indemnity from the borrower) of the credit agreement to the extent that the company has provided cash cover in respect of any guarantees)
    Kurze Angaben
    All the shares and by way of a first fixed charge all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Aug. 1996
    Geliefert am 03. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to allied irish banks, P.L.C. (as security trustee) and/or aib finance limited on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage f/h land to the west of main road leaves green biggin hill bromley kent t/n-SGL573654. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks, P.L.C. (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Aug. 1996
    Geliefert am 03. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to allied irish banks, P.L.C. (as security trustee) and/or aib finance limited on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage f/h plots 5, 25, 26, 27, 31 and 32 vincent square biggin hill bromley t/n-SGL573654. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks, P.L.C. (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Feb. 1996
    Geliefert am 01. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a sillwood hall montpelier road brighton east sussex t/no ESX191041 with the goodwill of the business and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks Plcas Trustee for Itself and Aib Finance Limited
    Transaktionen
    • 01. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Dez. 1995
    Geliefert am 16. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to allied irish banks,P.L.C. In its capacity as trustee for itself and aib finance limited and/or aib finance limited on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the f/h property k/as land at maiden lane and exchange court,london WC1 being part of land under t/no.NGL654987.specific charge the goodwill and connection of the business or businesses from time to time carried on by or for the account of the company upon all or any part of the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-101 and 103 ross road south norwood. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H-flat 17, flat 70, flat 82 and garage 3 greenhill high street hampstead. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H-12A, 22 cunningham court maida vale london W9. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H-5, 40 parking bay 3, parking bay 5, parking bay 6, manor house marylebone road london NW1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The oasis 122-124 widmore road bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-forsythe shades court 29/31 the avenue beckenham kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-eastland court 163A widmore road bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-westland lodge 159 widmore road bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-fairline court 2 oakwood avenue beckenham kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-andace park 127 and 135-151 widmore road bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-andhurst court 2A coombe lane west (previously known as 2, 4 and 6 gloucester road) kingston-upon-thames surrey. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-androse gardens bickerley road ringwood hants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-andbourne court admiralty road southbourne bournemouth. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-andwell court trinity place eastbourne east sussex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-hopton court forge close hayes bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-andringham lodge 51 palace grove bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1995
    Geliefert am 25. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-andridge court 162-164 kingston road merton park london SW19. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NEWINCCO 839 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    25. Juni 2013Aufgelöst am
    26. Jan. 2010Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian David Holland
    The Clock House
    87 Paines Lane
    HA5 3BZ Pinner
    Middlesex
    Praktiker
    The Clock House
    87 Paines Lane
    HA5 3BZ Pinner
    Middlesex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0