SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02302277 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CHURCHFIELD PARK (NOTTINGHAM) LIMITED | 05. Okt. 1988 | 05. Okt. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 6 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Janette Malham als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR, Stephen Jonathan | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 163496070001 | ||||
CHURCH, John Andrew | Sekretär | 1 Rectory Cottages Gedling NG4 4BH Nottingham Nottinghamshire | British | 59407160001 | ||||||
GOODALL, Christopher John | Sekretär | 4 Manor Court Bramcote NG9 3DR Nottingham Nottinghamshire | British | Solicitor | 84003280001 | |||||
MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158305770001 | |||||||
MCLEISH, William David | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
RUTTER, Christopher | Sekretär | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Company Director | 103588940001 | |||||
ARTHUR, Kevin Mccabe | Geschäftsführer | The Landings Beningbrough YO30 1BY York | British | Company Director | 51886750002 | |||||
BOLOT, Timothy James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 107837080002 | ||||
BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 79917240001 | ||||
CARPENTER, Terence John | Geschäftsführer | Green Pastures Farm 106 Bridle Road Burton Joyce NG14 5FP Nottingham Nottinghamshire | British | Motor Car Sales Executive | 15679280001 | |||||
CHURCH, John Andrew | Geschäftsführer | 1 Rectory Cottages Gedling NG4 4BH Nottingham Nottinghamshire | British | Chartered Accountant | 59407160001 | |||||
COLVIN, William | Geschäftsführer | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Director | 51697890003 | ||||
FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 111188390002 | ||||
HENDERSON, David Greig | Geschäftsführer | 20 Lydney Park West Bridgford NG2 7TJ Nottingham | England | British | Director | 6112570002 | ||||
HILL, Randolph Paul | Geschäftsführer | 40 Bridgetown Road CV37 7JA Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Director | 15223790003 | |||||
LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | Director | 144822040001 | ||||
MACINTOSH, Michael | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 137864880001 | ||||
MALHAM, Janette | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 91088900004 | ||||
MARK, Larry Edward | Geschäftsführer | 29 Cedar Drive SL5 0UA Sunningdale Berkshire | New Zealander | Company Director | 5076900001 | |||||
MCKEEVER, Pauline Ann | Geschäftsführer | 40 Pine Place G5 0BX Glasgow | Britain | British | Managing Director | 91521130001 | ||||
MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 110640170001 | ||||
MORETON, John Ernest | Geschäftsführer | The Old Farm Winkfield Row RG12 6NG Reading Berkshire | New Zealander | Company Director | 80392940001 | |||||
MURPHY, John | Geschäftsführer | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | Director | 26177180004 | ||||
NEWCOMBE, John Harry | Geschäftsführer | 25 Boxley Drive West Bridgford NG2 7GQ Nottingham | British | Chartered Secretary | 11916170001 | |||||
RUTTER, Christopher | Geschäftsführer | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Company Director | 103588940001 | |||||
SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | Company Director | 174231320001 | ||||
SIZER, Graham Kevin | Geschäftsführer | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | Chartered Accountant | 77274540003 | ||||
SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 147997950001 | ||||
SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | Director | 147997950001 | ||||
SUFFIELD, Mervyn John, Dr | Geschäftsführer | The Cottage Winchester Road Waltham Chase SO32 2LG Southampton Hampshire | British | Medical Doctor | 34214100001 | |||||
THORNE, Anthony David | Geschäftsführer | 41 Bartholomew Place RG42 3DQ Warfield Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 80445640001 |
Hat SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 29. Feb. 2008 Geliefert am 14. März 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Juni 2007 Geliefert am 19. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Juli 2006 Geliefert am 20. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Apr. 2005 Geliefert am 15. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Sept. 2004 Geliefert am 28. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Aug. 2002 Geliefert am 03. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Second guarantee and debenture | Erstellt am 25. Feb. 2002 Geliefert am 11. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by the chargor and by each other charging company to the chargee (as security agent for the beneficiaries) (as defined) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 03. Sept. 1993 Geliefert am 09. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 15. Jan. 1992 Geliefert am 29. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Aug. 1990 Geliefert am 04. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Churchfield nursing home, south east radford, grove lane radford, nottinghamshire title no nt 238835. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Aug. 1989 Geliefert am 11. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £61,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben Including churchfield home radford nottingham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 19. Jan. 1989 Geliefert am 21. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £536,000 | |
Kurze Angaben F/H land off radford grove lane hartley road nottingham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0