HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02303704 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?
- Verkauf von Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45111) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | No 1 Dorset Street SO15 2DP Southampton Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HIGHTHIRD LIMITED | 11. Okt. 1988 | 11. Okt. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 2 Penman Way, Grove Park Leicester Leicestershire LE19 1st zum No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP am 08. Okt. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gerard Edward Nieuwenhuys als Geschäftsführer am 07. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Adam Collinson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Mallett als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Kurnick als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Page-Morris als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Laurence Vaughan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Kevin Jones als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINSON, Adam | Sekretär | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | 148166240001 | |||||||
| COLLINSON, Adam | Geschäftsführer | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | England | British | 136375910001 | |||||
| BAKER, Lorna Margaret | Sekretär | 47 Summerleys Road HP27 9DS Princes Risborough Buckinghamshire | British | 48588210001 | ||||||
| CARPENTER, Mark Gwilym | Sekretär | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | British | 105829630002 | ||||||
| JONES, David Kevin | Sekretär | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | 157724100001 | |||||||
| MORRIS, Mark Christopher | Sekretär | Curtis House LE15 9JG Stoke Dry Rutland | British | 147628740001 | ||||||
| CARPENTER, Mark Gwilym | Geschäftsführer | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 105829630002 | |||||
| HAMILTON, John | Geschäftsführer | 12 Hardwick Close SL6 5JU Maidenhead Berkshire | British | 26625940001 | ||||||
| KURNICK, Robert Harold | Geschäftsführer | 670 Pleasant Birmingham Michigan 48009 Usa | United States | American | 82981540007 | |||||
| MALLETT, Jeremy Richard | Geschäftsführer | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 71752820001 | |||||
| MORRIS, Mark Christopher | Geschäftsführer | Curtis House LE15 9JG Stoke Dry Rutland | England | British | 147628740001 | |||||
| NIEUWENHUYS, Gerard Edward | Geschäftsführer | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 66435290003 | |||||
| PAGE-MORRIS, Geoffrey Giovanni | Geschäftsführer | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | England | British | 105444550002 | |||||
| VAUGHAN, Laurence Edward William | Geschäftsführer | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | England | English | 40326440010 |
Hat HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Okt. 2000 Geliefert am 26. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a valley road hughenden way high wycombe buckinghamshire t/n BM19263. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 28. Sept. 2000 Geliefert am 03. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a valley road hughenden valley high wycombe buckinghamshire t/no. BM128087. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Dez. 1998 Geliefert am 13. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land k/a land and buildings on the south east side of hughenden road high wycombe t/n BM19263 and l/a land and buildings on the south east side of friars gardens hughendedn high wycombe t/n BM128087 by way of assignment the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Residual floating charge | Erstellt am 31. Dez. 1998 Geliefert am 13. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of floating charge the company's undertaking property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 26. Jan. 1993 Geliefert am 28. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of overdraft facilities (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben First all the company's present and future stock of used motor vehicles of whatsoever nature and all the company's right title and interest therein. Secondly all moneys from time to time payable under any insurances in respect of motor vehicles. And thirdly all goods given in exchange for the motor vehicles. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 01. Mai 1992 Geliefert am 02. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The company's present and future stock of used vehicles and all the company's right, title and interest therein all moneys from time to time payable under any insurances all debts from time to time owing to the company in respect of motor vehicles. See doc for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 14. Sept. 1989 Geliefert am 03. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Sept. 1989 Geliefert am 19. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Sept. 1989 Geliefert am 15. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed | |
Kurze Angaben All monies from time to time owing to the company by the chargor in respect of refund monies (continued see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 14. Sept. 1989 Geliefert am 15. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First all the chargors present and future stock of used motor vehicles of whatsoever nature and all the chargor's right title and interest therein (for full details see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0