ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02307783 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O AARON AND PARTNERS LLP 5-7 Grosvenor Court Foregate Street CH1 1HG Chester Cheshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Change of details for Fourth Holdings Limited as a person with significant control on 27. Sept. 2022 | 5 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Forum St Paul's 33 Gutter Lane Second Floor London EC2V 8AS United Kingdom zum 5-7 Grosvenor Court Foregate Street Chester Cheshire CH1 1HG am 04. Okt. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 20. Sept. 2022
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Whitmarsh am 22. Juli 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Clinton Anderson am 22. Juli 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Change of details for Fourth Holdings Limited as a person with significant control on 22. Juli 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juli 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 90 Long Acre Covent Garden London WC2E 9RA zum Forum St Paul's 33 Gutter Lane Second Floor London EC2V 8AS am 09. Juni 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von John Whitmarsh als Direktor am 05. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Clinton Anderson als Direktor am 02. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christian Berthelsen als Geschäftsführer am 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Benjamin William Hood als Geschäftsführer am 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Aug. 2019 bis 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON, Clinton | Geschäftsführer | Foregate Street CH1 1HG Chester 5-7 Grosvenor Court Cheshire | United States | American | Chief Executive Officer | 267294470001 | ||||
WHITMARSH, John | Geschäftsführer | Foregate Street CH1 1HG Chester 5-7 Grosvenor Court Cheshire | United States | American | Chief Financial Officer | 267294480001 | ||||
LOVELADY, Andrew Robert | Sekretär | 50 Tollemache Road CH43 8SZ Prenton Merseyside | British | 41693730006 | ||||||
O'SHAUGHNESSY, Lesley Annette | Sekretär | 86 Fernhill Road OX5 1RR Begbroke Oxfordshire | British | 102851620001 | ||||||
BERTHELSEN, Christian | Geschäftsführer | Long Acre Covent Garden WC2E 9RA London 90 | England | Danish | Chief Technical Officer | 127022230002 | ||||
BROOKER, Geoffrey Alan | Geschäftsführer | 2 Prestidge Place OX5 2XR Kidlington Oxfordshire | England | British | Chartered Accountant/Finance D | 89868450002 | ||||
CUTHBERT, Edward Guy Thompson | Geschäftsführer | 57 Hemley Road Orsett RM16 3DG Grays Essex | England | British | Director | 58491370001 | ||||
FREEMAN, Graeme Gideon | Geschäftsführer | 106 Kelham Hall Drive Wheatley OX33 1YB Oxford Oxfordshire | British | Software | 56973700002 | |||||
GOLDBLATT, Stuart Mark | Geschäftsführer | Long Acre Covent Garden WC2E 9RA London 90 | England | British | Chief Financial Officer | 160655200002 | ||||
GOODBODY, Keith David | Geschäftsführer | 16 Cleveland Gardens Barnes SW13 0AG London | British | Software | 64423160001 | |||||
GRIBBLE, David | Geschäftsführer | 7 Strouds Meadow Cold Ash RG16 9PQ Thatcham Berkshire | British | Consultant | 6553610001 | |||||
HERBERT, Russell | Geschäftsführer | Sheephouse Cottage Stepping Stone Lane GL6 6RX Painswick Gloucestershire | British | Management Consultant | 57912870003 | |||||
HOOD, Benjamin William | Geschäftsführer | Long Acre Covent Garden WC2E 9RA London 90 | England | British | Chief Executive | 159402370002 | ||||
HOYLE, Christopher Michael | Geschäftsführer | Little Chippers Merton OX6 0NF Bicester Oxfordshire | British | Technical Director | 54528960002 | |||||
LAYZELL, Stuart Paul | Geschäftsführer | Long Acre Covent Garden WC2E 9RA London 90 United Kingdom | United Kingdom | British | None | 157984010001 | ||||
LILLEY, Derek | Geschäftsführer | Pinfold House Pinfold Lane Marthall WA16 7SN Knutsford Cheshire | England | British | Company Director | 12475750002 | ||||
LILLEY, Sharon Edwina | Geschäftsführer | Pinfold House Pinfold Lane Marthall WA16 7SN Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | Director | 22518500002 | ||||
LOVELADY, Andrew Robert | Geschäftsführer | 50 Tollemache Road CH43 8SZ Prenton Merseyside | United Kingdom | British | Director | 41693730006 | ||||
O'SHAUGHNESSY, Anthony | Geschäftsführer | 86 Fernhill Road Begbroke OX5 1RR Oxford Oxfordshire | England | British | Computer Programmer | 24813320001 | ||||
PATEL, Bijal Mahendra | Geschäftsführer | Suite 650 3440 Preston Ridge Road GA 30005 Alpharetta Hotschedules United States | United States | British | Cfo | 261857010001 | ||||
SALTERS, Richard Mark | Geschäftsführer | 4 Norton Gate Kings Norton B38 8DQ Birmingham | British | Sales And Marketing Director | 81993430001 | |||||
TRIVETT, Trevor Edward | Geschäftsführer | 9 Green Farm Adderbury OX17 3PD Banbury Oxfordshire | England | British | General Manager | 6553600001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fourth Holdings Limited In Liquidatoin | 06. Apr. 2016 | 5-7 Grosvenor Court Foregate Street CH1 1HG Chester Aaron & Partners Llp Cheshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 07. Sept. 2018 Geliefert am 12. Sept. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Please see instrument for further details. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 14. Aug. 2015 Geliefert am 18. Aug. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Part lower ground floor 90 long acre london leasehold. Part second floor 90 long acre london leasehold. Second floor greenway house tytherington business park macclesfield cheshire leasehold. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. März 2011 Geliefert am 26. März 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 18. März 2011 Geliefert am 25. März 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Jan. 2010 Geliefert am 16. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 02. Dez. 1994 Geliefert am 03. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 15. Mai 1990 Geliefert am 21. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0