SYSTEMCARE PRODUCTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SYSTEMCARE PRODUCTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02317543 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SYSTEMCARE PRODUCTS LIMITED?
- (2466) /
Wo befindet sich SYSTEMCARE PRODUCTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 99 Gresham Street Fifth Floor EC2V 7NG London Uk |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SYSTEMCARE PRODUCTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SYSTEMCARE 2000 LIMITED | 08. Feb. 1989 | 08. Feb. 1989 |
| MONCORN LIMITED | 15. Nov. 1988 | 15. Nov. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SYSTEMCARE PRODUCTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SYSTEMCARE PRODUCTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Philip Matthew Deakin am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ola Tricia Aramita Barreto-Morley am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Edward Ufland am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Giles Hudson am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für S & J Registrars Limited am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gavin Udall als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ola Tricia Aramita Barreto-Morley als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Philip Matthew Deakin als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2008 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SYSTEMCARE PRODUCTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S & J REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Gresham Street EC2V 7NG London 99 United Kingdom |
| 132600000001 | ||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Geschäftsführer | Gresham Street Fifth Floor EC2V 7NG London 99 Uk | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Geschäftsführer | Gresham Street Fifth Floor EC2V 7NG London 99 Uk | United Kingdom | British | 146225080002 | |||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Geschäftsführer | Gresham Street Fifth Floor EC2V 7NG London 99 Uk | United Kingdom | British | 161583790001 | |||||||||
| UFLAND, Edward | Geschäftsführer | Gresham Street Fifth Floor EC2V 7NG London 99 Uk | United Kingdom | British | 87558180001 | |||||||||
| BURNHOPE, Mark Edward | Sekretär | 113 Stafford Road Bloxwich WS3 3PG Walsall West Midlands | English | 60709550001 | ||||||||||
| REX, Simon John | Sekretär | Cooden Cottage 57 Station Road Fernhill Heath WR3 7UJ Worcester Worcestershire | British | 11273460001 | ||||||||||
| SHAW, John William | Sekretär | Old Hunting Lodge Worcester Road Great Witley WR6 6JT Worcester | British | 61198560001 | ||||||||||
| BURNHOPE, Mark Edward | Geschäftsführer | 113 Stafford Road Bloxwich WS3 3PG Walsall West Midlands | England | English | 60709550001 | |||||||||
| COLE, Peter Gregory | Geschäftsführer | Wightwick Mill Barn 203 Bridgnorth Road WV6 8BD Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 112413650001 | |||||||||
| GEORGE, Brian Charles | Geschäftsführer | 22 Bond End Yoxall DE13 8NH Burton On Trent Staffordshire | British | 33415800001 | ||||||||||
| HARDY, Paul | Geschäftsführer | 5 Woodhall Close CV11 6WJ Nuneaton Warwickshire | England | British | 86511850001 | |||||||||
| MCKAY, Michael William Hoy | Geschäftsführer | Peggs Farm Orton On The Hill CV9 3NE Atherstone Warwickshire | United Kingdom | British | 53050860001 | |||||||||
| REX, Simon John | Geschäftsführer | Cooden Cottage 57 Station Road Fernhill Heath WR3 7UJ Worcester Worcestershire | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | British | 11273460001 | |||||||||
| ROBINSON, Deborah | Geschäftsführer | 41 Charlotte Street WS1 2BB Walsall West Midlands | British | 27429760002 | ||||||||||
| SHAW, John William | Geschäftsführer | Old Hunting Lodge Worcester Road Great Witley WR6 6JT Worcester | United Kingdom | British | 61198560001 | |||||||||
| SKEGGS, Douglas Frederick | Geschäftsführer | Tre Ribble Barn HR2 8LS Three Ashes Herefordshire | England | British | 156791110001 | |||||||||
| UDALL, Gavin | Geschäftsführer | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 83889580001 |
Hat SYSTEMCARE PRODUCTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 03. Dez. 2004 Geliefert am 16. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Dez. 2004 Geliefert am 10. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Feb. 2001 Geliefert am 20. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. März 1998 Geliefert am 07. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Erstellt am 25. Sept. 1997 Geliefert am 27. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively in the security holder for any reason. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over book debts | Erstellt am 18. Sept. 1995 Geliefert am 29. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to or in connection with a financing agreement and all other monies due on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all book debts and other debts now and from time to time hereafter due or owing or incurred to the company other than such debts as the factor may have specifically agreed in writing to exclude from such fixed charge. Floating charge over all book debts and other debts of the company which are not charged hereunder by way of fixed charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Jan. 1995 Geliefert am 31. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage f/h property k/a victoria works, northgate, walsall, west midlands and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Jan. 1995 Geliefert am 19. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. Apr. 1992 Geliefert am 07. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 14. Jan. 1991 Geliefert am 21. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0