PPUK LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PPUK LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02322105 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PPUK LIMITED?
- (5190) /
Wo befindet sich PPUK LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ellard House Dallimore Road M23 9NX Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PPUK LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
POWERPLUS (U.K.) LIMITED | 14. Dez. 1995 | 14. Dez. 1995 |
POWERPLUS (1989) LIMITED | 10. Aug. 1989 | 10. Aug. 1989 |
TRANMULTI LIMITED | 28. Nov. 1988 | 28. Nov. 1988 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PPUK LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PPUK LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | Seiten | MG01 | ||||||||||||||
legacy | 11 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
legacy | 14 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Anthony Roger Harrison am 01. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Marcus Alan Chadwick am 29. Apr. 2010 | 3 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Kenneth Arthur Harrison am 29. Apr. 2010 | 5 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed powerplus (U.K.) LIMITED\certificate issued on 18/05/09 | Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 16 Seiten | AA |
Wer sind die Geschäftsführer von PPUK LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHADWICK, Marcus Alan | Sekretär | Dallimore Road M23 9NX Manchester Ellard House | British | 50837940002 | ||||||
HARRISON, Anthony Roger | Geschäftsführer | Ellard House Dallimore Road M23 9NX Manchester | United Kingdom | British | Engineer | 32662080002 | ||||
HARRISON, Kenneth Arthur | Geschäftsführer | Dallimore Road M23 9NX Manchester Ellard House | England | British | Engineer | 69700001 | ||||
AUBREY, Leslie Trevor | Sekretär | 23 Spencer Drive Llandough CF64 2LR Penarth South Glamorgan | British | 35123280001 | ||||||
BAGNALL, David Leonard | Sekretär | 2 Meadway Bramhall SK7 1LA Stockport Cheshire | British | 16576270001 | ||||||
CREW, Nigel James | Sekretär | 10 The Heathlands Wombourne WV5 8HF Wolverhampton | British | 50016960001 | ||||||
COYNE, Anthony Edward | Geschäftsführer | 34 Shipton Close Great Sankey WA5 5XS Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Engineer | 68413490001 | ||||
CREW, Nigel James | Geschäftsführer | 10 The Heathlands Wombourne WV5 8HF Wolverhampton | United Kingdom | British | Director | 50016960001 | ||||
HUGHES, John William | Geschäftsführer | 6 Fairmead Rise Kings Norton B38 8BS Birmingham West Midlands | British | Engineer | 16546840001 | |||||
PARNHAM, Paul Henry | Geschäftsführer | Smithy House Clotton CW6 0EH Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 116821170001 |
Hat PPUK LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 01. März 2011 Geliefert am 09. März 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Omnibus guarantee & set-off agreement | Erstellt am 01. März 2011 Geliefert am 09. März 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any one or more of the principals to the chargee and all other monies due or to become due from each of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its credit balances see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Apr. 2001 Geliefert am 11. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
First fixed charge. | Erstellt am 19. Juli 1991 Geliefert am 22. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge on book and other debts present and future and the proceeds thereof see 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 24. Okt. 1989 Geliefert am 31. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0