SIBTEC LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSIBTEC LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02323508
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SIBTEC LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich SIBTEC LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Cooper Buildings
    Arundel Street
    S1 2NS Sheffield
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SIBTEC LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für SIBTEC LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Juli 2010

    Kapitalaufstellung am 12. Juli 2010

    • Kapital: GBP 15,011
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Nigel Tomlinson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ian Proctor als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Sibtec Ltd Sheffield Technology Parks Don Valley Site 60 Shirland Lane Sheffield South Yorkshire S9 3SP am 02. Feb. 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von SIBTEC LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GREEN, Stuart Roger
    16 Spoon Way
    Stannington
    S6 6EZ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Spoon Way
    Stannington
    S6 6EZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish27140060001
    HAYES, Peter John
    Losehill Farm
    Castleton
    S33 8WB Hope Valley
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Losehill Farm
    Castleton
    S33 8WB Hope Valley
    Derbyshire
    EnglandBritish77810510001
    HIGHFIELD, Edward
    12 The Brew House Ecclesall Road
    S11 8HG Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    12 The Brew House Ecclesall Road
    S11 8HG Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish122049860001
    KAY, David Robert
    Branksome Mellor Lane
    Chapel En Le Frith
    SK23 9SA High Peak
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Branksome Mellor Lane
    Chapel En Le Frith
    SK23 9SA High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritish44045790002
    TAYLOR, Richard
    90 Ranmoor Road
    S10 3HJ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    90 Ranmoor Road
    S10 3HJ Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish105828510001
    LEVERICK, Diane Tracy
    The Dovecote
    Moat Lane Wickersley
    S66 1DZ Rotherham
    South Yorkshire
    Sekretär
    The Dovecote
    Moat Lane Wickersley
    S66 1DZ Rotherham
    South Yorkshire
    British97795990001
    WEBSTER, Howard Mark
    Brightlands 10 Park Edge
    Hathersage
    S32 1BS Hope Valley
    Derbyshire
    Sekretär
    Brightlands 10 Park Edge
    Hathersage
    S32 1BS Hope Valley
    Derbyshire
    British6207000001
    WIGFIELD, Dawn
    7 Castledale Grove
    S2 1NJ Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    7 Castledale Grove
    S2 1NJ Sheffield
    South Yorkshire
    British125037120001
    ANDERSON, Robert John, Professor
    Town Head Farm
    Longnor
    SK17 0PS Buxton
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Town Head Farm
    Longnor
    SK17 0PS Buxton
    Derbyshire
    British112128560001
    BRELSFORD, Martin Charles
    52 Wynyard Road
    Hillsborough
    S6 4GE Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    52 Wynyard Road
    Hillsborough
    S6 4GE Sheffield
    South Yorkshire
    British64885540002
    CLAYDON, Peter Christopher
    The Old Vicarage
    Beckett Road
    WFB 2DD Dewsbury
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Beckett Road
    WFB 2DD Dewsbury
    West Yorkshire
    United KingdomBritish10112450001
    CLAYDON, Peter Christopher
    The Old Vicarage
    Beckett Road
    WFB 2DD Dewsbury
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Beckett Road
    WFB 2DD Dewsbury
    West Yorkshire
    United KingdomBritish10112450001
    CORNICK, Peter Charles
    Moorgate House 2 Cavendish Avenue
    S17 3NJ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Moorgate House 2 Cavendish Avenue
    S17 3NJ Sheffield
    South Yorkshire
    British5914860001
    DUNKLEY, Sylvia Jane, Councillor Doctor
    66 Whirlowdale Road
    S7 2NJ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    66 Whirlowdale Road
    S7 2NJ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish31016220001
    FRIZELLE, Michael John
    9 Weavers Close
    S35 8RH Sheffield
    S Yorks
    Geschäftsführer
    9 Weavers Close
    S35 8RH Sheffield
    S Yorks
    United KingdomBritish29795700001
    GORMAN, Martin Philip
    8 Rochester Close
    S10 4JL Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Rochester Close
    S10 4JL Sheffield
    South Yorkshire
    British58547550001
    HANDSCOMBE, Robert Dudley, Dr
    15 Bents Drive
    S11 9RN Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    15 Bents Drive
    S11 9RN Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish11076260001
    HEATON, Christopher Charles Standring
    6 Home Farm Court
    Wortley
    S35 7DT Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    6 Home Farm Court
    Wortley
    S35 7DT Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish40217900001
    HIGHFIELD, Edward
    12 The Brew House Ecclesall Road
    S11 8HG Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    12 The Brew House Ecclesall Road
    S11 8HG Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish122049860001
    HILL, Keith Leonard
    10 Totley Brook Road
    S17 3QS Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    10 Totley Brook Road
    S17 3QS Sheffield
    South Yorkshire
    British71051710001
    HOBBS, John Michael
    11 Cedar Close
    South Ella
    HU10 7HY Hull
    North Humberside
    Geschäftsführer
    11 Cedar Close
    South Ella
    HU10 7HY Hull
    North Humberside
    EnglandBritish32848000001
    JONES, David
    154 Foxhill Road
    Foxhill
    S6 1HD Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    154 Foxhill Road
    Foxhill
    S6 1HD Sheffield
    South Yorkshire
    British73574900001
    JONES, Stephen Christopher Sutton, Councillor
    20 Pleasant Road
    S12 2BE Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Pleasant Road
    S12 2BE Sheffield
    South Yorkshire
    British4812630001
    JORDAN, William Thomas
    14 Derriman Drive
    S11 9LD Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    14 Derriman Drive
    S11 9LD Sheffield
    South Yorkshire
    British75360040001
    KIME, Nicholas Kenneth Duncan
    167 Watt Lane
    S10 5RD Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    167 Watt Lane
    S10 5RD Sheffield
    South Yorkshire
    British72108920001
    MACDONALD, Robert, Councillor
    8 Vainor Road
    S6 4AN Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Vainor Road
    S6 4AN Sheffield
    South Yorkshire
    British84723700001
    MATHEWS, George, Councillor
    36 Osberton Place
    S11 8XL Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    36 Osberton Place
    S11 8XL Sheffield
    South Yorkshire
    British29189930001
    MOYNAHAN, Laura Maria
    122 Upperthorpe
    S6 3NF Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    122 Upperthorpe
    S6 3NF Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish44999160001
    MOYNAHAN, Laura Maria
    122 Upperthorpe
    S6 3NF Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    122 Upperthorpe
    S6 3NF Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish44999160001
    PONS, Colin Michael
    1 Main Road
    Ridgeway
    S12 3XR Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Main Road
    Ridgeway
    S12 3XR Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish35691070002
    PROCTOR, Ian
    Cardoness Road
    Crosspool
    S10 5RU Sheffield
    32
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cardoness Road
    Crosspool
    S10 5RU Sheffield
    32
    South Yorkshire
    British122000970001
    PYE, Michael John
    12 Kenbourne Road
    S7 1NL Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    12 Kenbourne Road
    S7 1NL Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish8545230001
    RIPPON, Timothy Lee
    73 Ingram Road
    S2 2SB Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    73 Ingram Road
    S2 2SB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish78505570001
    RIPPON, Timothy Lee
    73 Ingram Road
    S2 2SB Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    73 Ingram Road
    S2 2SB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish78505570001
    SIMPSON, Derek
    11 William Crescent
    Mosborough
    S19 5DJ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    11 William Crescent
    Mosborough
    S19 5DJ Sheffield
    South Yorkshire
    British13886090001

    Hat SIBTEC LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 26. Mai 2006
    Geliefert am 07. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 11. Dez. 1992
    Geliefert am 17. Dez. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A charge by way of legal mortgage over all those premises consisting of two storey buildings yard and land near shirlnad lane and shortridge street both in the city of sheffield and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0