COMMUNITY CLEAN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOMMUNITY CLEAN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02324043
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COMMUNITY CLEAN LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich COMMUNITY CLEAN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite 201 Second Floor
    Design Centre East, Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von COMMUNITY CLEAN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BARCHESTER HEALTHCARE (HULL) LIMITED04. Juli 199504. Juli 1995
    BARCHESTER HEALTHCARE LIMITED11. Mai 199511. Mai 1995
    PULLBIT LIMITED01. Dez. 198801. Dez. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COMMUNITY CLEAN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für COMMUNITY CLEAN LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für COMMUNITY CLEAN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jon Hather am 09. Apr. 2014

    2 SeitenCH01
    X35JQCSA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01
    A311RMV4

    legacy

    1 SeitenSH20
    S308VEPF

    Kapitalaufstellung am 27. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19
    A309K817

    legacy

    1 SeitenCAP-SS
    S308VEP7

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account cancelled 21/01/2014
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    X2Z747ZJ

    Beendigung der Bestellung von Michael Parsons als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01
    X2K3QA8H

    Erfüllung der Belastung 20 vollständig

    4 SeitenMR04
    A2JI6KEO

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    13 SeitenAA
    A2HPP8A8

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jon Hather am 25. März 2013

    2 SeitenCH01
    X2532JGO

    legacy

    15 SeitenMG01
    A1O3PHBN

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    X1MZEDA1

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    12 SeitenAA
    A1CKV9DV

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Suite 201 the Chambers Chelsea Harbour London SW10 0XF* am 13. Dez. 2011

    1 SeitenAD01
    X0O06NRN

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    XIC87ZQV

    Ernennung von Mr Ian Portal als Sekretär

    2 SeitenAP03
    XI2WRZPS

    Beendigung der Bestellung von Jon Hather als Sekretär

    1 SeitenTM02
    XI2WQZPR

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    12 SeitenAA
    AUWQPVR1

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    X4BE2PL2

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    11 SeitenAA
    AWJ0JM4Y

    Änderung der Details des Direktors für Michael Dennis Parsons am 02. Okt. 2009

    2 SeitenCH01
    XVLDOGZT

    Änderung der Details des Direktors für Jon Hather am 02. Okt. 2009

    2 SeitenCH01
    XVLLXGZA

    Wer sind die Geschäftsführer von COMMUNITY CLEAN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PORTAL, Ian
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Sekretär
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    165001730001
    DUNCAN, David Gregor
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director97755760001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandEnglishCompany Secretary68848420006
    DUNCAN, David Gregor
    Flat 43 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    Sekretär
    Flat 43 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    BritishAccountant97755760001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Sekretär
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary68848420004
    HILL, Stuart
    Thorndyke Farm Hull Road
    Woodmansey
    HU17 0TH Beverley
    North Humberside
    Sekretär
    Thorndyke Farm Hull Road
    Woodmansey
    HU17 0TH Beverley
    North Humberside
    British38539180001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Sekretär
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director116537370001
    BROSNAN, Denis
    Croom House
    Croom
    Croom
    County Limerick
    Ireland
    Geschäftsführer
    Croom House
    Croom
    Croom
    County Limerick
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director142998660001
    HILL, Lorraine Alison
    Thorndyke Farm Hull Road
    Woodmansey
    HU17 0TH Beverley
    North Humberside
    Geschäftsführer
    Thorndyke Farm Hull Road
    Woodmansey
    HU17 0TH Beverley
    North Humberside
    BritishAdministrator38539120001
    LOMAS, Keith James
    Lyncroft
    North Buckland
    EX33 1HY Braunton
    Devon
    Geschäftsführer
    Lyncroft
    North Buckland
    EX33 1HY Braunton
    Devon
    EnglishCompany Director9290380001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    IrishDirector116537370001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director116537370001
    MCLEOD, John
    Moorfoot
    Bathpool
    PL15 7NW Launceston
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Moorfoot
    Bathpool
    PL15 7NW Launceston
    Cornwall
    BritishBritishCompany Director55599030001
    PARSONS, Michael Dennis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector44895330007
    RANN, Bryan Martin
    11 Westella Road
    Kirkella
    HU10 7QD Hull
    North Humberside
    Geschäftsführer
    11 Westella Road
    Kirkella
    HU10 7QD Hull
    North Humberside
    United KingdomBritishAdministrator102420730001

    Hat COMMUNITY CLEAN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 14. Dez. 2012
    Geliefert am 19. Dez. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Okt. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An intercreditor and subordination agreement
    Erstellt am 13. Juli 2006
    Geliefert am 25. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Subject to clause 10.2 if at any time prior to the discharge in full of the liabilities of the senior creditors, any lender or investor receives or recovers any payment or distribution of, or on account of or in relation to, any of the liabilities which is not permitted by clause 7 any amount by way of set-off in respect of any of the liabilities owed to them which does not give effect to a payment permitted by clause 7. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 25. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Subordination agreement
    Erstellt am 13. Juli 2006
    Geliefert am 20. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company as junior creditor under the subordination agreement has undertaken to the security trustee that if: any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor recieves all or any amount. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Juli 2006
    Geliefert am 20. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The bridge secured obligations being all monies due or to become due from each bridge obligor to the bridge finance parties or bridge overdraft banks (or any of them) and the opco secured obligations being all monies due or to become due from each opco obligor to the opco finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The "Securitytrustee")
    Transaktionen
    • 20. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 28 april 2005 and
    Erstellt am 07. Apr. 2005
    Geliefert am 05. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land at hardengreen dalkeith in the county of midlothian t/no MID67516 together with all existing servitude rights and other benefiting the subjects hereby secured.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Okt. 2004
    Geliefert am 02. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Cherry trees hotel stratford road alcester stratford on avon, f/h, t/n WK324489,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries(The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Nov. 2003
    Geliefert am 12. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the property known as cherry trees hotel site, stratford road, alcester t/no WK324489. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Apr. 2002
    Geliefert am 23. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage cherry trees hotel stratford road alcester stratford-on-avon warwickshire t/n WK324489. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Feb. 1994
    Geliefert am 28. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south of castle hill road,sutton and land on the east side of noddle hill way,sutton,humberside.t/nos hs 158774 hs 133501 hs 133553.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Feb. 1994
    Geliefert am 28. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The croft,wawne road,kingston upon hull,humberside.t/no.hs 40194.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 1991
    Geliefert am 11. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    One acre of land adjoining croftview nursing home wawne road sutton humberside.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 07. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    135 princes avenue kingston-upon-hull humberside t/no hs 10741.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 07. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at castle hill road sutton humberside t/nos hs 133501 & hs 133553.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 07. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying west of woodmansey grange farm woodmansey humberside t/no hs 151278.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 07. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The croft warne road kingston-upon-hull humberside t/no hs 40194.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 07. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the east side of castle hill road kinston-upon-hull humberside t/n hs 172768.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 07. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Woodmansey grange farm beverly humberside t/n hs 148062.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 07. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at castle hill road sutton humberside t/no hs 158774.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 07. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    106A albert avenue kingston-upon-hull humberside t/no hs 95400.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. März 1989
    Geliefert am 28. März 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. März 1989Registrierung einer Belastung
    • 07. Feb. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0