COTMIST LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COTMIST LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02330075 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COTMIST LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich COTMIST LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | No 1 Dorset Street SO15 2DP Southampton Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COTMIST LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COTMIST LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alexander George Bremner als Geschäftsführer am 19. Dez. 2012 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 38 Station Road Cambridge Cambridgeshire CB1 2JH am 07. Aug. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Juni 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2011 | 18 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2010 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Twenty Station Road Cambridge Cambridgeshire CB1 2JD am 26. Nov. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Karen Hill als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Alexander George Bremner als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2009 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 8 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Thwaites als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 37 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Ms Karen Marie Hill als Direktor | 1 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COTMIST LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOLES, Jonathan Christian | Sekretär | The Close CM6 1EW Great Dunmow 1 Essex | British | 146051240001 | ||||||
| TOPEL, Sven Jurgen | Geschäftsführer | Wolverstone House Pine Grove CM23 5NP Bishops Stortford Hertfordshire | England | British | 61964730001 | |||||
| WOOLES, Jonathan Christian | Geschäftsführer | 1 The Close CM6 1EW Great Dunmow Essex | England | British | 73265380001 | |||||
| CORFIELD, Nicholas Epps | Sekretär | Orchard House 53 School Lane Fulbourn CB1 5BH Cambridge Cambridgeshire | British | 40881630001 | ||||||
| DAVIS, William Edward | Sekretär | Beechcroft Wield Road GU34 5NH Medstead Alton Hampshire | British | 4522990001 | ||||||
| GRANT, Timothy Andrew | Sekretär | Rectory House Maltings Lane IP31 1NS Ingham Suffolk | British | 151692340001 | ||||||
| HALL, Geoffrey Basil | Sekretär | 5 Pinehurst RH12 2DL Horsham West Sussex | British | 8586730001 | ||||||
| REECE, Richard | Sekretär | Flora Cottage CB10 2XH Wimbish Essex | British | 147397690001 | ||||||
| CITY ROAD REGISTRARS LIMITED | Sekretär | 16-26 Banner Street EC1Y 8QE London | 36050670001 | |||||||
| BENNETT, Barry John | Geschäftsführer | 36 Carpenters Wood Drive Chorleywood WD3 5RJ Rickmansworth Hertfordshire | Irish | 14707370001 | ||||||
| BREMNER, Alexander George | Geschäftsführer | Inch Avenue Aberdour KY3 0TF Burntisland 3 Fife Scotland | Scotland | British | 152806580001 | |||||
| DAVIS, William Edward | Geschäftsführer | Beechcroft Wield Road GU34 5NH Medstead Alton Hampshire | British | 4522990001 | ||||||
| HALL, Geoffrey Basil | Geschäftsführer | 5 Pinehurst RH12 2DL Horsham West Sussex | British | 8586730001 | ||||||
| HILL, Karen Marie | Geschäftsführer | Durham Road N2 9DR London 113 | England | British | 104265470002 | |||||
| KING, John Arthur | Geschäftsführer | 6 Ashleigh Road RH12 2LF Horsham West Sussex | British | 17249890001 | ||||||
| MARSHALL, Antony Duncan Trevit | Geschäftsführer | Sway House Cottage South Sway Lane, Sway SO41 6BL Lymington Hampshire | British | 68088240001 | ||||||
| OKEN, Howard John | Geschäftsführer | Flat 16 Welsby Court Eaton Rise Ealing W5 2EX London | England | British | 13731600001 | |||||
| PURCELL, John | Geschäftsführer | 36 Packington Street Islington N1 8QB London | British | 35542020002 | ||||||
| READER, Craig Vivian | Geschäftsführer | New Pond Farm New Pond Hill TN21 0LX Cross In Hand East Sussex | United Kingdom | British | 124071700001 | |||||
| REECE, Richard | Geschäftsführer | Flora Cottage CB10 2XH Wimbish Essex | England | British | 147397690001 | |||||
| SAUNDERS, Timothy James | Geschäftsführer | 7 Crossacres Pyrford GU22 8QS Woking Surrey | British | 54603250001 | ||||||
| SMITH, Martin Timothy | Geschäftsführer | 9 Carlingnose Point KY11 1ER North Queensferry | Scotland | British | 82478070001 | |||||
| THWAITES, Paul John | Geschäftsführer | Barton House 28 Wimpole Road CB23 7AB Barton Cambridgeshire | British | 116602510001 |
Hat COTMIST LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of contracts | Erstellt am 27. Jan. 2010 Geliefert am 30. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights titles benefits and interests present and future arising out of or evidenced by the surrender agreements, with full benefit of all negotiable or non-negotiable instruments guarantees warranties. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Apr. 2002 Geliefert am 14. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Aug. 2001 Geliefert am 22. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter | |
Kurze Angaben Land on the north east side of tweed close, moulton, suffolk, forest heath, title number SK176231. Land on the wouth west side of west fen road, ely, cambridgeshire, title number CB218265. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Aug. 2001 Geliefert am 21. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The land on the north east side of tweed close, moulton, suffolk t/no SK176231.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Aug. 2001 Geliefert am 21. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The land on the south west side of west fen road, ely, cambridgeshire t/no CB218265. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Aug. 2001 Geliefert am 21. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 24. Sept. 1998 Geliefert am 07. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Each and every liability of the company to abbey national treasury services PLC (as trustee for the beneficiaries) under or pursuant to the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben 4.77 acres of land at west fen road ely with the fixtures thereon. By way of first fixed charge (1) the borrowers interest in any insurances (2) all copywrights patents and inventions and fees (3) all plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Juni 1998 Geliefert am 17. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Each and every liability due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further advances made thereunder | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1992 Geliefert am 15. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H - flat 12 crowthorne lodge crowthorne road bracknell forest berkshire title no. Bk 281855. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1992 Geliefert am 15. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H - flat 11 crowthorne lodge crowthorne road bracknell forest berkshire title no. Bk 281854. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1992 Geliefert am 15. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land and buildings known as flat 13 crowthorne lodge crowthorne road bracknell berkshire title no. Bk 281857. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1992 Geliefert am 15. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land and buildings known as flat 14 crowthorne lodge crowthorne road bracknell forest berkshire title no bk 281858. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Nov. 1989 Geliefert am 11. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £11,750 due from the company to mcinerney homes limited | |
Kurze Angaben L/H plot 14 crowthorne lodge crowthorne road bracknell berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Nov. 1989 Geliefert am 11. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £11,750 due from the company to mcinerney homes limited | |
Kurze Angaben L/H plot 12 crowthorne lodge, crowthorne road bracknell berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Nov. 1989 Geliefert am 11. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £11,750 due form the company to mcinerney homes limited | |
Kurze Angaben L/H - plot 11 crowthorne lodge, crowthorne road bracknell, bracknell berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Nov. 1989 Geliefert am 11. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £11,750 dur from the company to mcinerney homes limited | |
Kurze Angaben L/H plot 13 crowthorne lodge crowthorne road brackenell berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Nov. 1989 Geliefert am 11. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H - plot 11 crowthorne lodge, crowthorne road bracknell berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Nov. 1989 Geliefert am 11. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H plot 13 gowthorne lodge crowthorne road bracknell berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Nov. 1989 Geliefert am 11. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H - plot 12 crowthorne lodge, crowthorne road bracknell, berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Nov. 1989 Geliefert am 15. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 14 crowthorne lodge crowthorne road bracknell berks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat COTMIST LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0