COTMIST LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOTMIST LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02330075
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COTMIST LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich COTMIST LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COTMIST LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für COTMIST LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Beendigung der Bestellung von Alexander George Bremner als Geschäftsführer am 19. Dez. 2012

    2 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 38 Station Road Cambridge Cambridgeshire CB1 2JH am 07. Aug. 2012

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 30. Juli 2012

    LRESSP

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium and capital reduction cancelled 01/06/2012
    RES13

    Kapitalaufstellung am 15. Juni 2012

    • Kapital: GBP 2,170.04
    4 SeitenSH19

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2011

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    15 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2010

    20 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Twenty Station Road Cambridge Cambridgeshire CB1 2JD am 26. Nov. 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Karen Hill als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Alexander George Bremner als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2009

    20 SeitenAA

    legacy

    8 SeitenMG01

    Beendigung der Bestellung von Paul Thwaites als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    37 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Ernennung von Ms Karen Marie Hill als Direktor

    1 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von COTMIST LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WOOLES, Jonathan Christian
    The Close
    CM6 1EW Great Dunmow
    1
    Essex
    Sekretär
    The Close
    CM6 1EW Great Dunmow
    1
    Essex
    British146051240001
    TOPEL, Sven Jurgen
    Wolverstone House Pine Grove
    CM23 5NP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Wolverstone House Pine Grove
    CM23 5NP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritish61964730001
    WOOLES, Jonathan Christian
    1 The Close
    CM6 1EW Great Dunmow
    Essex
    Geschäftsführer
    1 The Close
    CM6 1EW Great Dunmow
    Essex
    EnglandBritish73265380001
    CORFIELD, Nicholas Epps
    Orchard House 53 School Lane
    Fulbourn
    CB1 5BH Cambridge
    Cambridgeshire
    Sekretär
    Orchard House 53 School Lane
    Fulbourn
    CB1 5BH Cambridge
    Cambridgeshire
    British40881630001
    DAVIS, William Edward
    Beechcroft
    Wield Road
    GU34 5NH Medstead Alton
    Hampshire
    Sekretär
    Beechcroft
    Wield Road
    GU34 5NH Medstead Alton
    Hampshire
    British4522990001
    GRANT, Timothy Andrew
    Rectory House
    Maltings Lane
    IP31 1NS Ingham
    Suffolk
    Sekretär
    Rectory House
    Maltings Lane
    IP31 1NS Ingham
    Suffolk
    British151692340001
    HALL, Geoffrey Basil
    5 Pinehurst
    RH12 2DL Horsham
    West Sussex
    Sekretär
    5 Pinehurst
    RH12 2DL Horsham
    West Sussex
    British8586730001
    REECE, Richard
    Flora Cottage
    CB10 2XH Wimbish
    Essex
    Sekretär
    Flora Cottage
    CB10 2XH Wimbish
    Essex
    British147397690001
    CITY ROAD REGISTRARS LIMITED
    16-26 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    Sekretär
    16-26 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    36050670001
    BENNETT, Barry John
    36 Carpenters Wood Drive
    Chorleywood
    WD3 5RJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    36 Carpenters Wood Drive
    Chorleywood
    WD3 5RJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Irish14707370001
    BREMNER, Alexander George
    Inch Avenue
    Aberdour
    KY3 0TF Burntisland
    3
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    Inch Avenue
    Aberdour
    KY3 0TF Burntisland
    3
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritish152806580001
    DAVIS, William Edward
    Beechcroft
    Wield Road
    GU34 5NH Medstead Alton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Beechcroft
    Wield Road
    GU34 5NH Medstead Alton
    Hampshire
    British4522990001
    HALL, Geoffrey Basil
    5 Pinehurst
    RH12 2DL Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    5 Pinehurst
    RH12 2DL Horsham
    West Sussex
    British8586730001
    HILL, Karen Marie
    Durham Road
    N2 9DR London
    113
    Geschäftsführer
    Durham Road
    N2 9DR London
    113
    EnglandBritish104265470002
    KING, John Arthur
    6 Ashleigh Road
    RH12 2LF Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    6 Ashleigh Road
    RH12 2LF Horsham
    West Sussex
    British17249890001
    MARSHALL, Antony Duncan Trevit
    Sway House Cottage
    South Sway Lane, Sway
    SO41 6BL Lymington
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Sway House Cottage
    South Sway Lane, Sway
    SO41 6BL Lymington
    Hampshire
    British68088240001
    OKEN, Howard John
    Flat 16 Welsby Court
    Eaton Rise Ealing
    W5 2EX London
    Geschäftsführer
    Flat 16 Welsby Court
    Eaton Rise Ealing
    W5 2EX London
    EnglandBritish13731600001
    PURCELL, John
    36 Packington Street
    Islington
    N1 8QB London
    Geschäftsführer
    36 Packington Street
    Islington
    N1 8QB London
    British35542020002
    READER, Craig Vivian
    New Pond Farm
    New Pond Hill
    TN21 0LX Cross In Hand
    East Sussex
    Geschäftsführer
    New Pond Farm
    New Pond Hill
    TN21 0LX Cross In Hand
    East Sussex
    United KingdomBritish124071700001
    REECE, Richard
    Flora Cottage
    CB10 2XH Wimbish
    Essex
    Geschäftsführer
    Flora Cottage
    CB10 2XH Wimbish
    Essex
    EnglandBritish147397690001
    SAUNDERS, Timothy James
    7 Crossacres
    Pyrford
    GU22 8QS Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    7 Crossacres
    Pyrford
    GU22 8QS Woking
    Surrey
    British54603250001
    SMITH, Martin Timothy
    9 Carlingnose Point
    KY11 1ER North Queensferry
    Geschäftsführer
    9 Carlingnose Point
    KY11 1ER North Queensferry
    ScotlandBritish82478070001
    THWAITES, Paul John
    Barton House 28 Wimpole Road
    CB23 7AB Barton
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Barton House 28 Wimpole Road
    CB23 7AB Barton
    Cambridgeshire
    British116602510001

    Hat COTMIST LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignment of contracts
    Erstellt am 27. Jan. 2010
    Geliefert am 30. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights titles benefits and interests present and future arising out of or evidenced by the surrender agreements, with full benefit of all negotiable or non-negotiable instruments guarantees warranties. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2002
    Geliefert am 14. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(The Security Trustee) and the Finance Parties (as Defined) or Any of Them
    Transaktionen
    • 14. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2001
    Geliefert am 22. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter
    Kurze Angaben
    Land on the north east side of tweed close, moulton, suffolk, forest heath, title number SK176231. Land on the wouth west side of west fen road, ely, cambridgeshire, title number CB218265. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Close Asset Management Holdings Limited
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Aug. 2001
    Geliefert am 21. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The land on the north east side of tweed close, moulton, suffolk t/no SK176231.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Aug. 2001
    Geliefert am 21. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The land on the south west side of west fen road, ely, cambridgeshire t/no CB218265. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2001
    Geliefert am 21. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 24. Sept. 1998
    Geliefert am 07. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability of the company to abbey national treasury services PLC (as trustee for the beneficiaries) under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    4.77 acres of land at west fen road ely with the fixtures thereon. By way of first fixed charge (1) the borrowers interest in any insurances (2) all copywrights patents and inventions and fees (3) all plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC(As Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juni 1998
    Geliefert am 17. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further advances made thereunder
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC (As Trustee for the Beneficiaries (as Defined in the Deed))
    Transaktionen
    • 17. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 1992
    Geliefert am 15. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H - flat 12 crowthorne lodge crowthorne road bracknell forest berkshire title no. Bk 281855. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 1992
    Geliefert am 15. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H - flat 11 crowthorne lodge crowthorne road bracknell forest berkshire title no. Bk 281854. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 1992
    Geliefert am 15. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings known as flat 13 crowthorne lodge crowthorne road bracknell berkshire title no. Bk 281857. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 1992
    Geliefert am 15. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings known as flat 14 crowthorne lodge crowthorne road bracknell forest berkshire title no bk 281858. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 1989
    Geliefert am 11. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £11,750 due from the company to mcinerney homes limited
    Kurze Angaben
    L/H plot 14 crowthorne lodge crowthorne road bracknell berkshire.
    Berechtigte Personen
    • Mcinerney Homes Limited
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 29. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 1989
    Geliefert am 11. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £11,750 due from the company to mcinerney homes limited
    Kurze Angaben
    L/H plot 12 crowthorne lodge, crowthorne road bracknell berkshire.
    Berechtigte Personen
    • Mcinerney Homes Limited
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 06. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A registered charge
    Erstellt am 07. Nov. 1989
    Geliefert am 11. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £11,750 due form the company to mcinerney homes limited
    Kurze Angaben
    L/H - plot 11 crowthorne lodge, crowthorne road bracknell, bracknell berkshire.
    Berechtigte Personen
    • Mcinerney Homes Limited
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 29. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 1989
    Geliefert am 11. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £11,750 dur from the company to mcinerney homes limited
    Kurze Angaben
    L/H plot 13 crowthorne lodge crowthorne road brackenell berkshire.
    Berechtigte Personen
    • Mcinerney Homes Limited
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 16. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 1989
    Geliefert am 11. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H - plot 11 crowthorne lodge, crowthorne road bracknell berkshire.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 15. Feb. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 1989
    Geliefert am 11. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H plot 13 gowthorne lodge crowthorne road bracknell berkshire.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 15. Feb. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 1989
    Geliefert am 11. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H - plot 12 crowthorne lodge, crowthorne road bracknell, berkshire.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 15. Feb. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 1989
    Geliefert am 15. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    14 crowthorne lodge crowthorne road bracknell berks.
    Berechtigte Personen
    • Mcinerney Homes LTD
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1989Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat COTMIST LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Juli 2012Beginn der Liquidation
    09. Juli 2013Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praktiker
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0