LIVERLINE TRAVEL SERVICES LIMITED

LIVERLINE TRAVEL SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLIVERLINE TRAVEL SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02330730
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LIVERLINE TRAVEL SERVICES LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich LIVERLINE TRAVEL SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LIVERLINE TRAVEL SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NORTHUMBRIA REALTY (1988) LIMITED22. Dez. 198822. Dez. 1988

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LIVERLINE TRAVEL SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für LIVERLINE TRAVEL SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Admiral Way Doxford Int Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP am 14. Sept. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 04. Sept. 2012

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Philip Martin Stone als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Greaves als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nigel Paul Featham als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    6 SeitenAA

    Ernennung von Kenneth Mcintyre Carlaw als Direktor am 18. Juli 2012

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 26. Mai 2012

    1 SeitenCH03

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Dez. 2011

    Kapitalaufstellung am 16. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    11 SeitenAA

    Ernennung von Nigel Paul Featham als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan May als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Philip Martin Stone am 14. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für John Greaves am 14. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Paul May am 14. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 14. Dez. 2009

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    9 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von LIVERLINE TRAVEL SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Sekretär
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    Geschäftsführer
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    EnglandBritish161250030001
    CAMPBELL, David Gerard
    47 Ridgely Drive
    Ponteland
    NE20 9BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    47 Ridgely Drive
    Ponteland
    NE20 9BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8159840001
    JONES, Michael Adrian
    5 Sandycroft
    Warsash
    SO31 9AA Southampton
    Hampshire
    Sekretär
    5 Sandycroft
    Warsash
    SO31 9AA Southampton
    Hampshire
    British36134870001
    MONAGHAN, David Bell
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Sekretär
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British35862500001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Sekretär
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    FEATHAM, Nigel Paul
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    EnglandBritish161124990001
    FICKLING, John Matthew
    62 Gainsborough Close
    NE25 9XB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    62 Gainsborough Close
    NE25 9XB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British40818470001
    GREAVES, John
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish40433200001
    HIND, Robert Andrew
    18 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8QZ Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    18 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8QZ Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish21961900002
    HINDMARSH, Patricia Gail
    3 Ainderby Road
    Throckley
    NE15 9DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    3 Ainderby Road
    Throckley
    NE15 9DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British40429750001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    KENNAN, Anthony Denis
    13 The Poplars
    Gosforth
    NE3 4AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    13 The Poplars
    Gosforth
    NE3 4AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8159860001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Geschäftsführer
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MAY, Jonathan Paul
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish125675730002
    MONAGHAN, David Bell
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British35862500001
    NOBLE, Stephen Leslie
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    United KingdomBritish128655430001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Geschäftsführer
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    STONE, Philip Martin
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    EnglandBritish69200640003
    STONE, Philip Martin
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Geschäftsführer
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish69200640003
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish67622780002
    WILLIAMS, Dawson Thomas
    Coed Del
    Badgers Close Ashley Heath
    BH24 2SH Ringwood
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Coed Del
    Badgers Close Ashley Heath
    BH24 2SH Ringwood
    Hampshire
    British2719600001

    Hat LIVERLINE TRAVEL SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Erstellt am 15. Aug. 1994
    Geliefert am 31. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Kurze Angaben
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 11. Aug. 1994
    Geliefert am 26. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement dated 4TH may 1994, any interest rate agreement, or any of the security documents (as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tthe First National Bank of Boston"the Agent"
    Transaktionen
    • 26. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1992
    Geliefert am 02. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings on the south side of london road northfleet t/no. K647227 with all buildings & fixtures.....see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 02. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1992
    Geliefert am 02. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings on the south west side of london road & north west side of barretts road, dunton green, sevenoaks kent t/nos. K647228 & K513298 with all buildings & fixtures....see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 02. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Juli 1990
    Geliefert am 23. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from proudmental fleet management limited and/or any of the other companies named to the chargee under the terms of this charge and pursuant to a loan agreement of even date.
    Kurze Angaben
    The property specified on from m 395, re m 226. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Charted Bank as Agent and Trustee for Itself and Dresdner Bank A.G.
    Transaktionen
    • 23. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Juli 1990
    Geliefert am 23. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property specipied on form m 395, re m 253. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 23. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Jan. 1990
    Geliefert am 29. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property at scremerston, nr berwick upon tweed, northumberland see 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chrtered Bank
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Aug. 1989
    Geliefert am 31. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LIVERLINE TRAVEL SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Apr. 2013Aufgelöst am
    04. Sept. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praktiker
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praktiker
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0