LARSTRIKE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LARSTRIKE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02337990 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LARSTRIKE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LARSTRIKE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LARSTRIKE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LARSTRIKE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 24. Juli 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresr ückblick erstellt bis 15. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für William James Buchan am 27. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Neil Midmer am 27. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Kamma Foulkes am 27. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für William David Mcleish am 27. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LARSTRIKE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| FEENEY, Martin | Sekretär | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Sekretär | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Sekretär | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Sekretär | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Sekretär | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158305150001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| MITCHELL, Andrew Ross | Sekretär | Highwood PA13 4TA Kilmacolm Refrewshire | British | 25359180002 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Sekretär | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Sekretär | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| ABLETT, Julie | Geschäftsführer | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BARLOW, George Edward | Geschäftsführer | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Geschäftsführer | Pipers Cottage Grove Heath Road Ripley GU23 6EU Woking Surrey | American | 51593550001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| CHISMAN, Ronald Neil | Geschäftsführer | 1 Beaufort Close SW15 3TL London | United Kingdom | British | 780950001 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| DENNY, Nigel John | Geschäftsführer | Brook House The Manor Potton SG19 2RN Sandy Bedfordshire | British | 53339290001 | ||||||
| FARRALL, Elaine Ann | Geschäftsführer | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Geschäftsführer | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Geschäftsführer | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Geschäftsführer | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Geschäftsführer | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Geschäftsführer | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LAWRENCE, Stephen John | Geschäftsführer | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | 5579020001 | |||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MACKAY, William Donald | Geschäftsführer | 79 Tweedsmuir Road G52 2RX Glasgow | British | 796730001 | ||||||
| MCINTEER, Warren Hill | Geschäftsführer | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MICHELS, David Michael Charles | Geschäftsführer | 15 Court Drive HA7 4QH Stanmore Middlesex | British | 4855250001 | ||||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Geschäftsführer | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| PHIPPEN, Kent William | Geschäftsführer | 12 Elm Tree Road St Johns Wood NW8 9JX London | United Kingdom | American | 84576560001 | |||||
| RHODES, Colin Eric | Geschäftsführer | 12 Alexandra Park Lenzie G66 5BH Glasgow | British | 3918330003 |
Hat LARSTRIKE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Commercial legal charge | Erstellt am 04. Aug. 1999 Geliefert am 20. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The dets and rental sums as referred to in the governor and company of the bank of scotland's commercial charge conditions (1995 edition) as filed at h/m/ land registry under reference MD308F/01 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land and buildings on the west side of lode lane solihull k/a salisbury court nursing home 21 lodge lane B91 2AB t/n WM63362. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Commercial legal charge | Erstellt am 04. Aug. 1999 Geliefert am 20. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The debts and rental sums referred to in the governor and company of the bank of scotland's commercial charge conditions (1995 edition) as filed at H.M.land registry under reference no MD308F/01 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Broomcroft house eccleshall road sheffield S11 9DY t/n LA108098. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1997 Geliefert am 04. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the credit documents and/or the security documents (all as defined in the legal charge) | |
Kurze Angaben Property charged being heathland court (formerly k/a heathlands) parkside wimbledon london borough of merton t/no;-SY232477. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1997 Geliefert am 04. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the credit documents and/or the security documents (all as defined in the legal charge) | |
Kurze Angaben Property charged being brunswick court 62 stratford road (formerly mardalke hempstead road) watford t/no;-HD282592. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Dez. 1996 Geliefert am 08. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the credit documents and/or the security documents | |
Kurze Angaben Wingham house oaken lane claygate surrey/elmbridge part t/n: SY643948 and all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery the insurances the ancillary rights relating to the property and income the goodwill of the business and the benefit of all licences floating charge all furnishings and fittings and all machinery equipment chattels consumables and stocks. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Sept. 1996 Geliefert am 18. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities now due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the credit documents and/or the security documents (as defined) and this charge | |
Kurze Angaben The property k/a hill house high street elstree herts t/no hd 306249. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 22. Jan. 1995 Erworben am 21. Nov. 1996 Geliefert am 30. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums of principal interest and expenses now due or to become due fromthe company to the chargee pursuant to the terms of the charge | |
Kurze Angaben That plot of ground k/a annfield house stirling t/no stg 9911. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 01. Feb. 1993 Geliefert am 19. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the facility documents and/or the security documents as defined in this deed | |
Kurze Angaben See doc ref M114 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Aug. 1991 Geliefert am 03. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to teh chargee for itself and as agent for the banks (as defined in the charge). On any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Floating charge charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Aug. 1991 Geliefert am 03. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0