J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED

J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJ. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02339787
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED?

    • (9305) /

    Wo befindet sich J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp
    St Nicholas House Park Row
    NG1 6FQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Welche sind die letzten Einreichungen für J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Nov. 2010

    10 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    8 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Mai 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Nov. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Mai 2009

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Nov. 2008

    5 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:replacement of liquidator
    6 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Nov. 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    8 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Wer sind die Geschäftsführer von J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    THOM, Colin
    28 Laureston Drive
    LE2 2AQ Leicester
    Leicestershire
    Sekretär
    28 Laureston Drive
    LE2 2AQ Leicester
    Leicestershire
    British72322870002
    POWNALL, David Michael
    The Old Chapel 35 Main Street
    Kinoulton
    NG12 3EA Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Old Chapel 35 Main Street
    Kinoulton
    NG12 3EA Nottingham
    Nottinghamshire
    British78687410002
    POWNALL, Michael
    2 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    2 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    British9610500001
    BROWN, Christopher Frank
    16 Whatton Oaks
    Rothley
    LE7 7QE Leicester
    Sekretär
    16 Whatton Oaks
    Rothley
    LE7 7QE Leicester
    British61859510001
    TURNER, Andrew Richard
    Rose Cottage Bleasby Road
    Thurgarton
    NG14 7FW Nottingham
    Sekretär
    Rose Cottage Bleasby Road
    Thurgarton
    NG14 7FW Nottingham
    British74225120001
    SPALDING, Andrew
    Field House 2 Manor Court
    Willoughby On The Wolds
    LE12 6SS Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Field House 2 Manor Court
    Willoughby On The Wolds
    LE12 6SS Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish43693090001
    WAINE, Paul
    35 Quayside Close
    NG2 3BP Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    35 Quayside Close
    NG2 3BP Nottingham
    Nottinghamshire
    British9756380001

    Hat J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 19. Mai 2000
    Geliefert am 01. Juni 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the finance documents or any other document
    Kurze Angaben
    The property known as land on the north west side of harrimans lane, dunkirk t/no:288435 and the proceeds of sale thereof and all compensation or grants payable or paid to or recoverable by the mortgagor in respect of the property and all other estates and interests which the mortgagor may have in the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transaktionen
    • 01. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 19. Mai 2000
    Geliefert am 01. Juni 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever whether incurred under the finance documents or any other documents (all as defined therein)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transaktionen
    • 01. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2001Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 19. Jan. 2006Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (405 (2))
    Mortgage
    Erstellt am 21. Feb. 2000
    Geliefert am 23. Feb. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 20 august 19999 as varied by a novation agreement documented by an exchange of letters dated 10 january 2000 and 14 january 2000 and other monies due under this deed
    Kurze Angaben
    All debts arising from the sale of aluminium deoxidants or other products supplied by the chargee to the company under the agreement.
    Berechtigte Personen
    • Tinfos Nizi S.A.
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of certain debts
    Erstellt am 20. Aug. 1999
    Geliefert am 27. Aug. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 20TH august 1999 and/or this mortgage
    Kurze Angaben
    All debts arising from the sale of goods by the company to british stell pursuant to an agreement dated 20TH august 1999.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Compagnie Des Mines Et Metaux S.A.
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage supplemental to a mortgage debenture dated 4 june 1990 issued by the company
    Erstellt am 23. Apr. 1999
    Geliefert am 07. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assignment of the items listed below (the equipment) including any part or parts thereof and all additional alterations and accessories replacements and renewals of component parts thereto together with the benefit of all obligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the equipment and all other obligations and warranties given by any other party in respect of the equipment to or in favour of the company and without prejudice to the generality of the foregoing the benefit of all maintenance agreements entered into between the company and any such third party; items: multi melting furnace.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 26. März 1999
    Geliefert am 10. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due from nottingham metal recyclers limited to the chargees and intended to be secured by this mortgage including a loan by michael pownall (the first lender) of £200,000 ,a loan by michael pownall of £250,000 ,a loan by margaret annette pownall (the second lender) of £20,000 and any sums due under guarantees dated 10TH march 1999
    Kurze Angaben
    The assignment by way of security of the schematic melting furnace with ancillary equipment located at alcester street dunkirk nottingham NG7 2SF and a floating charge over all other plant machinery furniture equipment and other tangible assets.
    Berechtigte Personen
    • Michael Pownall
    • Margaret Annette Pownall
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of chattels
    Erstellt am 28. Nov. 1995
    Geliefert am 28. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,000,000 due from the company to the chargee pursuant to a master hire purchase agreement made the 27TH september 1995 and hiring contract made the 28TH november 1995
    Kurze Angaben
    Schematic melting unit with ancillary equipment located at alcester street dunkirk nottingham NG7 2SF as more full described in the mortgage of chattels.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Okt. 1990
    Geliefert am 26. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Initial Leasing Limited
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 06. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over contruct
    Erstellt am 26. Sept. 1990
    Geliefert am 11. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All benefit of rebate of rentals payments from a leasing agreement.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 06. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Juni 1990
    Geliefert am 14. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 06. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat J. MCINTYRE (ALUMINIUM) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Mai 2001Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Gurpil Singh Johal
    Kroll Limited
    Aspect Court
    B2 5HG 4 Temple Row
    Birmingham
    Praktiker
    Kroll Limited
    Aspect Court
    B2 5HG 4 Temple Row
    Birmingham
    Lee Antony Manning
    Aspect Court
    4 Temple Row
    B2 5HG Birmingham
    Praktiker
    Aspect Court
    4 Temple Row
    B2 5HG Birmingham
    2
    DatumTyp
    27. Mai 2005Beginn der Liquidation
    05. Apr. 2011Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Allan Watson Graham
    Kpmg
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    Praktiker
    Kpmg
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    James Douglas Ernle Money
    Kpmg Llp
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    Praktiker
    Kpmg Llp
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praktiker
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0