CUNDELL GROUP HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CUNDELL GROUP HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02340016 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CUNDELL GROUP HOLDINGS LIMITED?
- Herstellung anderer Behälter aus Papier und Pappe (17219) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich CUNDELL GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o SMURFIT KAPPA UK LTD Cunard Building Water Street L3 1SF Liverpool |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CUNDELL GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FOUR HUNDRED AND SIXTY SECOND SHELF TRADING COMPANYLIMITED | 26. Jan. 1989 | 26. Jan. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CUNDELL GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CUNDELL GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse | 2 Seiten | SH08 | ||||||||||
Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte | 2 Seiten | SH10 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Nicola Pritchard am 31. Mai 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Nicola Pritchard am 31. Mai 2018 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CUNDELL GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALES, Nicola | Sekretär | c/o Smurfit Kappa Uk Ltd Water Street L3 1SF Liverpool Cunard Building United Kingdom | 171698830002 | |||||||
| HALES, Nicola | Geschäftsführer | c/o Smurfit Kappa Uk Ltd Water Street L3 1SF Liverpool Cunard Building United Kingdom | United Kingdom | British | 149752060003 | |||||
| MCNEILL, Patrick | Geschäftsführer | 15 Saxon Close Appleton WA4 5SD Warrington Cheshire | England | British | 111170280001 | |||||
| BUCK, Robert Irving | Sekretär | 4 Autumn Walk Wargrave RG10 8BS Reading Berkshire | British | 21278640001 | ||||||
| CLAYTON, Michael James | Sekretär | The Old Mill Ireby CA7 1DS Wigton Cumbria | British | 4036940005 | ||||||
| CLISH, Keith | Sekretär | 8 Birkdale Gardens DH1 2UJ Durham City County Durham | British | 111750070001 | ||||||
| WILLIS, Martin John | Sekretär | Longacre The Village Willingale CM5 0SJ Ongar Essex | British | 35350380001 | ||||||
| BAILEY, Trevor Howard | Geschäftsführer | 2 The Beacons Beaconsfield Road AL10 8EQ Hatfield Hertfordshire | British | 15206530003 | ||||||
| BARRETT, Patrick Augustine | Geschäftsführer | The Chestnuts Hurley SL6 5LN Maidenhead | British | 941830001 | ||||||
| BRADLEY, David | Geschäftsführer | Hambleton Grange Burton Leonard HG3 3RX Harrogate North Yorkshire | British | 65302630001 | ||||||
| BUCK, Robert Irving | Geschäftsführer | 4 Autumn Walk Wargrave RG10 8BS Reading Berkshire | British | 21278640001 | ||||||
| CLAYTON, Michael James | Geschäftsführer | The Old Mill Ireby CA7 1DS Wigton Cumbria | British | 4036940005 | ||||||
| CLISH, Keith | Geschäftsführer | 8 Birkdale Gardens DH1 2UJ Durham City County Durham | United Kingdom | British | 111750070001 | |||||
| COGHLAN, John Patrick | Geschäftsführer | 6 Scholars Mews AL8 7JQ Welwyn Garden City Hertfordshire | Irish | 68846400002 | ||||||
| FIX, Brian Stanley | Geschäftsführer | Barnfield Spring Elms Lane Little Baddow CM3 4SQ Chelmsford Essex | British | 2873300001 | ||||||
| FOX, William Russell | Geschäftsführer | Autumn House Bradbury TS21 2ET Bradbury Cleveland | England | British | 198580800001 | |||||
| GILHAM, Kenneth Frank | Geschäftsführer | Barbers Orchard Colam Lane Little Baddow CM3 4SY Chelmsford Essex | British | 44029610001 | ||||||
| KERSLAKE, John Wilfred Ernest | Geschäftsführer | 5 Crescent Drive Shenfield CM15 8DS Brentwood Essex | England | British | 50508990001 | |||||
| KILROY, Howard Edward | Geschäftsführer | 129 Old Church Street Chelsea SW3 6EB London | Irish | 10864480001 | ||||||
| ROBERTSON, James Alexander | Geschäftsführer | PO BOX 25 Great Braitch Lane AL10 9PX Hatfield Hertfordshire | Irish | 39090290001 | ||||||
| SMURFIT, Dermot Francis, Dr | Geschäftsführer | 12 Gloucester Gate NW1 4HG London | Irish | 81453700002 | ||||||
| SMURFIT, Michael William | Geschäftsführer | Villa Les Bruyeres 1 Place Sainte Devote Monte Carlo 98000 Monaco | Irish | 18910210002 | ||||||
| TUCKER, Arthur James | Geschäftsführer | 12 Hop Gardens RG9 2EH Henley On Thames Oxfordshire | England | British | 5713020001 | |||||
| WOOLLARD, Andrew John | Geschäftsführer | Greystones Farm Eppleby DL11 7AJ Richmond North Yorkshire | United Kingdom | British | 69151240003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CUNDELL GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smurfit Kappa Investments Uk Limited | 06. Apr. 2016 | Water Street L3 1SF Liverpool Cunard Building England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CUNDELL GROUP HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 01. März 2006 Geliefert am 15. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Dez. 2002 Geliefert am 09. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the company and each other chargor to the secured creditors to the spanish bond creditors (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Dez. 2002 Geliefert am 09. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other chargor to the secured creditors (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Dez. 2002 Geliefert am 09. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other chargor to the secured creditors (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Sept. 2002 Geliefert am 04. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0