MKD HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMKD HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02340362
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MKD HOLDINGS LIMITED?

    • (3614) /
    • (5244) /

    Wo befindet sich MKD HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kroll
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MKD HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MOBEN KITCHENS DIRECT LIMITED04. Mai 198904. Mai 1989
    ALNERY NO. 826 LIMITED27. Jan. 198927. Jan. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MKD HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2005

    Welche sind die letzten Einreichungen für MKD HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 04. Okt. 2008

    14 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Okt. 2008

    15 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Kündigung eines Administrators

    9 Seiten2.38B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    15 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht

    20 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    44 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    24 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    25 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von MKD HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MURPHY, John
    Eagles View
    46 Burford Lane
    WA13 0SH Lymm
    Cheshire
    Sekretär
    Eagles View
    46 Burford Lane
    WA13 0SH Lymm
    Cheshire
    British28789400004
    BENNETT, Yvonne Elizabeth
    Farm View
    Long Reach
    KT24 6LZ West Horsley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Farm View
    Long Reach
    KT24 6LZ West Horsley
    Surrey
    British92978920001
    GAASTRA, Stephen
    Long Meadow House Mill Lane
    CB25 0NF Swaffham Bulbeck
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Long Meadow House Mill Lane
    CB25 0NF Swaffham Bulbeck
    Cambridgeshire
    EnglandBritish96778910001
    GOODING, Christopher Thomas
    4 Hook Hill Park
    GU22 0PX Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Hook Hill Park
    GU22 0PX Woking
    Surrey
    British101921460001
    GOSAL, Kulvant Singh
    3 Church House
    Manor Lane
    CV35 0JT Kineton
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    3 Church House
    Manor Lane
    CV35 0JT Kineton
    Warwickshire
    British101921440001
    POVEY, Roy
    10 Westbourne Grove
    M33 6RD Sale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    10 Westbourne Grove
    M33 6RD Sale
    Cheshire
    EnglandBritish254100460001
    SLOWEY, Neil Patrick
    7 Newby Close
    BL9 9GG Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Newby Close
    BL9 9GG Bury
    Lancashire
    United KingdomBritish101731390001
    VICENTE, Joaquim Antonio Clara
    112 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    112 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    EnglandPortuguese104002590002
    LEWIS, Ashley Martin
    Bollinway
    Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    The Spinney
    Cheshire
    Sekretär
    Bollinway
    Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    The Spinney
    Cheshire
    British136948910001
    BOLER, Stephen Eckersley
    Wrenshot Wrenshot Lane
    High Legh
    WA16 6PG Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Wrenshot Wrenshot Lane
    High Legh
    WA16 6PG Knutsford
    Cheshire
    British19357700001
    CARR, Anthony
    27 Rutland Road
    PR8 6PB Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    27 Rutland Road
    PR8 6PB Southport
    Merseyside
    British14170250001
    COTTER, Stephen Anthony
    Bracken
    Plantation Road
    LU7 3HT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Bracken
    Plantation Road
    LU7 3HT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    EnglandBritish78750100001
    DILWORTH, Eric Alain
    Cockers Farm House
    Long Lane Limbrick
    PR6 9EE Chorley
    Geschäftsführer
    Cockers Farm House
    Long Lane Limbrick
    PR6 9EE Chorley
    British87217710001
    HENDER, Thomas
    Wheatmans Cottage
    2 Lapworth Street
    BG5 5ES Lowsonford
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Wheatmans Cottage
    2 Lapworth Street
    BG5 5ES Lowsonford
    Warwickshire
    British39104570002
    HILL, Derek William
    53 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    53 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    British105971130001
    HILL, Philip Nigel
    19 Whitland Avenue
    BL1 5FB Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    19 Whitland Avenue
    BL1 5FB Bolton
    Lancashire
    British66695480001
    HOLDEN, Gavin
    The Red House
    Lower Street
    TN33 9ED Ninfield Battle
    East Sussex
    Geschäftsführer
    The Red House
    Lower Street
    TN33 9ED Ninfield Battle
    East Sussex
    British101921430001
    LEWIS, Ashley Martin
    Bollinway
    Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    The Spinney
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Bollinway
    Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    The Spinney
    Cheshire
    EnglandBritish136948910001
    LYNSKEY, Peter John
    Fairleigh Hinderton Lane
    Neston
    CH64 9QA South Wirral
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Fairleigh Hinderton Lane
    Neston
    CH64 9QA South Wirral
    Cheshire
    United KingdomBritish25563190001
    MURPHY, John
    25 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    25 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    British28789400001
    MURRAY, William John
    Annells
    Cowfold Lane
    RG27 9BP Rotherwick
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Annells
    Cowfold Lane
    RG27 9BP Rotherwick
    Hampshire
    British34787230004
    SAMSON, Harvey Jack
    1 Acacia Drive
    Hale
    WA15 8QZ Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    1 Acacia Drive
    Hale
    WA15 8QZ Altrincham
    Cheshire
    British3650740001
    STANWAY, Andrew David
    Beechcroft House
    Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Beechcroft House
    Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    United Kingdom British 31199160002
    WATTS, Stephen John
    455 Cockfosters Road
    EN4 0JT Hadleywood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    455 Cockfosters Road
    EN4 0JT Hadleywood
    Hertfordshire
    British37062200001
    WEST, Geoffrey Arthur
    31 Vale Close
    Heaton Norris
    SK4 5DS Stockport
    Geschäftsführer
    31 Vale Close
    Heaton Norris
    SK4 5DS Stockport
    British23989730001
    WHITE, Joseph Kenneth
    Rushafield Farm Green Lane
    SK14 3BD Hyde
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Rushafield Farm Green Lane
    SK14 3BD Hyde
    Cheshire
    EnglandBritish23989740001
    WILSON, Jenny Charles
    8 Rochfield Avenue
    M25 7PS Whitefield
    Manchester
    Geschäftsführer
    8 Rochfield Avenue
    M25 7PS Whitefield
    Manchester
    British23989770001

    Hat MKD HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Jan. 2004
    Geliefert am 13. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to any security beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H and l/h premises at cornbrook 2 brindley road old trafford manchester t/n's GM355091, GM356519, GM356520 and GM371063. The plot of land lying to the north west of chester road old trafford manchester t/n GM289483. Plot 3 springvale on the west side of black county route bilston t/n GM647649 for details of further property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Canven (C.I.) Limited (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 09. Aug. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to any security beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H and l/h premises at cornbrook, 2 brindley road, old trafford, manchester, M16 9HQ t/nos GM355091, GM356519, GM356520 and GM371063, the plot of land lying to the north west of chester road, old trafford, manchester t/n GM289483, plot 3, springvale on the west side of black county route, bilston t/n GM647649 (refer to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Canven (C.I.) Limited (the "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Sept. 2001
    Geliefert am 19. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (as defined),or any of them,under the banking documents (as defined)
    Kurze Angaben
    L/Hold land lying to the north west of chester rd,old trafford,manchester; t/no gm 289483. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Okt. 2000
    Geliefert am 15. Nov. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee (the security trustee) and the security beneficiaries (as defined) or any of them under the banking documents (as defined)
    Kurze Angaben
    F/H and l/h land k/a cornbrook 2 brindley road old trafford manchester t/nos. GM355091, GM356519, GM356520 and GM371063.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of accession (to a composite guarantee and debenture dated 10TH august 2000)
    Erstellt am 30. Okt. 2000
    Geliefert am 15. Nov. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee (the security trustee) and the security beneficiaries (as defined) or any of them under the banking documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 02. Aug. 1999
    Geliefert am 06. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 08. Okt. 1998
    Geliefert am 14. Okt. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,500 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed
    Kurze Angaben
    £1,500.
    Berechtigte Personen
    • Enfranchise 226 Limited
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 19. Juli 1995
    Geliefert am 22. Juli 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The whole or any part of the rents reserved by a lease or any money payable pursuant to the lease or any expense incurred by the landlord in consequence of any failure by the tenant to observe and perform the covenants and obligations of and the conditions binding the tenant contained in the lease
    Kurze Angaben
    £1,500 and accrued interest.
    Berechtigte Personen
    • Highcross Developments Limited
    Transaktionen
    • 22. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Dez. 1994
    Geliefert am 16. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a cornbrook, 2 brindley road, old trafford, manchester t/nos: GM355091, GM356520, GM371963, GM356519,GM464482 and GM450626. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 18. Nov. 1994
    Geliefert am 06. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor (as defined) to the chargee under the stock documents as defined in this deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Plcr Any of Themstockholders (As Defined) and the Stockholders Oas Agent and Trustee for Itself and Each of The
    Transaktionen
    • 06. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guaranee and debenture
    Erstellt am 18. Nov. 1994
    Geliefert am 21. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trust deed
    Erstellt am 19. Apr. 1994
    Geliefert am 20. Apr. 1994
    Datum des Sicherungsinstruments 19. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Berechtigte Personen
    • Adt Group PLC and Adt Trustees Limited
    Transaktionen
    • 20. Apr. 1994Registrierung einer Belastung zur Sicherung einer Serie von Schuldverschreibungen (397)
    • 25. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 15. Apr. 1994
    Geliefert am 25. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture registered pursuant to an order of the court dated 29TH september 1992
    Erstellt am 20. Juli 1992
    Geliefert am 10. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See doc M395 ref M371 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • M K D Group Limited
    Transaktionen
    • 10. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 04. Sept. 1991
    Geliefert am 18. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £164,530.83 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All its right title & interest in and to all sums payable under the insurance (for full details see form 395).
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of deposit
    Erstellt am 27. Sept. 1990
    Geliefert am 08. Okt. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a lease dated 25/3/87 and this deed of deposit
    Kurze Angaben
    The sum of £7,500.
    Berechtigte Personen
    • Fiabrook Limited
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    Rent deposit deed.
    Erstellt am 02. Nov. 1989
    Geliefert am 09. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 2.11.89
    Kurze Angaben
    £5,750.00.
    Berechtigte Personen
    • Midland City Properties Limited.
    Transaktionen
    • 09. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 04. Sept. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Juni 1989
    Geliefert am 20. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Orama mill, whitworth rochdale, gr. Manchester together with the goodwill of the business undertaken at the property.
    Berechtigte Personen
    • First National Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    • 25. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Mai 1989
    Geliefert am 02. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    • 05. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MKD HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Apr. 2007Beginn der Verwaltung
    04. Okt. 2008Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles Peter Holder
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Praktiker
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Praktiker
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Praktiker
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0