OCYT 11 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOCYT 11 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02341739
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OCYT 11 LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich OCYT 11 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Victoria Road
    Leeds
    LS11 5UG West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OCYT 11 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HEMAX LIMITED09. Mai 198909. Mai 1989
    SARSET LIMITED31. Jan. 198931. Jan. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OCYT 11 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis26. Sept. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für OCYT 11 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01
    A1UKUJSU

    legacy

    2 Seiten288a
    X1CG0C79

    legacy

    1 Seiten288b
    X1CG1C7A

    legacy

    3 Seiten363a
    XLL6BASM

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Sept. 2008

    1 SeitenAA
    AW39D5WW

    legacy

    3 Seiten363a
    XIKNN20B

    legacy

    1 Seiten353
    XHUXA1WC

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed hemax LIMITED\certificate issued on 23/05/08
    2 SeitenCERTNM
    A7YVLZYS

    legacy

    2 Seiten288a
    AGWCRZK8

    legacy

    3 Seiten288a
    AGWCSZK9

    legacy

    1 Seiten288b
    AGWCTZKA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    1 SeitenAA
    A4FSAYMF

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    1 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    1 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von OCYT 11 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOLDISON, Alison
    28 Preston View
    Swillington
    LS26 8UG Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    28 Preston View
    Swillington
    LS26 8UG Leeds
    West Yorkshire
    British126408080001
    BOLDISON, Alison
    28 Preston View
    Swillington
    LS26 8UG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    28 Preston View
    Swillington
    LS26 8UG Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant126408080001
    LAWS, Richard
    3 Sycamore Walk
    LS28 5BS Farsley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 Sycamore Walk
    LS28 5BS Farsley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant125867660001
    CHAPMAN, Christopher John
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50769680003
    KELLY, Leonard Robert
    62 Leas Road
    CR6 9LL Warlingham
    Surrey
    Sekretär
    62 Leas Road
    CR6 9LL Warlingham
    Surrey
    British13878470001
    LATHAM, Graham Charles Mason
    27 Whitewells Gardens
    Scholes
    HD9 1TZ Holmfirth
    Sekretär
    27 Whitewells Gardens
    Scholes
    HD9 1TZ Holmfirth
    BritishFinancial Director81181550001
    PARSONS, Graham John
    Derwent Ridge
    Bullhurst Lane Weston Underwood
    DE6 4PA Ashbourne
    Derbyshire
    Sekretär
    Derwent Ridge
    Bullhurst Lane Weston Underwood
    DE6 4PA Ashbourne
    Derbyshire
    British33400140001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Sekretär
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    STRATTON, Malcolm
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    Sekretär
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    British30601260002
    BROWNING, Gordon Robert
    Linbeck
    Linton
    BD23 5HQ Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Linbeck
    Linton
    BD23 5HQ Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector142600170001
    DAVIES, Michael Thomas
    11 The Rills
    LE10 1NA Hinckley
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    11 The Rills
    LE10 1NA Hinckley
    Leicestershire
    BritishManager50770000001
    DODWELL, Andrew Joseph
    Springfield Road
    Morley
    LS27 9TA Leeds
    114
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Springfield Road
    Morley
    LS27 9TA Leeds
    114
    West Yorkshire
    BritishAccountant130317690001
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    Geschäftsführer
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant56562210001
    KELLY, Leonard Robert
    62 Leas Road
    CR6 9LL Warlingham
    Surrey
    Geschäftsführer
    62 Leas Road
    CR6 9LL Warlingham
    Surrey
    BritishDirector13878470001
    MAXWELL, Stuart
    11a Melbourne Lane
    DE73 8AT Breedon On The Hill
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    11a Melbourne Lane
    DE73 8AT Breedon On The Hill
    Derbyshire
    EnglandBritishSales Director110823580002
    TWIGG, William Barry
    9 Pine View
    Ashgate
    S40 4DN Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    9 Pine View
    Ashgate
    S40 4DN Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector11026610001
    WOODS, Kathryn Louise
    Royles Head Lane
    Langwood
    HD3 4TU Huddersfield
    Ash Grove 17
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Royles Head Lane
    Langwood
    HD3 4TU Huddersfield
    Ash Grove 17
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director128624780001
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Mariner
    B79 7UL Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Mariner
    B79 7UL Tamworth
    Staffordshire
    57363930001
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    WESTMINSTER SECURITIES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    33480800001
    WILLIAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    6125640001

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0