FLEXTECH B LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFLEXTECH B LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02342064
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FLEXTECH B LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich FLEXTECH B LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FLEXTECH B LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BRAVO TV LIMITED03. Feb. 199703. Feb. 1997
    BRAVO CLASSIC MOVIES LIMITED01. Feb. 198901. Feb. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FLEXTECH B LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FLEXTECH B LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für FLEXTECH B LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 24. Mai 2016

    • Kapital: GBP 0.3345
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium cancelled 26/04/2016
    RES13

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 3.345
    SH01

    legacy

    94 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 01. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 3.345
    SH01

    legacy

    92 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Robert Dominic Dunn als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Gale als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 09. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 3.345
    SH01

    legacy

    97 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Wer sind die Geschäftsführer von FLEXTECH B LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Sekretär
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    154162790002
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritishChief Financial Officer179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritishSolicitor182167230001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Sekretär
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    British37860010002
    TAYLOR, Richard George
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    Sekretär
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    British47989960001
    QUADRANGLE SECRETARIES LIMITED
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    Bevollmächtigter Sekretär
    95 The Promenade
    GL50 1WG Cheltenham
    Gloucestershire
    900002950001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BRETT, Stephen Marc
    2092 Hardscrabble Drive
    Boulder
    Colorado
    880303
    Usa
    Geschäftsführer
    2092 Hardscrabble Drive
    Boulder
    Colorado
    880303
    Usa
    AmericanAttorney21673650001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Geschäftsführer
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-AmericanManaging Director52311710004
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Geschäftsführer
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    BritishSolicitor73000530008
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant96956740001
    HARMAN, Phillip Brent
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    Geschäftsführer
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    New ZealanderCompany Manager51102310001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    BritishAccountant28242190001
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Geschäftsführer
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    BritishAccountant37860010002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritishSolicitor47785600002
    OPIE, Lisa Moreen
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishTelevision Executive88563310001
    OSBORNE, Timothy William
    Pucks Hill
    Cranham
    GL4 8HP Gloucester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Pucks Hill
    Cranham
    GL4 8HP Gloucester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishSolicitor112086830002
    SINGER, Adam Nicholas
    8 Oxhey Road
    Oxhey
    WD1 4QE Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Oxhey Road
    Oxhey
    WD1 4QE Watford
    Hertfordshire
    BritishCompany Director35783020005
    SINGER, Adam Nicholas
    10747 East Crestline Circle
    Englewood Arapahoe Colorado 80111
    Usa
    Geschäftsführer
    10747 East Crestline Circle
    Englewood Arapahoe Colorado 80111
    Usa
    BritishProgramme Executive35783020003
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    BritishFinance Director79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Geschäftsführer
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    BritishDirector8281170001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritishSolicitor164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritishSolicitor164134250001
    WALL, Malcolm Robert
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    Geschäftsführer
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    EnglandBritishDirector178772080002
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritishSolicitor140137570002
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    Hat FLEXTECH B LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 10. Mai 2005
    Geliefert am 18. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the chargors to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 18. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 28. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of the company in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 28. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 22. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of tcn in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 22. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture made between (1) telewest communications networks limited, (2) the original charging subsidiaries, (3) the original charging partnerships and (4) telewest finance corporation (the "us "borrower") 5). cibc world markets PLC in its capacity as security trustee issued by the company.
    Erstellt am 16. März 2001
    Geliefert am 23. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A).all amounts payable to cibc world markets PLC as security trustee to the extent only of the amount payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed and all amounts payable to any other person who may be appointed as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed to the extent only of the amounts payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed; (b) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to all or any of the finance parties under the senior documents; (c) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to the hedge counterparties under the hedging arrangements; (d) all indebtedness of the lessees to the lessors (or any of them) under the lease documents; and (e) all financial obligations due to crosby under the crosby documents
    Kurze Angaben
    I). all the company's present and future rights, title, benefit and interest in and under the loan stock (as defined) from time to time ii).all rights title benefit and interest in and to amounts payable to the company arising under the bbc jv management services agreement, and the UK gold jv management services agreement iii). All rights title benefit and interest in and to amounts payable to the company under the bbc jv agreement,the UK gold jv agreement and any other subscription and shareholder agreement entered into in relation to a joint venture,including (but not limited to) all amounts payable under clauses 19 and 20 of the bbc jv agreement and clauses 19 and 20 of the UK gold jv agreement and iv). All the company's present and future rights title benefit and interest in and under the intercompany loan agreement together with first floating charge all the company's undertaking property and assets not charged by way of fixed charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC (In Its Capacity as Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 02. März 2000
    Geliefert am 16. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (in this capacity the "security trustee") under or pursuant to the transaction documents (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All stocks shares and securities of any kind whatsoever whether marketable or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transaktionen
    • 16. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 27. Aug. 1997
    Geliefert am 12. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the transaction documents (as defined in the debenture)
    Kurze Angaben
    All the undertaking goodwill property assets and rights of such chargor as specified in the debenture (the "charged assets"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank(In It's Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0