TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02345011 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 Dorset Rise EC4Y 8EN London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ASHURST PARK INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED | 23. Jan. 1991 | 23. Jan. 1991 |
SCATSOUTH A51 LIMITED | 08. Feb. 1989 | 08. Feb. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Gordon als Geschäftsführer am 02. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Spire Healthcare Limited als Direktor am 02. Nov. 2015 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Roger als Geschäftsführer am 02. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Gordon am 01. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Roger am 01. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Roger am 01. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Gordon am 01. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom zum 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 120 Holborn London EC1N 2TD* am 12. Dez. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Daniel Francis Toner am 23. Aug. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jean De Gorter als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONER, Daniel Francis | Sekretär | Dorset Rise EC4Y 8EN London 3 | British | 100270040001 | ||||||||||
TONER, Daniel Francis | Geschäftsführer | Dorset Rise EC4Y 8EN London 3 | United Kingdom | British | Solicitor | 100270040002 | ||||||||
SPIRE HEALTHCARE LIMITED | Geschäftsführer | Dorset Rise EC4Y 8EN London 3 United Kingdom |
| 202359590001 | ||||||||||
MORRIS, David Richard | Sekretär | 22 Lee Lane East Horsforth LS18 5RE Leeds West Yorkshire | British | Company Secretary | 64514410001 | |||||||||
PRESTON, David James | Sekretär | 4 Victoria Mansions Navigation Way Ashton On Ribble PR2 2YX Preston Lancashire | British | Chartered Accountant | 46551430003 | |||||||||
PRESTON, David James | Sekretär | 5 Cock Robin Cottages Croston PR5 7HH Preston | British | 46551430001 | ||||||||||
WALFORD, Arthur David | Sekretär | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | British | 6658190001 | ||||||||||
BUPA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bupa House 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London | 107319700001 | |||||||||||
BARKER, Hilary Jane | Geschäftsführer | Flat B22 Herbal Hill Gardens 9 Herbal Hill EC1R 5EJ London | British | Finance Director | 62838010001 | |||||||||
BEAZLEY, Nicholas Tetley | Geschäftsführer | The Dower House Westmill SG9 9LY Buntingford Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 105797560001 | ||||||||
BURNS, Robert Ian | Geschäftsführer | 6 Netherfield Road AL5 2AG Harpenden Hertfordshire | England | British | Director-Bupa Hospitals | 36584260002 | ||||||||
CHADWICK, Bernard Keith | Geschäftsführer | Willow Glen Dowbridge Kirkham PR4 2YL Preston Lancashire | England | British | Director | 3632310001 | ||||||||
DAVIES, Julian Peter | Geschäftsführer | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Director | 29367700001 | ||||||||
DE GORTER, Jean Jacques, Dr | Geschäftsführer | Holborn EC1N 2TD London 120 | United Kingdom | French | Director | 128865640001 | ||||||||
DUGDALE, Michael Ian | Geschäftsführer | 29 Magnolia Dene HP15 7QE Hazlemere Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 79570840001 | |||||||||
ELLERBY, Mark | Geschäftsführer | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | Group Financial Controller | 40582650004 | ||||||||
FOZARD, Ian | Geschäftsführer | The Old Brewhouse 8a Waterside HG5 9AZ Knaresborough North Yorkshire | England | British | Managing Director | 21934910001 | ||||||||
GORDON, Simon | Geschäftsführer | Dorset Rise EC4Y 8EN London 3 | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 162037020001 | ||||||||
GRAY, Duncan Archibald | Geschäftsführer | 51 Exchange Building 132 Commercial Street E1 6NG London | England | British | Finance And Commerical Directo | 68845270002 | ||||||||
GREGORY, Fraser David | Geschäftsführer | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | Director | 107664270001 | ||||||||
HEMMING, Eric Rodney | Geschäftsführer | The Elms 4 Clifton Drive FY8 5PP Lytham St. Annes Lancashire | British | Director | 84030950001 | |||||||||
HOLDEN, Dean Allan | Geschäftsführer | Spring House Spring Hill Fordcombe TN3 0SE Tunbridge Wells Kent | British | Group Financial Controller | 32671980002 | |||||||||
HOLLINGSWORTH, Clare Margaret | Geschäftsführer | House Farm Crowhurst Lane Crowhurst RH7 6LR Lingfield Mansion Surrey | United Kingdom | British | Managing Director-Hospitals | 62952630002 | ||||||||
JONES, Richard James Edward | Geschäftsführer | Holborn EC1N 2TD London 120 | England | British | Director | 133019680001 | ||||||||
KEE, Fergus Alexander | Geschäftsführer | The Old Cottage Howe Green SG13 8LH Hertford | United Kingdom | Irish | Uk Finance Director | 26911740008 | ||||||||
KENT, Benjamin David Jemphrey | Geschäftsführer | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 93897360003 | ||||||||
KING, Raymond | Geschäftsführer | Westlands House Cowfold Road West Grinstead RH13 8LZ Horsham West Sussex | British | Chartered Accountant | 56146040001 | |||||||||
LEA, Edward William | Geschäftsführer | 81 Castle Road AL1 5DQ St. Albans Hertfordshire | British | Group Finance Director | 28018450003 | |||||||||
PRESTON, David James | Geschäftsführer | 4 Victoria Mansions Navigation Way Ashton On Ribble PR2 2YX Preston Lancashire | British | Chartered Accountant | 46551430003 | |||||||||
ROGER, Robert | Geschäftsführer | Dorset Rise EC4Y 8EN London 3 | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 151959030001 | ||||||||
SARSFIELD, Vincent Gerard | Geschäftsführer | Little Lowes Fold Heath Lane Lowton WA3 2SJ Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 5491860001 | ||||||||
SMITH, Graham | Geschäftsführer | Moor Lane LS297AF Burley In Wharfedale Briarfield West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 142125320001 | ||||||||
SMITH, Graham | Geschäftsführer | Moor Lane LS297AF Burley In Wharfedale Briarfield West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Executive | 142125320001 | ||||||||
STEVENS, Geoffrey Robert | Geschäftsführer | Beech House 3 Millhouses Court S11 9HZ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 57380020001 | ||||||||
WALFORD, Arthur David | Geschäftsführer | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Solicitor | 6658190001 |
Hat TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Security accession deed | Erstellt am 22. Okt. 2008 Geliefert am 29. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Juli 2002 Geliefert am 31. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 16. Juli 1996 Geliefert am 20. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Tunbridge wells independent hospital ashurst park fordcombe tunbridge wells t/no K709645 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. März 1992 Geliefert am 25. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 23. Dez. 1991 Geliefert am 08. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof, fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts andthe benefits of any licences l/h property comprised in title no k 709645 being a lease of ashurst park independent hospital fordcombe road tunbridge wells kent from ibh limited (1) to ashurst park independent hospital limited (2) dated 21/8/91. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 21. Aug. 1991 Geliefert am 10. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage l/h property, tunbridge wells independent hospital tunbridge wells kent. Including all fixtures fittings other than trade fixtures and fittings plant and machinery. (See form 395 and continuation sheet for full details document M114). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Juli 1991 Geliefert am 09. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee on any account | |
Kurze Angaben (See for 395 document M13C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Jan. 1991 Geliefert am 24. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 500000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of charge. | |
Kurze Angaben Land at ashurst park fordcombe county of kent being part of land comprised in t/no. K535622. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Okt. 1990 Geliefert am 31. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land at ashurst park near fordcombe road, fordcombe in the company of kent title no K535622. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0