IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameIWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02350078
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Bdo Llp
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    IWP (U.K.) HOLDINGS PLC27. Juli 199227. Juli 1992
    IWP INTERNATIONAL LIMITED21. Aug. 198921. Aug. 1989
    IWP UK HOLDINGS LIMITED10. März 198910. März 1989
    SAVECARE LIMITED20. Feb. 198920. Feb. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    16 SeitenLIQ13
    Y9FI7VZU

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2019

    16 SeitenLIQ03
    A8WXER5V

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2018

    15 SeitenLIQ03
    A7YSF56H

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD zum C/O Bdo Llp Two Snowhill Birmingham B4 6GA am 28. Feb. 2018

    2 SeitenAD01
    A707CZ75

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2017

    16 SeitenLIQ03
    A6ZZPAYG

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl
    4 SeitenLIQ MISC
    A6I84Y0W

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600
    A6ESS528

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    19 SeitenLIQ10
    Q6DHWTAY

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2016

    13 Seiten4.68
    A5YTPMOZ

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC
    A5KP7FJC

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:Sec. Of State Cert of Release of Liquidator
    1 SeitenLIQ MISC
    A5J4V0R4

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600
    A5FMIS6Q

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40
    A5FMIS6Y

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq
    13 SeitenLIQ MISC OC
    Q5CQ5SW2

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600
    A5CPAK17

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40
    A5CPAK1F

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2015

    12 Seiten4.68
    A510NVRC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2014

    10 Seiten4.68
    A3Z38VZN

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2013

    10 Seiten4.68
    A301T0Y8

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2012

    9 Seiten4.68
    A22M94QI

    Beendigung der Bestellung von Leo Ring als Sekretär

    2 SeitenTM02
    A15DNGCO

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Set-off agreement.amt auth share cap revoked 12/12/2011
    RES13
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 12. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 39,743,464.228955
    4 SeitenSH01
    A10AGK22

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 22 Grimrod Place Skelmersdale Lancs WN8 9UU* am 11. Jan. 2012

    2 SeitenAD01
    A0OSPZSJ

    Wer sind die Geschäftsführer von IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OTLEY, Richard Reverdy
    4 Osborne Way
    HP23 6EN Wiggington
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    4 Osborne Way
    HP23 6EN Wiggington
    Hertfordshire
    United KingdomBritishInvestment Analyst127085630001
    BAILIWICK, Muriel Ann
    28 Loudwater Close
    TW16 6DE Sunbury On Thames
    Middlesex
    Sekretär
    28 Loudwater Close
    TW16 6DE Sunbury On Thames
    Middlesex
    British8073510001
    PRICE, Andrew
    Min Y Mynydd
    CH8 8JG Rhes Y Cae
    Flintshire
    Sekretär
    Min Y Mynydd
    CH8 8JG Rhes Y Cae
    Flintshire
    BritishCompany Director23752090002
    RING, Leo Joseph
    3 Fairways
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    Sekretär
    3 Fairways
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    IrishCompany Secretary97021090001
    BYRNE, Bernard Michael
    31 Lavarna Road
    Terenure
    IRISH Dublin 6w
    Ireland
    Geschäftsführer
    31 Lavarna Road
    Terenure
    IRISH Dublin 6w
    Ireland
    IrishFinance Director60629740001
    FARRELL, Peter
    26 Ashletem Lawn
    IRISH Malamide
    Co Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    26 Ashletem Lawn
    IRISH Malamide
    Co Dublin
    Ireland
    IrishChartered Accountant26144590001
    FAWCETT, Douglas Kendall
    35 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    35 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    BritishCo Director6201580001
    HICKIE, Gerard
    Higher House Farm
    Castle Mill Lane
    WA15 0RA Ashley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Higher House Farm
    Castle Mill Lane
    WA15 0RA Ashley
    Cheshire
    IrishManaging Director85735370004
    HUGHES, Loraine
    Walsham Gardens
    WA9 5UT St. Helens
    38
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Walsham Gardens
    WA9 5UT St. Helens
    38
    Merseyside
    EnglandBritishFinance Director138239430001
    LANCASHIRE, Frank, Doctor
    9 Greenfield Lane
    CH2 2PA Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    9 Greenfield Lane
    CH2 2PA Chester
    Cheshire
    BritishCompany Director2893710001
    LYNCH STAUNTON, Graham Murray
    22 Grimrod Place
    WN8 9UU Skelmersdale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    22 Grimrod Place
    WN8 9UU Skelmersdale
    Lancashire
    United KingdomBritishCo Director77490420005
    MORAN, Patrick Joseph
    19 Fitzwilliam Square
    IRISH Dublin 2
    Ireland
    Geschäftsführer
    19 Fitzwilliam Square
    IRISH Dublin 2
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director59274790001
    MURPHY, Jim Michael
    36 Ulverton Road
    Dalkey
    IRISH Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    36 Ulverton Road
    Dalkey
    IRISH Dublin
    Ireland
    IrishCo Director96999840001
    O'BRIEN, Paul
    3 Fox Lodge Road
    Fox Lodge Woods
    IRISH Ratoath
    Ireland
    Geschäftsführer
    3 Fox Lodge Road
    Fox Lodge Woods
    IRISH Ratoath
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director96999430001
    POPHAM, Neil Rowland
    Whitehouse Farm
    Berden
    CM23 1AE Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Whitehouse Farm
    Berden
    CM23 1AE Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChief Executive48644450001
    PRICE, Andrew
    Min Y Mynydd
    CH8 8JG Rhes Y Cae
    Flintshire
    Geschäftsführer
    Min Y Mynydd
    CH8 8JG Rhes Y Cae
    Flintshire
    United KingdomBritishCompany Director23752090002
    SOROKIN, Alexander
    10 Sterling Street
    SW7 1HN London
    Geschäftsführer
    10 Sterling Street
    SW7 1HN London
    AmericanCorporate Financier111747170001
    SOUTHALL, John Leslie
    3 The Mill Pool
    Oakdrive Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    3 The Mill Pool
    Oakdrive Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector4847600001
    STEWART, James Alexander
    41 Lurgaw Road
    Portadown
    Armagh
    Geschäftsführer
    41 Lurgaw Road
    Portadown
    Armagh
    BritishManaging Director27721430001

    Hat IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 28. März 2006
    Geliefert am 11. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over property and assets including goodwill bookdebts uncalled plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent and Trustee for the Secured Parties (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of hypothec and issue of bonds
    Erstellt am 28. März 2006
    Geliefert am 10. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the bondholders or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All present and future shares in the capital stock of the pledged company, including the 100 a class shares (comprising 100% of the a class shares in the company). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Pledge agreement
    Erstellt am 28. März 2006
    Geliefert am 07. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the working capital lenders and/or the working capital security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The bond, all rights and revenues and the certificate or certificates that represent or may represent the bond. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent) in Its Capacity as Working Capital Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of hypothec
    Erstellt am 14. Okt. 2004
    Geliefert am 30. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and the payment of $500,000.00 canadian dollars and all other sums due or to become due from the company to the bondholders or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    To secure the payment and performance of the secured obligations the company has granted to the collateral agent for its own benefit and for the benefit of the bondholders a hypothec over the charged property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 30. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 22. Juni 2004
    Geliefert am 05. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all sums of money known as deposits together with all interest from time to time accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 09. Juni 2004
    Geliefert am 28. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 28. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 09. Juni 2004
    Geliefert am 25. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All sums of money k/a deposits, together with all interest from time to time accruing thereon.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juli 1989
    Geliefert am 28. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 29. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Jan. 2021Aufgelöst am
    21. Dez. 2011Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Dermot Justin Power
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praktiker
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Ian James Gould
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praktiker
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0