IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02350078 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Bdo Llp Two Snowhill B4 6GA Birmingham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
IWP (U.K.) HOLDINGS PLC | 27. Juli 1992 | 27. Juli 1992 |
IWP INTERNATIONAL LIMITED | 21. Aug. 1989 | 21. Aug. 1989 |
IWP UK HOLDINGS LIMITED | 10. März 1989 | 10. März 1989 |
SAVECARE LIMITED | 20. Feb. 1989 | 20. Feb. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 16 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2019 | 16 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2018 | 15 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD zum C/O Bdo Llp Two Snowhill Birmingham B4 6GA am 28. Feb. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2017 | 16 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl | 4 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 19 Seiten | LIQ10 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2016 | 13 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:s/s cert. Release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||||||||||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:Sec. Of State Cert of Release of Liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq | 13 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2015 | 12 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2014 | 10 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2013 | 10 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Dez. 2012 | 9 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Leo Ring als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 12. Dez. 2011
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 22 Grimrod Place Skelmersdale Lancs WN8 9UU* am 11. Jan. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTLEY, Richard Reverdy | Geschäftsführer | 4 Osborne Way HP23 6EN Wiggington Hertfordshire | United Kingdom | British | Investment Analyst | 127085630001 | ||||
BAILIWICK, Muriel Ann | Sekretär | 28 Loudwater Close TW16 6DE Sunbury On Thames Middlesex | British | 8073510001 | ||||||
PRICE, Andrew | Sekretär | Min Y Mynydd CH8 8JG Rhes Y Cae Flintshire | British | Company Director | 23752090002 | |||||
RING, Leo Joseph | Sekretär | 3 Fairways IRISH Rathfarnham Dublin 14 Ireland | Irish | Company Secretary | 97021090001 | |||||
BYRNE, Bernard Michael | Geschäftsführer | 31 Lavarna Road Terenure IRISH Dublin 6w Ireland | Irish | Finance Director | 60629740001 | |||||
FARRELL, Peter | Geschäftsführer | 26 Ashletem Lawn IRISH Malamide Co Dublin Ireland | Irish | Chartered Accountant | 26144590001 | |||||
FAWCETT, Douglas Kendall | Geschäftsführer | 35 Ashley Road KT12 1HG Walton On Thames Surrey | British | Co Director | 6201580001 | |||||
HICKIE, Gerard | Geschäftsführer | Higher House Farm Castle Mill Lane WA15 0RA Ashley Cheshire | Irish | Managing Director | 85735370004 | |||||
HUGHES, Loraine | Geschäftsführer | Walsham Gardens WA9 5UT St. Helens 38 Merseyside | England | British | Finance Director | 138239430001 | ||||
LANCASHIRE, Frank, Doctor | Geschäftsführer | 9 Greenfield Lane CH2 2PA Chester Cheshire | British | Company Director | 2893710001 | |||||
LYNCH STAUNTON, Graham Murray | Geschäftsführer | 22 Grimrod Place WN8 9UU Skelmersdale Lancashire | United Kingdom | British | Co Director | 77490420005 | ||||
MORAN, Patrick Joseph | Geschäftsführer | 19 Fitzwilliam Square IRISH Dublin 2 Ireland | Ireland | Irish | Company Director | 59274790001 | ||||
MURPHY, Jim Michael | Geschäftsführer | 36 Ulverton Road Dalkey IRISH Dublin Ireland | Irish | Co Director | 96999840001 | |||||
O'BRIEN, Paul | Geschäftsführer | 3 Fox Lodge Road Fox Lodge Woods IRISH Ratoath Ireland | Ireland | Irish | Company Director | 96999430001 | ||||
POPHAM, Neil Rowland | Geschäftsführer | Whitehouse Farm Berden CM23 1AE Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 48644450001 | ||||
PRICE, Andrew | Geschäftsführer | Min Y Mynydd CH8 8JG Rhes Y Cae Flintshire | United Kingdom | British | Company Director | 23752090002 | ||||
SOROKIN, Alexander | Geschäftsführer | 10 Sterling Street SW7 1HN London | American | Corporate Financier | 111747170001 | |||||
SOUTHALL, John Leslie | Geschäftsführer | 3 The Mill Pool Oakdrive Seisdon WV5 7ET Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | Director | 4847600001 | ||||
STEWART, James Alexander | Geschäftsführer | 41 Lurgaw Road Portadown Armagh | British | Managing Director | 27721430001 |
Hat IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Erstellt am 28. März 2006 Geliefert am 11. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over property and assets including goodwill bookdebts uncalled plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of hypothec and issue of bonds | Erstellt am 28. März 2006 Geliefert am 10. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the bondholders or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All present and future shares in the capital stock of the pledged company, including the 100 a class shares (comprising 100% of the a class shares in the company). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Pledge agreement | Erstellt am 28. März 2006 Geliefert am 07. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to the working capital lenders and/or the working capital security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The bond, all rights and revenues and the certificate or certificates that represent or may represent the bond. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of hypothec | Erstellt am 14. Okt. 2004 Geliefert am 30. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and the payment of $500,000.00 canadian dollars and all other sums due or to become due from the company to the bondholders or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben To secure the payment and performance of the secured obligations the company has granted to the collateral agent for its own benefit and for the benefit of the bondholders a hypothec over the charged property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 22. Juni 2004 Geliefert am 05. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all sums of money known as deposits together with all interest from time to time accruing thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 09. Juni 2004 Geliefert am 28. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 09. Juni 2004 Geliefert am 25. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All sums of money k/a deposits, together with all interest from time to time accruing thereon.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Juli 1989 Geliefert am 28. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat IWP (U.K.) HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0