NORCOR HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNORCOR HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02352247
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NORCOR HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /
    • (7499) /

    Wo befindet sich NORCOR HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Darlington Road
    West Auckland
    DL14 9PE County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NORCOR HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NORCOR HOLDINGS PLC27. Juni 198927. Juni 1989
    LEGIBUS 1361 LIMITED24. Feb. 198924. Feb. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORCOR HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für NORCOR HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 26. Okt. 2011

    • Kapital: GBP 0.25
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    5 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium cancelled 24/10/2011
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    10 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    9 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363a

    legacy

    8 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    9 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    9 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(287)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    9 SeitenAA

    legacy

    13 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von NORCOR HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CLISH, Keith
    8 Birkdale Gardens
    DH1 2UJ Durham City
    County Durham
    Sekretär
    8 Birkdale Gardens
    DH1 2UJ Durham City
    County Durham
    British111750070001
    CLISH, Keith
    8 Birkdale Gardens
    DH1 2UJ Durham City
    County Durham
    Geschäftsführer
    8 Birkdale Gardens
    DH1 2UJ Durham City
    County Durham
    United KingdomBritish111750070001
    MCNEILL, Patrick
    15 Saxon Close
    Appleton
    WA4 5SD Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    15 Saxon Close
    Appleton
    WA4 5SD Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish111170280001
    CLARK, Jeremy Francis
    13 Potters Crescent
    Great Moulton
    NR15 2HL Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    13 Potters Crescent
    Great Moulton
    NR15 2HL Norwich
    Norfolk
    British85512300001
    MIDDLETON, David George
    Malvern 13 Valley Side Road
    NR1 4LD Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    Malvern 13 Valley Side Road
    NR1 4LD Norwich
    Norfolk
    British9558290001
    WASDEN, Mark
    77a South Hill Road
    Thorpe St Andrew
    NR7 0LR Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    77a South Hill Road
    Thorpe St Andrew
    NR7 0LR Norwich
    Norfolk
    British1308800002
    BARRETT, Patrick Augustine
    26 Crossland House
    Holloway Drive
    GU25 4SY Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    26 Crossland House
    Holloway Drive
    GU25 4SY Virginia Water
    Surrey
    British941830005
    BRADLEY, David
    Hambleton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3RX Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Hambleton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3RX Harrogate
    North Yorkshire
    British65302630001
    CLARK, Jeremy Francis
    13 Potters Crescent
    Great Moulton
    NR15 2HL Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    13 Potters Crescent
    Great Moulton
    NR15 2HL Norwich
    Norfolk
    British85512300001
    CLAYTON, Michael James
    The Old Mill
    Ireby
    CA7 1DS Wigton
    Cumbria
    Geschäftsführer
    The Old Mill
    Ireby
    CA7 1DS Wigton
    Cumbria
    British4036940005
    COGHLAN, John Patrick
    6 Scholars Mews
    AL8 7JQ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 Scholars Mews
    AL8 7JQ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Irish68846400002
    FOSTER, Philip
    172 Newmarket Road
    NR4 6AR Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    172 Newmarket Road
    NR4 6AR Norwich
    Norfolk
    British9558300001
    HART, Timothy Guy Collins
    Kingswood House
    The Lee
    HP16 9NU Great Missenden
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Kingswood House
    The Lee
    HP16 9NU Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish36699430002
    HOBBS, Ronald Robert Collins
    Blue Hills
    Yalding Hill
    ME18 6AN Yalding
    Kent
    Geschäftsführer
    Blue Hills
    Yalding Hill
    ME18 6AN Yalding
    Kent
    British9643470002
    HOLLIDAY, Michael Francis
    Beech House
    7 Church Road Blofield
    NR13 4NA Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Beech House
    7 Church Road Blofield
    NR13 4NA Norwich
    Norfolk
    British24337350001
    MIDDLETON, David George
    2a Bernard Close
    New Rackheath
    NR13 6QS Norwich
    Geschäftsführer
    2a Bernard Close
    New Rackheath
    NR13 6QS Norwich
    British9558290002
    NEWTON, David Alexander
    Falcon House
    Mellis
    IP23 8DQ Eye
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Falcon House
    Mellis
    IP23 8DQ Eye
    Suffolk
    British108260001
    RIDLEY THOMAS, Roger
    Booton Manor
    Booton
    NR10 4NZ Reepham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Booton Manor
    Booton
    NR10 4NZ Reepham
    Norfolk
    British34045870002
    SNEDDEN, David King
    Flat 29 Ravelston Heights
    EH4 3LX Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Flat 29 Ravelston Heights
    EH4 3LX Edinburgh
    Midlothian
    British2699560004
    WASDEN, Mark
    77a South Hill Road
    Thorpe St Andrew
    NR7 0LR Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    77a South Hill Road
    Thorpe St Andrew
    NR7 0LR Norwich
    Norfolk
    British1308800002

    Hat NORCOR HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2002
    Geliefert am 09. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the company and each other chargor to the secured creditors to the spanish bond creditors (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London as Security Agent as Agent and Trustee for the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2002
    Geliefert am 09. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the secured creditors (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2002
    Geliefert am 09. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the secured creditors (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Sept. 2002
    Geliefert am 04. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Aug. 1999
    Geliefert am 13. Sept. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H jupiter road norwich t/n-NK215001.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Global supplemental debenture
    Erstellt am 06. Aug. 1992
    Geliefert am 26. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the lenders (as defined) under the finance documents (as defined) to which the company is a party, which include the foreign exchange facility agreement, the interest hedging agreement and the original debenture (all as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery see form 395 ref M543C.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for Itselfthe Arranger and the Lenders
    Transaktionen
    • 26. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Apr. 1989
    Geliefert am 12. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee as agent and trustee for itself the arranger and the lenders under the terms of the finance document.s
    Kurze Angaben
    9IXED and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 11. Jan. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0