EAST COAST CABLE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEAST COAST CABLE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02352468
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EAST COAST CABLE LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich EAST COAST CABLE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EAST COAST CABLE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LEGIBUS 1351 LIMITED24. Feb. 198924. Feb. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EAST COAST CABLE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für EAST COAST CABLE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 18. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 10,100
    SH01

    legacy

    92 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Gale als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Robert Dominic Dunn als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    97 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 25. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 10,100
    SH01

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Joanne Tillbrook als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Caroline Bernadette Elizabeth Withers als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von EAST COAST CABLE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151021000001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish182167230001
    ASHBURNER, Ronald Leslie George
    5 The Avenue
    UB10 8NR Uxbridge
    Middlesex
    Sekretär
    5 The Avenue
    UB10 8NR Uxbridge
    Middlesex
    British102503610001
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Sekretär
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Sekretär
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Sekretär
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    MARSHALL, Brian
    112 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    Sekretär
    112 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    British76205930002
    MELIA, Gerard Thomas
    83 Wellington Road
    Turton
    BL7 0EF Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    83 Wellington Road
    Turton
    BL7 0EF Bolton
    Lancashire
    British1512020001
    PROCTOR, Martina
    37a
    Madingley Road
    CB3 0EL Cambridge
    Sekretär
    37a
    Madingley Road
    CB3 0EL Cambridge
    British43777590001
    WANG, Stanley Leon
    584 Sentinel Road
    Morristown
    New Jersey
    08057
    Usa
    Sekretär
    584 Sentinel Road
    Morristown
    New Jersey
    08057
    Usa
    Us8903520001
    WRIGHT, Douglas Barclay
    Lodge Drive
    Loudwater
    WD3 4PT Rickmansworth
    Clarinsh
    Hertfordshire
    Sekretär
    Lodge Drive
    Loudwater
    WD3 4PT Rickmansworth
    Clarinsh
    Hertfordshire
    British134618260001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    ALDEN, Peter James
    32 Brookside
    CB2 1JQ Cambridge
    Geschäftsführer
    32 Brookside
    CB2 1JQ Cambridge
    British40967330002
    BLAKER, Peter Allan Renshaw, Lord
    Woodsland Farm Keysford Lane
    RH16 2QT Lindfield
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Woodsland Farm Keysford Lane
    RH16 2QT Lindfield
    West Sussex
    British56032390001
    BRODSKY, Julian Alvin
    1004 Swallow Drive
    Cherryhill
    New Jersey
    08003
    Usa
    Geschäftsführer
    1004 Swallow Drive
    Cherryhill
    New Jersey
    08003
    Usa
    American11120770001
    CAMPBELL, Gerald Daniel
    18 Ringwood Avenue
    N2 9NS London
    Geschäftsführer
    18 Ringwood Avenue
    N2 9NS London
    American48066760001
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Geschäftsführer
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    CHEW, Mun Chun
    15 Rectory Farm Road
    Little Wilbraham
    CB1 5LB Cambridge
    Geschäftsführer
    15 Rectory Farm Road
    Little Wilbraham
    CB1 5LB Cambridge
    Singaporean36124880001
    CHIA, Choon Wei, Doctor
    32 Adis Road
    01-41 Sophia Court
    Singapore 0922
    Geschäftsführer
    32 Adis Road
    01-41 Sophia Court
    Singapore 0922
    Singaporean35806810001
    COLBRAN, Robert Scott
    Pinecreek Farm
    Rr 4
    FOREIGN Acton
    Ontario Ltj 2mi
    Canada
    Geschäftsführer
    Pinecreek Farm
    Rr 4
    FOREIGN Acton
    Ontario Ltj 2mi
    Canada
    Canadian15486600001
    COSGROVE, Charles Henry
    52 Oxley Road
    Valley Mansion
    0923 Singapore
    Geschäftsführer
    52 Oxley Road
    Valley Mansion
    0923 Singapore
    American36156420001
    DAVENPORT, Hugo Riddell Agard Bramhall
    19 Wingate Way
    CB2 2HD Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    19 Wingate Way
    CB2 2HD Cambridge
    Cambridgeshire
    British6298250001
    DAVIES, Richard James
    The Library Suite The Mansion
    KT16 0QB Ottershaw Park
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Library Suite The Mansion
    KT16 0QB Ottershaw Park
    Surrey
    American45182540001
    DIXON SMITH, Robert William
    Houchins Farm
    Cootgeshall
    CO6 1RT Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Houchins Farm
    Cootgeshall
    CO6 1RT Colchester
    Essex
    British14413150001
    GAGE, John Barry
    202 Lord Seaton Road
    North York
    M2P 1K9 Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    202 Lord Seaton Road
    North York
    M2P 1K9 Ontario
    Canada
    Canadian15486590002
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GOWEN, Wayne Lyle
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    British39694410001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Geschäftsführer
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    HO, Lam Phoh
    129 Tanah Kerah Kechill Road
    1646 Singapore
    Geschäftsführer
    129 Tanah Kerah Kechill Road
    1646 Singapore
    Singaporean36156430001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    KNAPP, James Barclay
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Geschäftsführer
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Us Citizen79688880001
    LAWLEY, Ronald Edward
    28 Hurst Park
    GU29 0BP Midhurst
    West Sussex
    Geschäftsführer
    28 Hurst Park
    GU29 0BP Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish121475980001
    LEW, Allen Yoong Keong
    52 Nallur Road
    Singapore
    1545
    Geschäftsführer
    52 Nallur Road
    Singapore
    1545
    Singaporean44257660001

    Hat EAST COAST CABLE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 04. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 04. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 29. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 29. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 2004
    Geliefert am 30. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 30. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 06. Jan. 1998
    Geliefert am 23. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities whether actual or contingent now or hereafter due, owing or incurred to the chargee in its capacity as security trustee by the company and/or all or any of the other companies named therein under or pursuant to the agreement and/or the composite guarantee and debenture and/or the security trust deed and/or any of the other security documents, all obligations and liabilities due owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein to the interest rate beneficiaries (or any of them) in respect of the interest rate protection arrangements, and to the bond providers, if any (or any of them) in respect of any indemnity from the company and/or all or any of the other companies named therein issued in connection with the bond provision arrangements
    Kurze Angaben
    Century house south riverside office centre north station road colchester CO4 4TG; f/h on the north side of newcomem way colchester t/n EX529079. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. März 1995
    Geliefert am 07. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5.46 acres of land at newcomen way,colchester,essex.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0