PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED

PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePROVIDENT ENTERPRISES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02355554
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 27. Nov. 2012

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2012

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2011

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Muir als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Richard Stephen Laker als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2010

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Henderson am 30. Apr. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr David Henderson am 30. Apr. 2010

    1 SeitenCH03

    Ernennung von Mr Christopher Muir als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Philip Moorhouse als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HENDERSON, David
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    Sekretär
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    British2240270003
    HENDERSON, David
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    Geschäftsführer
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    EnglandBritish2240270003
    LAKER, Richard Stephen
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    Geschäftsführer
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    United KingdomBritish160256950001
    IRETON, Anthony Philip
    4 Chequers Close
    MK43 0RF Lower Shelton
    Bedfordshire
    Sekretär
    4 Chequers Close
    MK43 0RF Lower Shelton
    Bedfordshire
    British26235630002
    THORPE, Elizabeth Anne
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    Sekretär
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    British102907000001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    APPLEGARTH, David Christopher John
    31 Topcliff
    St Peters Riverside
    SR6 0QD Sunderland
    Geschäftsführer
    31 Topcliff
    St Peters Riverside
    SR6 0QD Sunderland
    ScotlandBritish81952520001
    IRETON, Anthony Philip
    4 Chequers Close
    MK43 0RF Lower Shelton
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    4 Chequers Close
    MK43 0RF Lower Shelton
    Bedfordshire
    British26235630002
    IRETON, Carol Ann
    Leasefield
    Halwill Junction
    EX21 5XU Beaworthy
    Devon
    Geschäftsführer
    Leasefield
    Halwill Junction
    EX21 5XU Beaworthy
    Devon
    British90225810001
    IRETON, Diane Jane
    31 Milverton Green
    LU3 3XP Luton
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    31 Milverton Green
    LU3 3XP Luton
    Bedfordshire
    British20384380001
    IRETON, Peter Sydney
    Leasefield
    Halwill Junction
    EX21 5XU Beaworthy
    Devon
    Geschäftsführer
    Leasefield
    Halwill Junction
    EX21 5XU Beaworthy
    Devon
    British90226380001
    IRETON, Robert Peter
    153 The Causeway
    Bassingbourn Cum Kneesworth
    SG8 5JD Royston
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    153 The Causeway
    Bassingbourn Cum Kneesworth
    SG8 5JD Royston
    Hertfordshire
    British93133760001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Geschäftsführer
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    METCALFE, Richard
    6 Dawber Delph
    Appley Bridge
    WN6 9LN Wigan
    Geschäftsführer
    6 Dawber Delph
    Appley Bridge
    WN6 9LN Wigan
    EnglandBritish60901930002
    MOORHOUSE, Philip James
    1 Elmtree Grove,
    Elmfield Road
    NE3 4BG Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    1 Elmtree Grove,
    Elmfield Road
    NE3 4BG Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish10786230004
    MUIR, Christopher James Russell
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    Geschäftsführer
    Norflex House
    Allington Way
    DL1 4DY Darlington
    EnglandBritish167397320001
    MURRAY, Gerard Thomas
    34 King Edward Road
    NE30 2RP Tynemouth
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    34 King Edward Road
    NE30 2RP Tynemouth
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish87695440002
    PALLESCHI, Dominic
    2 Holdernesse
    Wynyard Woods
    TS22 5RY Billingham
    Geschäftsführer
    2 Holdernesse
    Wynyard Woods
    TS22 5RY Billingham
    EnglandBritish96240680002

    Hat PROVIDENT ENTERPRISES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage deed
    Erstellt am 21. Nov. 2002
    Geliefert am 26. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a or being 2 duke street luton beds LU2 ojh (aka woburn house 1-2 duke street) t/n BD221758. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary schedule
    Erstellt am 13. Nov. 2002
    Geliefert am 14. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the right, title and interest in the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 30. Aug. 2002
    Geliefert am 31. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All goods which are now or hereafter become the subject matter of a hiring agreement or a hire purchase agreement together with the benefit of all contracts for the sub hire or sub hire purchase of the goods. All securities guarantees and inddemnities and all proceeds of sale, insurance claims replacements and debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment and charge
    Erstellt am 11. Apr. 2002
    Geliefert am 12. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All subcontracts entered into by the company with third parties in respect of vehicles supplied by or on behalf of the chargee by way of lease hire lease purchase hire purchase or other form of hire. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Man Transcom Limited
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Asset sub-hire agreement
    Erstellt am 19. März 2002
    Geliefert am 20. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's rights title and interest in sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over sub-lease and sub lease rentals
    Erstellt am 31. Dez. 2001
    Geliefert am 17. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Mercedes benz actros 2540LS reg no. Y936 jgs, mercedes benz actros 2450LS reg no. Y937 jgs and any shares or accessories belonging thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Associates Commercial Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Aug. 2001
    Geliefert am 31. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the north east and south west sides of burr st,luton known as woburn house,2 duke st,luton; bd 210290. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over sub-lease and sub-lease rentals
    Erstellt am 14. Mai 2001
    Geliefert am 16. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the agreement or this mortgage
    Kurze Angaben
    Mercedes benz actros 2540LS registration numbers Y962 jgs,Y963 jgs and Y964 jgs and any spares or accessories belonging thereto the proceeds of sale thereof any insurance policies relating thereto (and the proceeds of any claim thereunder) any maintenance contracts of such goods guarantees manual licences certificates records and other documents relating thereto.
    Berechtigte Personen
    • Associates Commercial Corporation Limited
    Transaktionen
    • 16. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over sub-lease and sub-lease rentals
    Erstellt am 02. Apr. 2001
    Geliefert am 04. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the agreement or this mortgage
    Kurze Angaben
    Mercedes benz actros,reg/nos X416 nbh,X417 nbh,X418 nbh and any spares or accessories thereon.
    Berechtigte Personen
    • Associates Commercial Corporation LTD
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over sub-lease and sub-lease rentals
    Erstellt am 02. Apr. 2001
    Geliefert am 04. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the agreement or this mortgage
    Kurze Angaben
    Mercedes benz actros reg/nos Y935 jgs,Y931 jgs,Y932 jgs,Y933 jgs,Y934 jgs and any spares or accessories thereon.
    Berechtigte Personen
    • Associates Commercial Corporation LTD
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture over contract hire and leasing agreements
    Erstellt am 21. Dez. 2000
    Geliefert am 08. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Charge over the benefit of related sub hire contracts.
    Berechtigte Personen
    • Hitachi Credit (UK) PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master agreement
    Erstellt am 23. Sept. 1997
    Geliefert am 26. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right titke and interest in and to the sub-hire agreements described in supplemntary schedules from time o time pursuant to the master agreement and in all ancillary contracts relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Leasing Limited
    • Royscot Commercial Leasing
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    • Royscot Spa Leasing
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 18. Jan. 1995
    Geliefert am 01. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the plant machinery chattels or other equipment as listed in the schedule on the form 395 including sierra diesel reg. No. G524 gvv and 7.5 ton tipper reg. No. B824 vbw. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First fixed charge
    Erstellt am 18. Juli 1994
    Geliefert am 19. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the credit agreements (as defined therein)
    Kurze Angaben
    (I) all sub-lease agreements entered into by the company with customers of the company relating to goods owned by the company (the credit agreements) (ii) the full benefit of the monies payable under the sub-lease agreements (iii) the benefit of all guarantees and indemnities taken by the company in connection with the sub-lease agreements and (iv) the benefit of all insurances effected by the company pursuant to the terms of the sub-lease agreements in respect of the goods comprised therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mercedes-Benz Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 22. Nov. 1993
    Geliefert am 25. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 10. Juni 1992
    Geliefert am 18. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed equitable charge on all book debts subject to an agreement (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Metropolitan Factors Limited
    Transaktionen
    • 18. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 18. Dez. 1991
    Geliefert am 23. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a leasing agreement of even date
    Kurze Angaben
    All hiring agreements relating to the vehicles described on the form 395.
    Berechtigte Personen
    • Greyhound Financial Services Limited
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0