HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02359461 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 10 Grosvenor Street London W1K 4BJ |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SKE LIMITED | 30. Mai 1989 | 30. Mai 1989 |
PRECIS (889) LIMITED | 10. März 1989 | 10. März 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Jan. 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Jepson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Cole als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lawrence Hutchings als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Berger-North als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Thomson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Verschiedenes Memorandum of capital 21/10/09 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Atkins als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 5 Seiten | 288a | ||||||||||||||||||
legacy | 5 Seiten | 288a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||
legacy | 5 Seiten | 288a | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAYDON, Stuart John | Sekretär | 156 Woodland Way BR4 9LU West Wickham Kent | British | 3175210001 | ||||||
HARDIE, Nicholas Alan Scott | Geschäftsführer | Albert Square SW8 1BS London 21 | England | British | Financial Controller | 56627250001 | ||||
BEGLIN, Jane Elizabeth | Sekretär | 117 Salcott Road SW11 6DG London | British | 42646050003 | ||||||
CARSON, Clare Frances | Sekretär | 89 South Worple Way SW14 8NG London | British | 63819630001 | ||||||
FRANKS, Deborah Ann | Sekretär | 15 The Avenue KT10 0RX Claygate Essex | British | 53651150002 | ||||||
YAMAMOTO, Taizo | Sekretär | Little Warren Tattenham Crescent KT18 5NU Epsom Surrey | Japanese | 49863440001 | ||||||
ATKINS, David John | Geschäftsführer | 60 Dukes Wood Drive SL9 7LF Gerrards Cross The Barn Buckinghamshire | United Kingdom | British | Surveyor | 144036070001 | ||||
BAKER, Michael John | Geschäftsführer | 18 Seaton Close Lynden Gate Putney Heath SW15 3TJ London | British | Surveyor | 77729120001 | |||||
BERGER-NORTH, Andrew John | Geschäftsführer | Parkland Close TN13 1SL Sevenoaks 1 Kent United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 134630050001 | ||||
BROWN, Philip David Harold | Geschäftsführer | 4 Parfour Drive CR8 5HJ Kenley Surrey | British | Chartered Surveyor | 36949510001 | |||||
BYWATER, John Andrew | Geschäftsführer | Craigens Hill Foot Lane Burn Bridge HG3 1NT Harrogate North Yorkshire | England | British | Chartered Surveyor | 71820020003 | ||||
CAMP, David John | Geschäftsführer | 11 Walham Grove SW6 London | British | Director | 4807190002 | |||||
COLE, Peter William Beaumont | Geschäftsführer | Walnut Tree Farm Walnut Tree Road Pirton SG5 3PX Hitchin Hertfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 51145990001 | ||||
DANTZIC, Roy Matthew | Geschäftsführer | 65 Springfield Road St Johns Wood NW8 0QJ London | British | Director | 52294450003 | |||||
DODDS, John Andrew William | Geschäftsführer | South Cockerham Hacche Lane EX36 3EH South Molton Devon | England | British | Chartered Surveyor | 27325060004 | ||||
EMERY, Jonathan Michael | Geschäftsführer | Percy Road TW12 2JS Hampton 93 Middlesex | British | Development Manager | 78621400001 | |||||
EVERRITT, John Vincent | Geschäftsführer | Dibbles The Street The St West Clandon GU4 7SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 59698840001 | ||||
HARRIS, Iain Farlane Sim | Geschäftsführer | 1 Red Lion Cottages WD25 8BB Aldenham Hertfordshire | England | British | Accountant | 56363000001 | ||||
HUTCHINGS, Lawrence Francis | Geschäftsführer | Brody House Strype Street E1 7LQ London Flat 503 United Kingdom | England | British | Asset Manager | 134630060001 | ||||
ISHIYAMA, Tsutomu | Geschäftsführer | 1 Corringham Road HA9 9PX Wembley Middlesex | Japanese | Company Director | 35181340001 | |||||
JEPSON, Martin Clive | Geschäftsführer | 5 Longcroft Avenue SM7 3AE Banstead Surrey | United Kingdom | British | Charetered Surveyor | 92627900001 | ||||
KAJIMA, Shoichi | Geschäftsführer | Minami-Azabu Minato-Ku Tokyo 4-11-65 Japan | Japan | Japanese | Company President | 155687420001 | ||||
LIPTON, Stuart Anthony, Sir | Geschäftsführer | 40 Queens Grove NW8 6HH London | England | British | Director | 2068540001 | ||||
METTER, David Antony | Geschäftsführer | W2 | United Kingdom | British | Director | 17535810001 | ||||
NAKAGAWA, Yukiyasu | Geschäftsführer | 6 Marlborough Hill St Johns Wood NW8 0NN London | Japanese | Divisional General Manager | 40237580001 | |||||
OHORI, Shoichi | Geschäftsführer | Kohoku-Ku Yokohama Fujizuka FOREIGN 2-31-10 Japan | Japanese | Company Director | 31558170001 | |||||
SUZUKI, Fujio | Geschäftsführer | 6 Marlborough Hill St Johns Wood NW8 0NN London | Japanese | Company Director | 65931220003 | |||||
THOMSON, Andrew James Gray | Geschäftsführer | Niton Street SW6 6NJ London 10 | England | British | It Director | 97267360001 | ||||
UCHIDA, Koji | Geschäftsführer | Nakano-Ku Tokyo Shirasagi FOREIGN 3-18-5 Japan | Japanese | Company Director | 31558180001 | |||||
WRIGHT, Geoffrey Harcroft | Geschäftsführer | Michaelmas House 4 The Riddings CR3 6DW Caterham Surrey | British | Building Surveyor | 8585700001 | |||||
YAMAMOTO, Taizo | Geschäftsführer | Little Warren Tattenham Crescent KT18 5NU Epsom Surrey | Japanese | Company Director | 49863440001 |
Hat HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 30. Apr. 1993 Geliefert am 14. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or skeb limited under the terms of the deed dated 6 january 1993. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Apr. 1993 Geliefert am 14. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or skeb limited to the chargee under the terms of the deed dated 6 january 1993. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Apr. 1991 Geliefert am 16. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company and/or skeb limited to the chargee under the finance documents and this deed on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben L/H land k/a block a on north east side of melton street and north west side of euston square gardens euston road. Title no nlg 290213, l/h land - block b fluor house, euston square. Title no ngl 287021 l/h blocks c & d, being part of fluor house euston square title no ngl 290214. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of deposit of shares | Erstellt am 29. Apr. 1991 Geliefert am 02. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or skeb limited under the terms of any of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben 1) all of the companys right, title and interest in and to two ordinary shares (the 'securities') of upk 1 each beneficially owned by the company and registered in the name of the company as to the first and in the name of mr d metter as to the second. And all documents evidencing the companys title thereto deposited with or transferred to the security agent. 2) all dividends interest and other monies paid or payable on or in respect of the securities and all benefits, rights and entitlements accuring or offered at any time to or in respect of the securities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deposit agreement | Erstellt am 29. Apr. 1991 Geliefert am 02. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the obligors as defined therein to the chargee under the terms of a loan facility agreement dated 19/4/91 | |
Kurze Angaben All right, title and interest in and to all the monies standing to the credit of the "ske limited and skeb limited - deposit account" (see doc M131 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment | Erstellt am 30. Apr. 1990 Geliefert am 09. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from skeb limited to the chargee as security agent for itself and the beneficiaries under the terms of a loan agreement dated 27 april 1990 and this charge | |
Kurze Angaben Legal assignment to the security agent of the option granted to the company under option agreement dated 30 march 1990 made between the company and skeb limited in relation to the leasehold interest of skeb limited (see 395 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment | Erstellt am 30. März 1990 Geliefert am 19. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or skeb limited to the chargee under the terms of a guarantee between the company and the bank and a facility letter dated 28/3/90 between skeb limited and the bank | |
Kurze Angaben Assignment to the bank of the option granted to the company under option agreement dated 30/3/90 (please see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deposit agreement | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 30. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent on behalf of the beneficiaries (as defined in the deposit agreement) under the terms of a loan agreement dated 22.6.89 and the charge | |
Kurze Angaben All right title & interest in all monies standing to the credit of the account designated "lloyds bank PLC re: ske limited (see doc for further details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 27. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent for itself and as trustee for the beneficiaries (as defined or or referred to in the deed) under the terms of the finance documents and this charge. | |
Kurze Angaben L/H land k/a block a on the north east side of melton street and the north west side of euston square gardens euston road title no:- ngl 290213 (please see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0