HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED

HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02359461
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    10 Grosvenor Street
    London
    W1K 4BJ
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SKE LIMITED30. Mai 198930. Mai 1989
    PRECIS (889) LIMITED10. März 198910. März 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Removal of company from register 02/11/2009
    RES13

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 21. Jan. 2010

    • Kapital: GBP 172.00000
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Satzung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Subdivision/credit company profit & loss 15/10/2009
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Martin Jepson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Peter Cole als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Lawrence Hutchings als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Berger-North als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Thomson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Verschiedenes

    Memorandum of capital 21/10/09
    1 SeitenMISC

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des genehmigten Stammkapitals

    RES05

    Beendigung der Bestellung von David Atkins als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten288a

    legacy

    5 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    5 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HAYDON, Stuart John
    156 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    Sekretär
    156 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    British3175210001
    HARDIE, Nicholas Alan Scott
    Albert Square
    SW8 1BS London
    21
    Geschäftsführer
    Albert Square
    SW8 1BS London
    21
    EnglandBritishFinancial Controller56627250001
    BEGLIN, Jane Elizabeth
    117 Salcott Road
    SW11 6DG London
    Sekretär
    117 Salcott Road
    SW11 6DG London
    British42646050003
    CARSON, Clare Frances
    89 South Worple Way
    SW14 8NG London
    Sekretär
    89 South Worple Way
    SW14 8NG London
    British63819630001
    FRANKS, Deborah Ann
    15 The Avenue
    KT10 0RX Claygate
    Essex
    Sekretär
    15 The Avenue
    KT10 0RX Claygate
    Essex
    British53651150002
    YAMAMOTO, Taizo
    Little Warren Tattenham Crescent
    KT18 5NU Epsom
    Surrey
    Sekretär
    Little Warren Tattenham Crescent
    KT18 5NU Epsom
    Surrey
    Japanese49863440001
    ATKINS, David John
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishSurveyor144036070001
    BAKER, Michael John
    18 Seaton Close
    Lynden Gate Putney Heath
    SW15 3TJ London
    Geschäftsführer
    18 Seaton Close
    Lynden Gate Putney Heath
    SW15 3TJ London
    BritishSurveyor77729120001
    BERGER-NORTH, Andrew John
    Parkland Close
    TN13 1SL Sevenoaks
    1
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Parkland Close
    TN13 1SL Sevenoaks
    1
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor134630050001
    BROWN, Philip David Harold
    4 Parfour Drive
    CR8 5HJ Kenley
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Parfour Drive
    CR8 5HJ Kenley
    Surrey
    BritishChartered Surveyor36949510001
    BYWATER, John Andrew
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor71820020003
    CAMP, David John
    11 Walham Grove
    SW6 London
    Geschäftsführer
    11 Walham Grove
    SW6 London
    BritishDirector4807190002
    COLE, Peter William Beaumont
    Walnut Tree Farm
    Walnut Tree Road Pirton
    SG5 3PX Hitchin
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Walnut Tree Farm
    Walnut Tree Road Pirton
    SG5 3PX Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor51145990001
    DANTZIC, Roy Matthew
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Geschäftsführer
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    BritishDirector52294450003
    DODDS, John Andrew William
    South Cockerham
    Hacche Lane
    EX36 3EH South Molton
    Devon
    Geschäftsführer
    South Cockerham
    Hacche Lane
    EX36 3EH South Molton
    Devon
    EnglandBritishChartered Surveyor27325060004
    EMERY, Jonathan Michael
    Percy Road
    TW12 2JS Hampton
    93
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Percy Road
    TW12 2JS Hampton
    93
    Middlesex
    BritishDevelopment Manager78621400001
    EVERRITT, John Vincent
    Dibbles The Street
    The St West Clandon
    GU4 7SX Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Dibbles The Street
    The St West Clandon
    GU4 7SX Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor59698840001
    HARRIS, Iain Farlane Sim
    1 Red Lion Cottages
    WD25 8BB Aldenham
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Red Lion Cottages
    WD25 8BB Aldenham
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant56363000001
    HUTCHINGS, Lawrence Francis
    Brody House
    Strype Street
    E1 7LQ London
    Flat 503
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brody House
    Strype Street
    E1 7LQ London
    Flat 503
    United Kingdom
    EnglandBritishAsset Manager134630060001
    ISHIYAMA, Tsutomu
    1 Corringham Road
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Geschäftsführer
    1 Corringham Road
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    JapaneseCompany Director35181340001
    JEPSON, Martin Clive
    5 Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    5 Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    Surrey
    United KingdomBritishCharetered Surveyor92627900001
    KAJIMA, Shoichi
    Minami-Azabu
    Minato-Ku
    Tokyo
    4-11-65
    Japan
    Geschäftsführer
    Minami-Azabu
    Minato-Ku
    Tokyo
    4-11-65
    Japan
    JapanJapaneseCompany President155687420001
    LIPTON, Stuart Anthony, Sir
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    Geschäftsführer
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    EnglandBritishDirector2068540001
    METTER, David Antony
    W2
    Geschäftsführer
    W2
    United KingdomBritishDirector17535810001
    NAKAGAWA, Yukiyasu
    6 Marlborough Hill
    St Johns Wood
    NW8 0NN London
    Geschäftsführer
    6 Marlborough Hill
    St Johns Wood
    NW8 0NN London
    JapaneseDivisional General Manager40237580001
    OHORI, Shoichi
    Kohoku-Ku Yokohama
    Fujizuka
    FOREIGN 2-31-10 Japan
    Geschäftsführer
    Kohoku-Ku Yokohama
    Fujizuka
    FOREIGN 2-31-10 Japan
    JapaneseCompany Director31558170001
    SUZUKI, Fujio
    6 Marlborough Hill
    St Johns Wood
    NW8 0NN London
    Geschäftsführer
    6 Marlborough Hill
    St Johns Wood
    NW8 0NN London
    JapaneseCompany Director65931220003
    THOMSON, Andrew James Gray
    Niton Street
    SW6 6NJ London
    10
    Geschäftsführer
    Niton Street
    SW6 6NJ London
    10
    EnglandBritishIt Director97267360001
    UCHIDA, Koji
    Nakano-Ku Tokyo
    Shirasagi
    FOREIGN 3-18-5 Japan
    Geschäftsführer
    Nakano-Ku Tokyo
    Shirasagi
    FOREIGN 3-18-5 Japan
    JapaneseCompany Director31558180001
    WRIGHT, Geoffrey Harcroft
    Michaelmas House
    4 The Riddings
    CR3 6DW Caterham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Michaelmas House
    4 The Riddings
    CR3 6DW Caterham
    Surrey
    BritishBuilding Surveyor8585700001
    YAMAMOTO, Taizo
    Little Warren Tattenham Crescent
    KT18 5NU Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Warren Tattenham Crescent
    KT18 5NU Epsom
    Surrey
    JapaneseCompany Director49863440001

    Hat HAMMERSON (EUSTON SQUARE) ESTATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 1993
    Geliefert am 14. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or skeb limited under the terms of the deed dated 6 january 1993.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stanhope Properties PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 1993
    Geliefert am 14. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or skeb limited to the chargee under the terms of the deed dated 6 january 1993.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kajima Europe B.V.
    Transaktionen
    • 14. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company and/or skeb limited to the chargee under the finance documents and this deed on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    L/H land k/a block a on north east side of melton street and north west side of euston square gardens euston road. Title no nlg 290213, l/h land - block b fluor house, euston square. Title no ngl 287021 l/h blocks c & d, being part of fluor house euston square title no ngl 290214. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank Plcfor Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit of shares
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 02. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or skeb limited under the terms of any of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    1) all of the companys right, title and interest in and to two ordinary shares (the 'securities') of upk 1 each beneficially owned by the company and registered in the name of the company as to the first and in the name of mr d metter as to the second. And all documents evidencing the companys title thereto deposited with or transferred to the security agent. 2) all dividends interest and other monies paid or payable on or in respect of the securities and all benefits, rights and entitlements accuring or offered at any time to or in respect of the securities.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC(As Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 02. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit agreement
    Erstellt am 29. Apr. 1991
    Geliefert am 02. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the obligors as defined therein to the chargee under the terms of a loan facility agreement dated 19/4/91
    Kurze Angaben
    All right, title and interest in and to all the monies standing to the credit of the "ske limited and skeb limited - deposit account" (see doc M131 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Sumitomo Bank Limiteddefined)as Agent and Trustees for the Beneficiaries (As
    Transaktionen
    • 02. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 30. Apr. 1990
    Geliefert am 09. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from skeb limited to the chargee as security agent for itself and the beneficiaries under the terms of a loan agreement dated 27 april 1990 and this charge
    Kurze Angaben
    Legal assignment to the security agent of the option granted to the company under option agreement dated 30 march 1990 made between the company and skeb limited in relation to the leasehold interest of skeb limited (see 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 30. März 1990
    Geliefert am 19. Apr. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or skeb limited to the chargee under the terms of a guarantee between the company and the bank and a facility letter dated 28/3/90 between skeb limited and the bank
    Kurze Angaben
    Assignment to the bank of the option granted to the company under option agreement dated 30/3/90 (please see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    A deposit agreement
    Erstellt am 23. Juni 1989
    Geliefert am 30. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent on behalf of the beneficiaries (as defined in the deposit agreement) under the terms of a loan agreement dated 22.6.89 and the charge
    Kurze Angaben
    All right title & interest in all monies standing to the credit of the account designated "lloyds bank PLC re: ske limited (see doc for further details).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Juni 1989
    Geliefert am 27. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent for itself and as trustee for the beneficiaries (as defined or or referred to in the deed) under the terms of the finance documents and this charge.
    Kurze Angaben
    L/H land k/a block a on the north east side of melton street and the north west side of euston square gardens euston road title no:- ngl 290213 (please see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC Securityficiaries)as Agent (For Itself and as Trustee for the Bene
    Transaktionen
    • 27. Juni 1989Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0