ARRIVA DERBY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameARRIVA DERBY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02362274
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ARRIVA DERBY LIMITED?

    • Sonstiger Personenlandverkehr im Stadt-, Vorort- oder Ballungsraum (nicht U-Bahn, Metro oder ähnlich) (49319) / Verkehr und Lagerei
    • Taxibetrieb (49320) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich ARRIVA DERBY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ARRIVA DERBY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DERBY CITY TRANSPORT LIMITED15. Sept. 198915. Sept. 1989
    DARTPINE LIMITED16. März 198916. März 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARRIVA DERBY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für ARRIVA DERBY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Change of details for Arriva (2007) Limited as a person with significant control on 10. Nov. 2017

    2 SeitenPSC05

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP zum 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor York North Yorkshire YO30 4XG am 14. März 2017

    2 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 27. Feb. 2017

    LRESSP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    12 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Simon William Mathieson als Geschäftsführer am 27. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Bowler als Geschäftsführer am 27. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Robert James Cheveaux als Geschäftsführer am 27. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Antony Bowd als Geschäftsführer am 27. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Lorna Edwards als Direktor am 27. Juni 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. März 2016

    Kapitalaufstellung am 10. März 2016

    • Kapital: GBP 3,108,173
    SH01

    Ernennung von Mark Antony Bowd als Direktor am 22. Jan. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von John Charles Barlow als Geschäftsführer am 27. Nov. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Alexander Donald Perry als Geschäftsführer am 31. Aug. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    9 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Mark David James Yexley als Geschäftsführer am 03. Juli 2015

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Simon William Mathieson am 28. Apr. 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. März 2015

    Kapitalaufstellung am 10. März 2015

    • Kapital: GBP 3,108,173
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    19 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Matthew Evans als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. März 2014

    Kapitalaufstellung am 10. März 2014

    • Kapital: GBP 3,108,173
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von ARRIVA DERBY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Sekretär
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    183720730001
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    EnglandBritish205425080001
    BOWLER, Richard Anthony
    4 Waterfield Road
    Cropston
    LE7 7HN Leicester
    Sekretär
    4 Waterfield Road
    Cropston
    LE7 7HN Leicester
    British35116070001
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    JARRATT, Andrew Howard
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    British1860730001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Sekretär
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BARLOW, John Charles
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish66466620003
    BAXTER, Barry James
    5 Denver Fold
    ST17 9XE Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    5 Denver Fold
    ST17 9XE Stafford
    Staffordshire
    British83122700001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BICKLE, Kenneth
    Langton Cottage
    Roston
    DE6 2EH Ashbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Langton Cottage
    Roston
    DE6 2EH Ashbourne
    Derbyshire
    British3036960002
    BOWD, Mark Antony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish204447910001
    BOWD, Mark Antony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish204447910001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish35116070003
    BOWLER, Richard Charles
    23b Brazenose Driftway
    Cowley
    OX4 2QY Oxford
    Geschäftsführer
    23b Brazenose Driftway
    Cowley
    OX4 2QY Oxford
    British51739150001
    CHALLANDS, John Frank
    218 Caxton Street
    Sunnyhill
    DE23 7RB Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    218 Caxton Street
    Sunnyhill
    DE23 7RB Derby
    Derbyshire
    British12008050001
    CHEVEAUX, Robert James
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    WalesBritish182114820001
    CLARKE, Kenneth Barry
    2 Sherwood Drive
    WF2 7QT Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Sherwood Drive
    WF2 7QT Wakefield
    West Yorkshire
    British76952760002
    CLAYTON, Stephen John
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish46866840005
    CUMMING, Graham Jackson
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    Geschäftsführer
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    British22410440002
    DYBALL, Richard Charles
    110
    Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    Geschäftsführer
    110
    Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    British33781930001
    EDGE, Christopher
    46 Howards Lane
    Putney
    SW15 6NJ London
    Geschäftsführer
    46 Howards Lane
    Putney
    SW15 6NJ London
    British11465390001
    EVANS, Matthew John
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish197082950001
    HARVEY, Peter
    Chapel End 36 Main Street
    Swithland
    LE12 8TH Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Chapel End 36 Main Street
    Swithland
    LE12 8TH Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish30318040003
    HIND, Robert Andrew
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish21961900003
    HIND, Robert Andrew
    173 Station Road
    Cropston
    LE7 7HH Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    173 Station Road
    Cropston
    LE7 7HH Leicester
    Leicestershire
    British21961900001
    HOPKINS, Christian
    Whitehill Avenue
    LU1 3SP Luton
    46
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Whitehill Avenue
    LU1 3SP Luton
    46
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish248192360001
    JARRATT, Andrew Howard
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Thatched Cottage Church Lane
    Attenborough
    NG9 6AS Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish1860730001
    JOHNSTONE, David Graham
    7 Pont Haugh
    Eland Mews Ponteland
    NE20 9XD Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    7 Pont Haugh
    Eland Mews Ponteland
    NE20 9XD Newcastle Upon Tyne
    British95834280001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    LLOYD, Alfred
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish131555780001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Geschäftsführer
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ARRIVA DERBY LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Admiral Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    1
    England
    06. Apr. 2016
    Admiral Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    1
    England
    Nein
    RechtsformCompany Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer4166672
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat ARRIVA DERBY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 10. Okt. 2008
    Geliefert am 17. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The mortgagor assigns by way of security and charges with full title guarantee all of its right title and interest in the goods specified in the schedule please see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 09. Sept. 1994
    Geliefert am 23. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined therein)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston"the Agent"
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over shares
    Erstellt am 09. Sept. 1994
    Geliefert am 23. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the first national bank of boston (as agent and trustee for the beneficiaries -as defined) under or pursuant to terms of the charge,
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and under the shares as deposited or ot be deposited with the agent to secure the due payment and discharge of the indebtedness, the shares being all the ordinary shares held by the derby city transport limited (ordinary shares of £1 each, company name jolmino limited) please see doc for further details,.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston,
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Erstellt am 15. Aug. 1994
    Geliefert am 31. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 07. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £81,585 due under the agreement
    Kurze Angaben
    All rights,title and interest in all sums payable.see form 395.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 07. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A credit agreement
    Erstellt am 14. Sept. 1992
    Geliefert am 24. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £72203.04 under the agreement
    Kurze Angaben
    All its right title and interest under the insurance polices for details see form 395 ref:397.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limted
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 25. Aug. 1989
    Geliefert am 14. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage over land & building situate at ascot drive derby and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 16. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ARRIVA DERBY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. Feb. 2017Beginn der Liquidation
    25. Dez. 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Adam Broadbent
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Praktiker
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Ian James Royle
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    Praktiker
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0