ARRIVA DERBY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ARRIVA DERBY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02362274 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ARRIVA DERBY LIMITED?
- Sonstiger Personenlandverkehr im Stadt-, Vorort- oder Ballungsraum (nicht U-Bahn, Metro oder ähnlich) (49319) / Verkehr und Lagerei
- Taxibetrieb (49320) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich ARRIVA DERBY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York North Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ARRIVA DERBY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DERBY CITY TRANSPORT LIMITED | 15. Sept. 1989 | 15. Sept. 1989 |
| DARTPINE LIMITED | 16. März 1989 | 16. März 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARRIVA DERBY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ARRIVA DERBY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Change of details for Arriva (2007) Limited as a person with significant control on 10. Nov. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP zum 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor York North Yorkshire YO30 4XG am 14. März 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon William Mathieson als Geschäftsführer am 27. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Bowler als Geschäftsführer am 27. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert James Cheveaux als Geschäftsführer am 27. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Antony Bowd als Geschäftsführer am 27. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Lorna Edwards als Direktor am 27. Juni 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mark Antony Bowd als Direktor am 22. Jan. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Charles Barlow als Geschäftsführer am 27. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alexander Donald Perry als Geschäftsführer am 31. Aug. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark David James Yexley als Geschäftsführer am 03. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon William Mathieson am 28. Apr. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Evans als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ARRIVA DERBY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARDS, Lorna | Sekretär | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village North Yorkshire | 183720730001 | |||||||
| EDWARDS, Lorna | Geschäftsführer | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village North Yorkshire | England | British | 205425080001 | |||||
| BOWLER, Richard Anthony | Sekretär | 4 Waterfield Road Cropston LE7 7HN Leicester | British | 35116070001 | ||||||
| DAVIES, Elizabeth Anne | Sekretär | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
| JARRATT, Andrew Howard | Sekretär | Thatched Cottage Church Lane Attenborough NG9 6AS Nottingham Nottinghamshire | British | 1860730001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Sekretär | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Sekretär | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
| BARLOW, John Charles | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 66466620003 | |||||
| BAXTER, Barry James | Geschäftsführer | 5 Denver Fold ST17 9XE Stafford Staffordshire | British | 83122700001 | ||||||
| BAYFIELD, Stephen | Geschäftsführer | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BAYFIELD, Stephen | Geschäftsführer | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BICKLE, Kenneth | Geschäftsführer | Langton Cottage Roston DE6 2EH Ashbourne Derbyshire | British | 3036960002 | ||||||
| BOWD, Mark Antony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 204447910001 | |||||
| BOWD, Mark Antony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 204447910001 | |||||
| BOWLER, Richard Anthony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 35116070003 | |||||
| BOWLER, Richard Charles | Geschäftsführer | 23b Brazenose Driftway Cowley OX4 2QY Oxford | British | 51739150001 | ||||||
| CHALLANDS, John Frank | Geschäftsführer | 218 Caxton Street Sunnyhill DE23 7RB Derby Derbyshire | British | 12008050001 | ||||||
| CHEVEAUX, Robert James | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | Wales | British | 182114820001 | |||||
| CLARKE, Kenneth Barry | Geschäftsführer | 2 Sherwood Drive WF2 7QT Wakefield West Yorkshire | British | 76952760002 | ||||||
| CLAYTON, Stephen John | Geschäftsführer | New Hall Farmhouse Fanhams Hall Road Newhall Green Wareside SG12 7SD Ware Hertfordshire | England | British | 46866840005 | |||||
| CUMMING, Graham Jackson | Geschäftsführer | Tudor House 19 Ashpole Furlong Loughton MK5 8EA Milton Keynes | British | 22410440002 | ||||||
| DYBALL, Richard Charles | Geschäftsführer | 110 Upper Harlestone NN7 4EL Northampton | British | 33781930001 | ||||||
| EDGE, Christopher | Geschäftsführer | 46 Howards Lane Putney SW15 6NJ London | British | 11465390001 | ||||||
| EVANS, Matthew John | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 197082950001 | |||||
| HARVEY, Peter | Geschäftsführer | Chapel End 36 Main Street Swithland LE12 8TH Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 30318040003 | |||||
| HIND, Robert Andrew | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 21961900003 | |||||
| HIND, Robert Andrew | Geschäftsführer | 173 Station Road Cropston LE7 7HH Leicester Leicestershire | British | 21961900001 | ||||||
| HOPKINS, Christian | Geschäftsführer | Whitehill Avenue LU1 3SP Luton 46 Bedfordshire United Kingdom | England | British | 248192360001 | |||||
| JARRATT, Andrew Howard | Geschäftsführer | Thatched Cottage Church Lane Attenborough NG9 6AS Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 1860730001 | |||||
| JOHNSTONE, David Graham | Geschäftsführer | 7 Pont Haugh Eland Mews Ponteland NE20 9XD Newcastle Upon Tyne | British | 95834280001 | ||||||
| JONES, Michael Adrian | Geschäftsführer | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 77984700001 | |||||
| LLOYD, Alfred | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 131555780001 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Geschäftsführer | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Geschäftsführer | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Geschäftsführer | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ARRIVA DERBY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriva Uk Bus Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ARRIVA DERBY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Erstellt am 10. Okt. 2008 Geliefert am 17. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The mortgagor assigns by way of security and charges with full title guarantee all of its right title and interest in the goods specified in the schedule please see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 09. Sept. 1994 Geliefert am 23. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 09. Sept. 1994 Geliefert am 23. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the first national bank of boston (as agent and trustee for the beneficiaries -as defined) under or pursuant to terms of the charge, | |
Kurze Angaben All right title and interest in and under the shares as deposited or ot be deposited with the agent to secure the due payment and discharge of the indebtedness, the shares being all the ordinary shares held by the derby city transport limited (ordinary shares of £1 each, company name jolmino limited) please see doc for further details,. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge and set-off over credit balances | Erstellt am 15. Aug. 1994 Geliefert am 31. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994 | |
Kurze Angaben All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit agreement | Erstellt am 27. Aug. 1993 Geliefert am 07. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £81,585 due under the agreement | |
Kurze Angaben All rights,title and interest in all sums payable.see form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A credit agreement | Erstellt am 14. Sept. 1992 Geliefert am 24. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £72203.04 under the agreement | |
Kurze Angaben All its right title and interest under the insurance polices for details see form 395 ref:397. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 25. Aug. 1989 Geliefert am 14. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage over land & building situate at ascot drive derby and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ARRIVA DERBY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0