MIDLANDS RADIO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMIDLANDS RADIO LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02365381
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MIDLANDS RADIO LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MIDLANDS RADIO PLC03. Juli 198903. Juli 1989
    NECTARPLACE PLC23. März 198923. März 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    8 SeitenAA

    legacy

    38 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Kapitalaufstellung am 03. Dez. 2019

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 19. Nov. 2019

    • Kapital: GBP 4,001,000
    3 SeitenSH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 10. Dez. 2018

    • Kapital: GBP 1,000.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of the share premium account and cancellation of the capital redemption reserve 04/12/2018
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Anthony Keenan am 25. Sept. 2018

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Sekretär
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United KingdomBritishManaging Director109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritishPublisher243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritishFinance Director119137220004
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector54693600002
    FLUET, Cliff
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    Sekretär
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    British97684290001
    LOCKWOOD, John Trevor
    2 South Street
    Barrow-Upon-Soar
    LE12 8LZ Loughborough
    Leicestershire
    Sekretär
    2 South Street
    Barrow-Upon-Soar
    LE12 8LZ Loughborough
    Leicestershire
    British9159330001
    MANNING, Richard Denley John
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    Sekretär
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    British77961690001
    NAISMITH, Roy Cameron
    The Corn Store
    Manor Farm Barns
    SO24 9DH Old Alresford
    Hampshire
    Sekretär
    The Corn Store
    Manor Farm Barns
    SO24 9DH Old Alresford
    Hampshire
    British50349450001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Sekretär
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    SCHWARZ, Nathalie Esther
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    Sekretär
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    BritishCompany Secretary59245010001
    WHITE, Steven Nicholas
    35 Malting Close
    Stoke Goldington
    MK16 8NX Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Sekretär
    35 Malting Close
    Stoke Goldington
    MK16 8NX Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British43421870001
    ALLEN, Charles Lamb
    Victoria Road
    W8 5RH London
    71
    Geschäftsführer
    Victoria Road
    W8 5RH London
    71
    United KingdomBritishDirector142635780001
    BAGLEY, David Laurence
    19 Darnford Lane
    WS14 9RW Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    19 Darnford Lane
    WS14 9RW Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishManaging Director10984400001
    BATTMAN, Geoffrey Neil
    Wakeley Cottage The Green
    Tanworth In Arden
    B94 5AL Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Wakeley Cottage The Green
    Tanworth In Arden
    B94 5AL Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director2326960001
    CHATAWAY, Christopher, Sir
    80 Maida Vale
    W9 1PR London
    Geschäftsführer
    80 Maida Vale
    W9 1PR London
    BritishCompany Director33231970001
    COLES, Ronald John
    Manor Farm Main Street
    Upton
    NG23 5ST Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Manor Farm Main Street
    Upton
    NG23 5ST Newark
    Nottinghamshire
    BritishManaging Director9159370001
    CONNOLE, Michael Damien
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    Geschäftsführer
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    EnglandIrishAccountant47934750001
    DAVIES, Paul Richard
    28 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    Geschäftsführer
    28 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    BritishCompany Director55332120002
    EVANS, Mark Roy
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritishFinance Director54693600002
    EYRE, Richard Anthony
    31 Croham Park Avenue
    CR2 7HN South Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    31 Croham Park Avenue
    CR2 7HN South Croydon
    Surrey
    BritishManaging Director5219910001
    HARRIS, Peter Jonathan
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    Geschäftsführer
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    EnglandBritishAccountant40917640001
    LEADBEATER, Edward Timothy David
    Crofts Cottage Bagot Street
    Abbots Bromley
    WS15 3DB Rugeley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Crofts Cottage Bagot Street
    Abbots Bromley
    WS15 3DB Rugeley
    Staffordshire
    BritishSolicitor34775550001
    LOCKWOOD, John Trevor
    2 South Street
    Barrow-Upon-Soar
    LE12 8LZ Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    2 South Street
    Barrow-Upon-Soar
    LE12 8LZ Loughborough
    Leicestershire
    BritishCompany Director9159330001
    MANNING, Richard Denley John
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    Geschäftsführer
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    United KingdomBritishSolicitor77961690001
    MANSFIELD, David James
    16 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    Geschäftsführer
    16 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    United KingdomBritishGroup Commercial Director32585450001
    NAISMITH, Roy Cameron
    The Corn Store
    Manor Farm Barns
    SO24 9DH Old Alresford
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Corn Store
    Manor Farm Barns
    SO24 9DH Old Alresford
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant50349450001
    ORCHARD, Stephen
    Clements Meadow Cross Lane
    SN8 1JZ Marlborough
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Clements Meadow Cross Lane
    SN8 1JZ Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector46952160003
    PALLOT, Wendy Monica
    The Willows
    Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    The Willows
    Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritishAccountant74832570006
    PARK, Richard Francis Jackson
    55 Gloucester Crescent
    NW1 7EG London
    Geschäftsführer
    55 Gloucester Crescent
    NW1 7EG London
    EnglandBritishCompany Director75081070002
    PARKINSON, Arnold John
    50 Links Drive
    B91 2DL Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    50 Links Drive
    B91 2DL Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director4093310001
    RILEY, Philip Stephen
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritishChief Executive140085310001
    RUFUS, Ian Douglas
    55 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    55 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director14867850005
    STANGER, Edward
    Whitewings Southmeads Road
    Oadby
    LE2 2LR Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Whitewings Southmeads Road
    Oadby
    LE2 2LR Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishCompany Director10498070001
    STANLEY, Ailsa
    7 Trentdale Road
    Carlton
    NG4 1BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    7 Trentdale Road
    Carlton
    NG4 1BU Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishJournalist10100130001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MIDLANDS RADIO LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06. Apr. 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom (England)
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer06898191
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MIDLANDS RADIO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 20. Mai 2011
    Geliefert am 27. Mai 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the note issuer and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Price
    Transaktionen
    • 27. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 20. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Matthew Paul Ramsbottom
    Transaktionen
    • 20. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 29. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 20. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robert John Norman
    Transaktionen
    • 20. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 18. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Geoffrey Percy
    Transaktionen
    • 18. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 13. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media holdings limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Global Radio Group Limited
    Transaktionen
    • 13. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Philip Riley
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Antony Thomas Lloyd
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 05. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All land vested in or charged to the chargor, all fixtures and fittings attached to the land and all rents, all plant & machinery, contacts goodwill uncalled capital stocks shares patents copyrights and all other intellectual property rights. A floating charge over all the other property assets and rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Consideration letter between the company and the governor and company of the bank of scotland (in its capacity as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries ("the security trustee")
    Erstellt am 21. Feb. 2001
    Geliefert am 08. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys as at 21 april 2000 or at any time thereafter owing to the security trustee and security beneficiaries by the principal debtors or any of them (where any company is also a principal debtor, the liability of such company to the security beneficiaries under the deed shall only have effect in relation to all the other principal debtors) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge
    Erstellt am 20. Apr. 2000
    Geliefert am 04. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the principal debtors (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All moneys as at 20 april 2000 or at any time thereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the books of the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge
    Erstellt am 31. Okt. 1996
    Geliefert am 06. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the books of the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge
    Erstellt am 04. Apr. 1995
    Geliefert am 07. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the comapny in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge
    Erstellt am 03. Juni 1994
    Geliefert am 11. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Sept. 1991
    Geliefert am 20. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to rear of radio house, aston road north birmingham west midlands park of t/n wk 97666.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Feb. 1991
    Geliefert am 18. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & premises k/a radio house, 79-84 aston road north, aston, birmingham west midlands t/nwk 97666.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Feb. 1991
    Geliefert am 15. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0