NORTHGATE (AVR) DEALERSHIP RENTALS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NORTHGATE (AVR) DEALERSHIP RENTALS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02367759 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NORTHGATE (AVR) DEALERSHIP RENTALS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich NORTHGATE (AVR) DEALERSHIP RENTALS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Norflex House Allington Way DL1 4DY Darlington County Durham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NORTHGATE (AVR) DEALERSHIP RENTALS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ARRIVA DEALERSHIP RENTALS LIMITED | 12. Jan. 2000 | 12. Jan. 2000 |
| ARRIVA AUTOMOTIVE SOLUTIONS (10) LIMITED | 19. Nov. 1997 | 19. Nov. 1997 |
| COWIE INTERLEASING (10) LIMITED | 03. Apr. 1989 | 03. Apr. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORTHGATE (AVR) DEALERSHIP RENTALS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NORTHGATE (AVR) DEALERSHIP RENTALS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Nov. 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Muir als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Stephen Laker als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr David Henderson am 30. Apr. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Henderson am 30. Apr. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Muir als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Moorhouse als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NORTHGATE (AVR) DEALERSHIP RENTALS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENDERSON, David | Sekretär | Norflex House Allington Way DL1 4DY Darlington County Durham | British | 2240270003 | ||||||
| HENDERSON, David | Geschäftsführer | Norflex House Allington Way DL1 4DY Darlington County Durham | England | British | 2240270003 | |||||
| LAKER, Richard Stephen | Geschäftsführer | Norflex House Allington Way DL1 4DY Darlington County Durham | United Kingdom | British | 160256950001 | |||||
| THORPE, Elizabeth Anne | Sekretär | 2 Oakwood DH7 0NP Lanchester County Durham | British | 102907000001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Sekretär | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| COWIE, Thomas, Sir | Geschäftsführer | Broadwood Hall DH7 0TD Lanchester County Durham | United Kingdom | British | 142033700001 | |||||
| HODGSON, Gordon William | Geschäftsführer | Bramble House Easington Lane DH5 0QX Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | 1108360001 | ||||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Geschäftsführer | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| METCALFE, Richard | Geschäftsführer | 6 Dawber Delph Appley Bridge WN6 9LN Wigan | England | British | 60901930002 | |||||
| MOORHOUSE, Philip James | Geschäftsführer | 1 Elmtree Grove, Elmfield Road NE3 4BG Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 10786230004 | |||||
| MUIR, Christopher James Russell | Geschäftsführer | Norflex House Allington Way DL1 4DY Darlington County Durham | England | British | 167397320001 | |||||
| MURRAY, Gerard Thomas | Geschäftsführer | 34 King Edward Road NE30 2RP Tynemouth Tyne & Wear | United Kingdom | British | 87695440002 | |||||
| PALLESCHI, Dominic | Geschäftsführer | 2 Holdernesse Wynyard Woods TS22 5RY Billingham | England | British | 96240680002 | |||||
| PYKETT, Terrance Neil | Geschäftsführer | Humblebee Hall WR7 4PF North Piddle Worcestershire | England | British | 8804520002 | |||||
| RAY, John Alfred | Geschäftsführer | 37 Harefield Long Melford CO10 9DE Sudbury Suffolk | British | 58415290002 |
Hat NORTHGATE (AVR) DEALERSHIP RENTALS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 22. Juni 1992 Geliefert am 25. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in its capacity as trustee for the beneficiaries (as defined in the inter creditor deed dated 17.6.92)(the "security trustee") and/or to the beneficiaries under or pursuant to the relevant documents (as defined)includingthis debenture | |
Kurze Angaben See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Suplemental guarantee & debenture | Erstellt am 08. Sept. 1989 Geliefert am 13. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the comapny and/or all or any of the other campanies named therein to the chargee as agent for itself and the banks as defined. On any account whatsoever | |
Kurze Angaben The undertaking and all property and assets of the company. See doc for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0