ANIX GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ANIX GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02367983 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ANIX GROUP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ANIX GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4 Triton Square Triton Square NW1 3HG London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ANIX GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ANIX COMPUTERS LIMITED | 31. Mai 1990 | 31. Mai 1990 |
| ANIX LIMITED | 17. Okt. 1989 | 17. Okt. 1989 |
| DAPPLESTONE COMPUTERS LIMITED | 04. Apr. 1989 | 04. Apr. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANIX GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ANIX GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 06. Juli 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Juni 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Adrian Paul Gregory als Direktor am 01. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ursula Franziska Morgenstern als Geschäftsführer am 01. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 39 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Chad Sterling Harris als Direktor am 01. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von York Place Company Secretaries Limited als Sekretär am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Terrence John Loughrey als Sekretär am 01. Juli 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Michael Peffer als Sekretär am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Lee Taylor als Geschäftsführer am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Graham als Geschäftsführer am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ANIX GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUGHREY, James Terrence John | Sekretär | Triton Square NW1 3HG London 4 Triton Square England | 199012170001 | |||||||||||
| GREGORY, Adrian Paul | Geschäftsführer | Triton Square NW1 3HG London 4 Triton Square England | England | British | 203421120001 | |||||||||
| HARRIS, Chad Sterling | Geschäftsführer | N. Haskell Ave. 75204 Dallas 2828 Texas Usa | United States | American | 199018650001 | |||||||||
| PROCH, Michel Alain | Geschäftsführer | c/o Atos Se Quai Voltaire 95877 Bezons River Ouest, 80 France | France | French | 167956020001 | |||||||||
| BRICKMAN, Lowell K | Sekretär | 4024 Enclave Mesa Circle Austin Texas 78731 Usa | United States | 127222980001 | ||||||||||
| COOPER, Paul Antony | Sekretär | 35 Colston Avenue BS1 4TT Bristol Avon | British | 41111910001 | ||||||||||
| DJURIC, George | Sekretär | Farm Watery Lane MK19 6DZ Beachampton Grange Buckinghamshire England | British | 180779760001 | ||||||||||
| DUNKLEY, Michael Robert Paul | Sekretär | 53 Waterford Close Thornbury BS35 2HU Bristol Avon | British | 19347000001 | ||||||||||
| GILBERT, Julie Helen | Sekretär | 124 Ormonds Close Bradley Stoke BS32 0DY Bristol | British | 86072560001 | ||||||||||
| PEFFER, James Michael | Sekretär | N Haskell Avenue 75204 Dallas 2828 Texas Usa | 167316460001 | |||||||||||
| SIMMONDS, Mark Oakley | Sekretär | 2 Glendower House Clifton Down BS8 3BP Bristol Avon | British | 44853240002 | ||||||||||
| BEACH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 76729800001 | |||||||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | York Place LS1 2EZ Leeds White Rose House 28a West Yorkshire |
| 51066720001 | ||||||||||
| AHLUWALIA, Inderjit | Geschäftsführer | 2 Orchard Close The Mount Winterbourne BS17 5BE Bristol Avon | British | 46393210001 | ||||||||||
| ARROWSMITH, Robert George | Geschäftsführer | 8 Brendon Drive KT10 9EQ Esher | United Kingdom | British | 70780350004 | |||||||||
| BALDWIN, Anthony John | Geschäftsführer | 16 Lynch Road GL13 9TA Berkeley Gloucestershire | British | 46963020001 | ||||||||||
| BROOKS, Alan Russell | Geschäftsführer | Hortonwood TF1 7GT Telford 37 Shropshire | United Kingdom | English | 152133250002 | |||||||||
| BROWN, Charles | Geschäftsführer | 1 Hill Farm Cottage Hill Farm Lane AL6 9BN Ayot St Lawrence Hertfordshire | British | 99539020001 | ||||||||||
| CORNISH, Neil David | Geschäftsführer | Chesnut House Ashley Road GL52 6PH Cheltenham Gloucestershire | England | British | 125871580001 | |||||||||
| DJURIC, George | Geschäftsführer | Farm Watery Lane MK19 6DZ Beachampton Grange Buckinghamshire England | England | British | 180779760001 | |||||||||
| FERGUSON, Alan | Geschäftsführer | Middle Street Ashcott TA7 9QG Bridgwater 2 Somerset | United Kingdom | British | 132201720001 | |||||||||
| GRAHAM, Steven | Geschäftsführer | 4548 Arcady Ave Highland Park Texas 75205 Usa | Usa | United States | 127222880001 | |||||||||
| HOWARTH, Clive Duncan Ward | Geschäftsführer | The Old Barn Compton Dando BS18 4LA Bristol Avon | British | 33870940001 | ||||||||||
| JAMES, Derrell | Geschäftsführer | Groves Circle 76226 Argyle 3 Texas United States | Usa | American | 139135010001 | |||||||||
| MCDERMOTT, Kevin | Geschäftsführer | Floor Ringway House Bell Road RG24 8FB Basingstoke 2nd Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 155228700001 | |||||||||
| MILLING, Mark Baird | Geschäftsführer | 9 Millford Street Southville BS3 1EE Bristol | British | 99539270002 | ||||||||||
| MORGENSTERN, Ursula Franziska | Geschäftsführer | Triton Square NW1 3HG London 4 Triton Square England | England | German | 169985440001 | |||||||||
| RATHBONE, John James | Geschäftsführer | Wedgewood Sarratt Lane Loudwater WD3 4AS Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 12232920002 | |||||||||
| SHEPPARD, Paul Jeremy | Geschäftsführer | 81 Johnson Road Emersons Green BS16 7JP Bristol Avon | England | British | 110186990001 | |||||||||
| SIMMONDS, Mark Oakley | Geschäftsführer | 2 Glendower House Clifton Down BS8 3BP Bristol Avon | United Kingdom | British | 44853240002 | |||||||||
| SMITH, Andrew Ian | Geschäftsführer | The Lodge 31 Hook Hill CR2 0LB Sanderstead Surrey | England | English | 94602120001 | |||||||||
| TAYLOR, Kevin Lee, Mr. | Geschäftsführer | Triton Square NW1 3HG London 4 Triton Square England | England | British | 261210950001 | |||||||||
| TOMALIN, Andrew Simon Edward | Geschäftsführer | The Old Fleece Stanley Downton GL10 3QS Stonehouse Gloucestershire | United Kingdom | British | 4685800002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ANIX GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atos It Outsourcing Services Limited | 06. Apr. 2016 | Triton Square Regent's Place NW1 3HG London 4 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ANIX GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 07. Aug. 2007 Geliefert am 11. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Juni 2005 Geliefert am 11. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or anix holdings limited, anix computers limited, anix business systems limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 3 the alpha centre armstrong way great western business park yate t/no AV173886. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 08. Dez. 1999 Geliefert am 14. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present or future obligations and liabilities owing by any chargor (as defined) to the chargee under the facility documents (as defined) or any other document; | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 19. Feb. 1997 Geliefert am 25. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 04. Sept. 1996 Geliefert am 10. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/as 1 & 2 the alpha centre yate bristol avon t/no AV175230 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0