HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02371285 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Hanover Square W1S 1HQ London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DEALPLAN LIMITED | 12. Apr. 1989 | 12. Apr. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 34 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 35 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 36 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Duncan Charles Eades Walker als Geschäftsführer am 12. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Duncan Charles Eades Walker als Geschäftsführer am 12. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Eric Slade als Geschäftsführer am 25. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Helical Registrars Limited am 01. Sept. 2014 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jack Struan Pitman als Geschäftsführer am 13. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 11-15 Farm Street London W1J 5RS zum 5 Hanover Square London W1S 1HQ am 19. Aug. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy John Murphy als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Mcnair Scott als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELICAL REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England |
| 89869830001 | ||||||||||
| KAYE, Gerald Anthony | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | United Kingdom | British | 38299690006 | |||||||||
| MURPHY, Timothy John | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | England | British | 40547240005 | |||||||||
| FREEMAN, Benjamin Patrick | Sekretär | 24 Hurst Road KT8 9AF East Molesey Surrey | British | 105715820001 | ||||||||||
| GONDHIA, Sima | Sekretär | 114 Squirrels Heath Lane RM11 2DY Hornchurch Essex | British | 83926180001 | ||||||||||
| GONDHIA, Sima | Sekretär | 114 Squirrels Heath Lane RM11 2DY Hornchurch Essex | British | 83926180001 | ||||||||||
| MARSTON, Lisa Margaret | Sekretär | 18 Terrapin Road Tooting SW17 8QN London | British | 27528570001 | ||||||||||
| ROLFE, Lee-Ann | Sekretär | Flat 2 307 Upper Richmond Road Putney SW15 6SS London | South African | 79280470001 | ||||||||||
| BROWN, Philip Michael | Geschäftsführer | Battle House Elvendon Road RG8 0DR Goring Oxfordshire | United Kingdom | British | 191384330001 | |||||||||
| BUTCHER, Michael William | Geschäftsführer | 19 Rigault Road SW6 4JJ London | British | 1279410002 | ||||||||||
| INWOOD, John Charles | Geschäftsführer | Letterbox House 58 Windmill Road TW12 1QU Hampton Hill Middlesex | United Kingdom | British | 56398550002 | |||||||||
| KAYE, Gerald Anthony | Geschäftsführer | Henham CM22 6AH Bishops Stortford The Glebe House Hertfordshire | United Kingdom | British | 38299690006 | |||||||||
| MCNAIR SCOTT, Nigel Guthrie | Geschäftsführer | 11-15 Farm Street London W1J 5RS | England | British | 6065190002 | |||||||||
| MOSS, Brian | Geschäftsführer | 70 Deverill Court Avenue Road SE20 7SA London | British | 35008800001 | ||||||||||
| PITMAN, Jack Struan | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | England | British | 74487000002 | |||||||||
| SCOTT, Clive David | Geschäftsführer | Eildon Hall TD6 9HD Melrose Roxburghshire | British | 48826800001 | ||||||||||
| SLADE, Michael Eric | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | England | British | 38913980001 | |||||||||
| WALKER, Duncan Charles Eades | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | England | British | 129346360008 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helical Plc | 06. Apr. 2016 | Hanover Square W1S 1HQ London 5 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 02. Juli 1999 Geliefert am 21. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or helical bar PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north east side of winterstoke road weston super mare north somerset t/n AV166133. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Apr. 1998 Geliefert am 01. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities due or to become due from helical bar PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property known as vaults under the footway on the south west side of kingsway london borough of camden; t/no 218813. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Apr. 1998 Geliefert am 01. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities due or to become due from helical bar PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as international buildings 67/75 kingsway london borough of camden; t/no ngl 334488. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Okt. 1997 Geliefert am 06. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or helical bar PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Great surrey house 203 to 208 blackfriars road (inclusive) southwark l/b of southwark t/no's SGL322825 TGL2938. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Okt. 1997 Geliefert am 06. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or helical baar PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5 to 10 bury street (inclusive) l/b of city of london t/no NGL297979. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 04. Nov. 1993 Geliefert am 06. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from helical bar PLC to the chargee under the terms of the facility letter (as defined) | |
Kurze Angaben All that area or piece of ground lying to the north of carse road inverness part of telford street retail park inverness. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Nov. 1993 Geliefert am 05. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee dated 02.11.93 | |
Kurze Angaben Floating charge over all and whole the area of ground lying generally to thw north of carse road inverness part of the telford street retail park inverness. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rental assignation | Erstellt am 29. Okt. 1993 Geliefert am 06. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the rental assignation | |
Kurze Angaben All rents payable under a lease dated 25.10.88 and 25.05.89 and registered in the books of the council and session on 14.06.89 of unit d telford street retail park inverness. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First legal charge | Erstellt am 18. Jan. 1990 Geliefert am 06. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23-6-89 and/or this charge | |
Kurze Angaben Land and premises adjoining marcham road and nuffield way abingdon oxfordshire fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Juli 1989 Geliefert am 08. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23.6.89 and this charge | |
Kurze Angaben Land and premises on the south side of gorseinon road, garngoch west glamorgan title no wa 153997 WA278451 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment for mor details see form 395 ref M135. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 30. Juni 1989 Geliefert am 19. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to security pacific national bank under the terms of a loan agreement dated 23RD june 1989 was registered pursuant to chapter 1, part xii of the companies act 1985, on 19TH july 1989. | |
Kurze Angaben 20, 22 & 24 graham st, and 14 collon st & 26, 28 & 30 (rear) graham st, airdrie see 395 ref: 416C. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 29. Juni 1989 Geliefert am 19. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to security pacific national bank under the terms of a loan agreement dated 23RD june 1989. was registed pursuant to chapter 1, part xii of the companies act 1985, on 19TH july 1989. | |
Kurze Angaben All & whole that plot of ground at bank st, coatbridge in the parish of old monkland & county of lanark extending to fifty six decimal or one hundredth parts of an acre or thereby (for full details see 395 tc ref: M418C). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 29. Juni 1989 Geliefert am 14. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/6/87 (as agent) | |
Kurze Angaben Land & buildings at the junction of anchor lane & west henderson's wynd, dundee angus & land lying to the north of anchor lane. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 29. Juni 1989 Geliefert am 14. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/6/89 (as agent) | |
Kurze Angaben Land & buildings lying on the south west side of newhaven road edinburgh midlothian. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 29. Juni 1989 Geliefert am 14. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/6/89 (as agent) | |
Kurze Angaben Weston house hay street elgin. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First legal charge | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 13. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing £44,540,000 due to the chargee. | |
Kurze Angaben All that land and buildings situate thereon on the east side of faraday close and north west side of marshall road, east sussex eastborne title no esx 128546 by way of fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See doc 395/136/c/2117 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First legal charge | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 11. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £44,540,000 secured on property acquired by helical properties retail l imited | |
Kurze Angaben F/H piece or parcel of land with buildings situate thereon 51, 53, 55, high st., & 10, walkers lane, kettering., Fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment and building materials of all kinds. Please see mort doc M383 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First legal charge | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 11. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £44,540,000 secured on property acquired by helical properties retail limited | |
Kurze Angaben Land k/a 116, crayford rd, bexley, kent title no: p 48787 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment and building materials of all kinds. Please see mort doc M379 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 11. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben Land k/a 47 to 49 high street dortford l/b of kent t/no k 61397 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 11. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben Land & buildings to the west of hexhon road swalwell gateshead tyne & wear t/no ty 80118 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 11. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben F/H land with retail warehouse premises situate at walworth road & nightingale road hitchin herts fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 11. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben Land & buildings k/a the showroom, berkeley court at the junction of scotter road & doncaster road scunthorpe humberside t/no hs 89450 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 11. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben F/H land & premises k/a 558 cowbridge road east cardiff t/no wa 126535 & land & buildings on the east side of alasworth road cardiff fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 11. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben Land & buildings on the southside of porteland road cowgate newcastle upon tyne tyne & wear t/no ty 102313 fixed charge over all moveable plant machineryimplements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1989 Geliefert am 11. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date. | |
Kurze Angaben F/H land & buildings k/a no 6 & 8 aughton street ormskirk fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0