STERLING COLOURS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTERLING COLOURS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02371771
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STERLING COLOURS LIMITED?

    • (2222) /

    Wo befindet sich STERLING COLOURS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Woodend
    Netherley Road
    L35 1QE Tarbock Green
    Merseyside
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STERLING COLOURS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für STERLING COLOURS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    6 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Jan. 2012

    5 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Jan. 2011

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    11 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Juli 2010

    10 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Hms Secretaries Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Vorschlag des Verwalters

    23 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    9 SeitenMG01

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    6 Seiten395

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten88(2)

    legacy

    1 Seiten123

    Beschlüsse

    Resolutions
    18 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Stammkapitals

    RES04
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von STERLING COLOURS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOULGER, Paul
    12 Mill Street
    CH4 7JE Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    12 Mill Street
    CH4 7JE Chester
    Cheshire
    BritishManaging Director20225950004
    GARDINER, Kevin Robert
    Blantyre Gardens
    Cumbernauld
    G68 9NJ Glasgow
    47
    Geschäftsführer
    Blantyre Gardens
    Cumbernauld
    G68 9NJ Glasgow
    47
    ScotlandBritishCompany Director137400340001
    HULSTON, Jeffrey Paul
    16 Far Moss Road
    Blundellsands
    L23 8TQ Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    16 Far Moss Road
    Blundellsands
    L23 8TQ Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishBusiness Director25163700003
    SOMERVILLE, Hamish
    Ottawa Avenue
    V7V 2S6 West Vancouver
    2260
    Bc
    Canada
    Geschäftsführer
    Ottawa Avenue
    V7V 2S6 West Vancouver
    2260
    Bc
    Canada
    CanadaBritishCompany Director37377750003
    SOMERVILLE, Nicholas
    52 Hillview Road
    EH12 8QQ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    52 Hillview Road
    EH12 8QQ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director75771340002
    HELSBY, Mark
    28 Chillington Avenue
    WA8 8BP Widnes
    Cheshire
    Sekretär
    28 Chillington Avenue
    WA8 8BP Widnes
    Cheshire
    British20225940001
    HOARE, Tracy
    3 Stonechat Close
    Netherley
    L27 6WE Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    3 Stonechat Close
    Netherley
    L27 6WE Liverpool
    Merseyside
    BritishFinancial Manager109591790001
    HURST, Peter
    80 Gledhow Lane
    LS8 1NJ Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    80 Gledhow Lane
    LS8 1NJ Leeds
    West Yorkshire
    British34665630002
    MUSKETT, Neil Philip
    7 Maes Celyn
    Llanbedr Dyffryn Clwyd
    LL15 1YR Ruthin
    Clwyd
    Sekretär
    7 Maes Celyn
    Llanbedr Dyffryn Clwyd
    LL15 1YR Ruthin
    Clwyd
    BritishTechnical Director34665640002
    SHILLITO, Raymond Harvey
    75 Spelding Drive
    Standish Lower Ground
    WN6 8LW Wigan
    Lancashire
    Sekretär
    75 Spelding Drive
    Standish Lower Ground
    WN6 8LW Wigan
    Lancashire
    BritishFinancial Director73136330001
    HMS SECRETARIES LIMITED
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    900004320001
    HELSBY, Mark
    28 Chillington Avenue
    WA8 8BP Widnes
    Cheshire
    Geschäftsführer
    28 Chillington Avenue
    WA8 8BP Widnes
    Cheshire
    BritishProduction Manager20225940001
    HURST, Peter
    80 Gledhow Lane
    LS8 1NJ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    80 Gledhow Lane
    LS8 1NJ Leeds
    West Yorkshire
    BritishTechnical Sales Director34665630002
    MUSKETT, Neil Philip
    7 Maes Celyn
    Llanbedr Dyffryn Clwyd
    LL15 1YR Ruthin
    Clwyd
    Geschäftsführer
    7 Maes Celyn
    Llanbedr Dyffryn Clwyd
    LL15 1YR Ruthin
    Clwyd
    BritishTechnical Director34665640002
    SHILLITO, Raymond Harvey
    75 Spelding Drive
    Standish Lower Ground
    WN6 8LW Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    75 Spelding Drive
    Standish Lower Ground
    WN6 8LW Wigan
    Lancashire
    BritishFinancial Director73136330001

    Hat STERLING COLOURS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 23. Dez. 2009
    Geliefert am 29. Dez. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pergola International Holdings Corporation
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 29. Apr. 2009
    Geliefert am 08. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cattles Invoice Finance LTD
    Transaktionen
    • 08. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 26. März 2009
    Geliefert am 07. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H and l/h property being the land and buildings k/a woodend, netherley road, tarbock green, prescot, merseyside fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including uncalled capital, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sinkro UK Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2005
    Geliefert am 05. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 2004
    Geliefert am 07. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Woodend netherley road tarbock green merseyside.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment (Small Firms) Fund No. 3
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Juli 2003
    Geliefert am 14. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Berechtigte Personen
    • Euro Sales Finance PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 01. Feb. 2001
    Geliefert am 07. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First fixed charge
    Erstellt am 03. Mai 1995
    Geliefert am 05. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    First fixed charge on book and other debts and the proceeds thereof as are not sold to and bought by the chargee under the terms of an agreement dated 3 may 1995. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transaktionen
    • 05. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 10. Mai 1989
    Geliefert am 26. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge on all undertaking and all property and assets present and future including book and other debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 11. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat STERLING COLOURS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Jan. 2011Ende der Verwaltung
    20. Jan. 2010Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Derek Forsyth
    Campbell Dallas
    Sherwood House
    PA1 3QS 7 Glasgow Road
    Paisley
    Praktiker
    Campbell Dallas
    Sherwood House
    PA1 3QS 7 Glasgow Road
    Paisley
    David Hunter
    Campbell Dallas
    Sherwood House
    PA1 3QS 7 Glasgow Road
    Paisley
    Praktiker
    Campbell Dallas
    Sherwood House
    PA1 3QS 7 Glasgow Road
    Paisley
    2
    DatumTyp
    03. Juli 2013Aufgelöst am
    20. Jan. 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Derek Murray Law Forsyth
    Sherwood House, 7 Glasgow Road
    PA4 8WF Paisley
    Praktiker
    Sherwood House, 7 Glasgow Road
    PA4 8WF Paisley

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0