BLITZ VISION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BLITZ VISION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02372013 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BLITZ VISION LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich BLITZ VISION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Deloitte Llp 1 City Square LS1 2AL Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BLITZ VISION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ROBAWN LIMITED | 13. Apr. 1989 | 13. Apr. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLITZ VISION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BLITZ VISION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Rsm Uk Central Square, Fifth Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL England zum Rsm Uk Central Square, Fifth Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA England zum Deloitte Llp 1 City Square Leeds LS1 2AL am 23. Jan. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jason Popp als Geschäftsführer am 20. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Stewart als Sekretär am 09. Jan. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Paul Mckenna Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA zum Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA am 09. Jan. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jason Popp als Direktor am 09. Jan. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas John Marshall als Geschäftsführer am 09. Jan. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Mckenna als Sekretär am 09. Jan. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BLITZ VISION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEWART, Michael | Sekretär | 1 City Square LS1 2AL Leeds Deloitte Llp | 254077040001 | |||||||
| INGERSOLL, Ellen Marie | Geschäftsführer | 1 City Square LS1 2AL Leeds Deloitte Llp | United States | American | 118864140001 | |||||
| MOSTER, Steven | Geschäftsführer | 1 City Square LS1 2AL Leeds Deloitte Llp | United States | American | 193607710001 | |||||
| BREEN, Michael John | Sekretär | 47 Wieland Road HA6 3QX Northwood Middlesex | English | 8442840002 | ||||||
| COOK, Russell John | Sekretär | 26 Egmont Road KT6 7AT Surbiton Surrey | British | 64676640001 | ||||||
| DAVIES, Digby John | Sekretär | 1a Cambridge Road TW1 2HN Twickenham Middlesex | British | 38937270002 | ||||||
| DAY, Christopher Alexander Coryton | Sekretär | 48 Whitley Court Road Quinton B32 1EY Birmingham West Midlands | British | 92047820001 | ||||||
| GORDON, Neil Arthur | Sekretär | Stable Cottage, Burrows Lea Hook Lane, Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | British | 73989530001 | ||||||
| MAKANJI, Ashok | Sekretär | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | 191997100001 | |||||||
| MAKANJI, Ashok | Sekretär | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | British | 120367360001 | ||||||
| MCKENNA, Paul | Sekretär | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | 193460210001 | |||||||
| PARDEN, Susannah Mary Louise | Sekretär | 87 Sutton Court Chiswick W4 3JF London | British | 75930520001 | ||||||
| PATEL, Daxshaben | Sekretär | 2 Millers Court Vicars Bridge Close HA0 1XG Alperton Middlesex | British | 96045520001 | ||||||
| WAKELEY, David Peacefull | Sekretär | 166 Rosemary Hill Road B74 4HN Sutton Coldfield West Midlands | British | 86839080001 | ||||||
| BEDDOW, Charles Edward Kenneth | Geschäftsführer | Manor Road MK45 4NU Barton Le Clay 163 Bedfordshire | United Kingdom | British | 132281430001 | |||||
| BEDDOW, Charles Edward Kenneth | Geschäftsführer | Manor Road MK45 4NU Barton Le Clay 163 Bedfordshire | United Kingdom | British | 132281430001 | |||||
| BREEN, Michael John | Geschäftsführer | 47 Wieland Road HA6 3QX Northwood Middlesex | England | English | 8442840002 | |||||
| BREEN, Michael John | Geschäftsführer | 47 Wieland Road HA6 3QX Northwood Middlesex | England | English | 8442840002 | |||||
| BURTON, Peter | Geschäftsführer | The Old School Sandridgebury AL3 6JB St Albans | United Kingdom | British | 1753870005 | |||||
| DAVIES, Digby John | Geschäftsführer | 1a Cambridge Road TW1 2HN Twickenham Middlesex | British | 38937270002 | ||||||
| DAY, Barry David | Geschäftsführer | The Old Rectory Hatton Green Hatton CV35 7LA Warwick Warwickshire | England | British | 57937960001 | |||||
| DYKSTRA, Paul Brian | Geschäftsführer | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | Usa | American | 118864330001 | |||||
| ELLIS, Robert Keith | Geschäftsführer | 55 Bushy Park Road TW11 9DQ Teddington Middlesex | England | British | 45171010001 | |||||
| ELLIS, Robert Keith | Geschäftsführer | 55 Bushy Park Road TW11 9DQ Teddington Middlesex | England | British | 45171010001 | |||||
| FRASER, Donald | Geschäftsführer | Beechwood 4 Dower Close Knotty Green HP9 1XL Beaconsfield Buckinghamshire | British | 60234160001 | ||||||
| GORDON, Neil Arthur | Geschäftsführer | Stable Cottage, Burrows Lea Hook Lane, Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | England | British | 73989530001 | |||||
| HUTTON, Paul William Peter | Geschäftsführer | 68 Allandale Crescent EN6 2JZ Potters Bar Hertfordshire | British | 37588540001 | ||||||
| JURELLER, John Michael | Geschäftsführer | 150 Brite Avenue Scarsdale Westchester New York 10583 Usa | Usa | American | 150101410001 | |||||
| MAKANJI, Ashok | Geschäftsführer | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | United Kingdom | British | 120367360001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas John | Geschäftsführer | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | England | British | 20708530004 | |||||
| MARSHALL, Nicholas John | Geschäftsführer | Spring House Fieldgate Lawn, Fieldgate Lane CV8 1BT Kenilworth Warwickshire | England | British | 20708530004 | |||||
| POPP, Jason | Geschäftsführer | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry Ges England | United States | American | 254059920001 | |||||
| SAMJI, Munir Akberali | Geschäftsführer | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | United Kingdom | United Kingdom | 119498620001 | |||||
| SUTTON, Peter Howard | Geschäftsführer | 109 Pembroke Road Muswell Hill N10 2JE London | British | 61149380001 | ||||||
| VENT, Richard H | Geschäftsführer | 93 Tahoe Boulevard Suite 802-318 Incline Village 89451 Nevada Usa | American | 55991280001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BLITZ VISION LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viad Corp | 06. Apr. 2017 | 1850 N. Central Avenue Suite 1900 Phoenix Viad Corp Arizona 85004-4565 United States | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat BLITZ VISION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture between (1) the chargor (the company) and (2) national westminster bank PLC (the security trustee) as agent and trustee for the secured parties (as defined) | Erstellt am 08. Mai 2000 Geliefert am 16. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the chargor to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined) including the debenture | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Juli 1998 Geliefert am 11. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to all or any of the financing documents including the guarantee and debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Mai 1993 Geliefert am 03. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Legal charge over all moneys from time to time held on any current deposit and/or other account at the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 19. Juni 1991 Geliefert am 10. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 19. Juni 1991 Geliefert am 21. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from simplecover limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charges upon a) the stock in trade, work-in-progress, pre-payments investments quoted on a recognised stock exchange and cash of the company both present and future b) all other the undertaking and all other property and assets of the company c) any property and assets of company both present and future not charged by way of fixed charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 12. Sept. 1990 Geliefert am 15. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Charge over funds held on deposit on a designated account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Feb. 1990 Geliefert am 10. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Legal charge over credit balances. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 09. Aug. 1989 Geliefert am 12. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BLITZ VISION LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0