RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02380110 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
- Rundfunk (60100) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juli 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. Okt. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 11 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juli 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Deidre Ann Ford als Direktor am 27. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Charles Gill als Geschäftsführer am 27. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Anthony Keenan als Direktor am 27. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Charles Stoddart Longcroft als Geschäftsführer am 27. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Notification of Bauer Radio Limited as a person with significant control on 28. Feb. 2019 | 4 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott William Taunton als Geschäftsführer am 27. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Bauer Group Secretariat Limited als Sekretär am 28. Feb. 2019 | 3 Seiten | AP04 | ||||||||||
Cessation of The Wireless Group (Ilrs) Ltd as a person with significant control on 28. Feb. 2019 | 3 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Änderung des Abrechnungsstichtags | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , 1 London Bridge Street, London, SE1 9GF, England zum Media House Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6EA am 04. Juni 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Sarah Jane Vickery als Direktor am 27. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Juli 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED | Sekretär | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom |
| 159023720001 | ||||||||||
FORD, Deidre Ann | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | Director | 255749500002 | ||||||||
KEENAN, Paul Anthony | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | Director | 39692770004 | ||||||||
VICKERY, Sarah Jane | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 119137220002 | ||||||||
ALLEN, Stephen | Sekretär | 1 Avenue Cottages High Street Mill Hill NW7 1QY London | British | 68299700001 | ||||||||||
ASHTON, Keir | Sekretär | Top Flat 82 Brondesbury Road NW6 6RX London | British | 68400270001 | ||||||||||
BARNETT, Danielle | Sekretär | 33 North Park Drive FY3 8NJ Blackpool Lancashire | British | 9233930001 | ||||||||||
DOWNEY, James Robinson | Sekretär | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | British | Finance Director | 107097580001 | |||||||||
LAWRENCE, Eric Alexander | Sekretär | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | 4250810002 | ||||||||||
SADLER, Keith John | Sekretär | 12 Parrys Grove Stoke Bishop BS9 1TT Bristol Avon | British | 73173100006 | ||||||||||
TOMPKINS, Anthony | Sekretär | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | 165681370001 | |||||||||||
OLSWANG COSEC LIMITED | Sekretär | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 83864780002 | |||||||||||
AIREY, Andrew Simon | Geschäftsführer | 57 North Park Drive FY3 8NH Blackpool Lancashire | England | British | Wine Merchant | 16913450001 | ||||||||
BARNETT, Danielle | Geschäftsführer | 33 North Park Drive FY3 8NJ Blackpool Lancashire | British | Director | 9233930001 | |||||||||
BARNETT MBE DL, John Morris | Geschäftsführer | Broadview 33 North Park Drive FY3 8NJ Blackpool Lancashire | England | British | Director (Managing) | 122413520001 | ||||||||
BATEY, James Derek | Geschäftsführer | Holme Eden 172 St Annes Road East St Annes FY8 3HP Lytham St Annes Lancashire | United Kingdom | British | Director Production Company | 21252100001 | ||||||||
CARR, Anthony David | Geschäftsführer | 3 Braxfield Court St Annes Road West FY8 1LQ Lytham St Annes Lancashire | British | Director Men/Ladies Retail | 13455890003 | |||||||||
DOWNEY, James Robinson | Geschäftsführer | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | United Kingdom | British | Finance Director | 107097580001 | ||||||||
FRIEDLAND, Sidney | Geschäftsführer | 53 Broadway SK8 1LB Cheadle Cheshire | British | Commercial Banker | 28444360001 | |||||||||
GILL, Michael Charles | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 123013340001 | ||||||||
GOODWIN, Jonathan Philip Pryce | Geschäftsführer | 29 Broadhinton Road SW4 0LT London | British | Managing Director | 68743940001 | |||||||||
JOSEPHS, John Irving | Geschäftsführer | 22 Osbaldeston Gardens NE3 4JE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | Company Director | 3830990001 | ||||||||
LAWRENCE, Eric Alexander | Geschäftsführer | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | Finance Director | 4250810002 | |||||||||
LEE, Matthew Everett | Geschäftsführer | 2 East Mead KY3 9LN Blackpool Lancashire | United Kingdom | British | Publisher | 97863000001 | ||||||||
LEE, Samuel George | Geschäftsführer | 7 St Clements Avenue FY3 8LT Blackpool Lancashire | British | Solicitor/Hm Coroner | 19009470001 | |||||||||
LONGCROFT, Christopher Charles Stoddart | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | Chief Financial Officer | 163116880001 | ||||||||
MACKENZIE, Ashley Calder | Geschäftsführer | 6 Springshaw Close TN13 2QE Sevenoaks Kent | British | Director Radio Executive | 59529980005 | |||||||||
MACKENZIE, Kelvin Calder | Geschäftsführer | Christophers Lockstone Close KT13 8EF Weybridge Surrey | United Kingdom | British | Director Chief Executive | 141795340001 | ||||||||
MCCANN, John | Geschäftsführer | 175 Malone Road BT9 6TB Belfast County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | British | Managing Director | 75447990001 | ||||||||
MCKEOWN, Norman | Geschäftsführer | Ormeau Road BT7 1EB Belfast Havelock House Northern Ireland | Northern Ireland | British | Director | 165664890001 | ||||||||
OWEN, Glyn David | Geschäftsführer | 10 Woodside Drive CW11 0JP Sandbach Cheshire | British | Managing Director | 26534930001 | |||||||||
SADLER, Keith John | Geschäftsführer | 12 Parrys Grove Stoke Bishop BS9 1TT Bristol Avon | British | Accountant | 73173100006 | |||||||||
TAUNTON, Scott William | Geschäftsführer | London Bridge Street SE1 9GF London 1 United Kingdom | United Kingdom | Australian | Company Director | 80505610007 | ||||||||
TOMPKINS, Anthony David | Geschäftsführer | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | England | British | Finance Director | 165684030001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Radio Limited | 28. Feb. 2019 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
The Wireless Group (Ilrs) Ltd | 06. Apr. 2016 | 401 Faraday Street, Birchwood Park WA3 6GA Warrington Ground Floor England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat RADIOWAVE (BLACKPOOL) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee | Erstellt am 21. Okt. 1999 Geliefert am 03. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All liability crystallised and all other sums due. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 21. Okt. 1999 Geliefert am 03. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 29. Sept. 1999 Geliefert am 20. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever save for those liabilities specifically excluded by the terms of a letter executed as a deed by the companies and the bank | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Feb. 1998 Geliefert am 21. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0